CASTORS INTERNATIONAL LIMITED

CASTORS INTERNATIONAL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCASTORS INTERNATIONAL LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02879952
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CASTORS INTERNATIONAL LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra CASTORS INTERNATIONAL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CASTORS INTERNATIONAL LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    THE CASTOR COMPANY LIMITED07 abr 199407 abr 1994
    LEBEN LIMITED13 dic 199313 dic 1993

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CASTORS INTERNATIONAL LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CASTORS INTERNATIONAL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    12 páginasLIQ14

    Destitución del liquidador por orden judicial

    13 páginasLIQ10

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 02 ene 2020

    15 páginasLIQ03

    Presentación de insolvencia

    Insolvency:form LIQ12 - secretary of state's release
    3 páginasLIQ MISC

    Destitución del liquidador por orden judicial

    11 páginasLIQ10

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 02 ene 2019

    22 páginasLIQ03

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    4 páginas600

    Informe de progreso del administrador

    30 páginasAM10

    Aviso de cambio de la administración a la liquidación voluntaria de acreedores

    31 páginasAM22

    Informe de progreso del administrador

    28 páginasAM10

    Resultado de la reunión de acreedores

    1 páginas2.23B

    Declaración de asuntos con el formulario 2.14B

    9 páginas2.16B

    Declaración de la propuesta del administrador

    39 páginas2.17B

    Domicilio social registrado cambiado de Colson Castors Ltd Bagnall Street Golds Hill West Bromwich West Midlands B70 0TS a 4 Hardman Square Spininningfields Manchester M3 3EB el 16 ene 2017

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un administrador

    1 páginas2.12B

    Cese del nombramiento de Richard William White como director el 18 abr 2016

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 028799520006

    1 páginasMR04

    Déclaration annuelle établie au 31 ene 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital22 feb 2016

    Estado de capital el 22 feb 2016

    • Capital: GBP 17,661,062.4
    SH01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2014

    29 páginasAA

    Cese del nombramiento de John Hinds como director el 01 may 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Derrick James Towell como director el 01 may 2015

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 31 ene 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital27 feb 2015

    Estado de capital el 27 feb 2015

    • Capital: GBP 17,661,062.4
    SH01

    Déclaration annuelle établie au 13 dic 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital16 dic 2014

    Estado de capital el 16 dic 2014

    • Capital: GBP 17,661,062.4
    SH01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2013

    28 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de CASTORS INTERNATIONAL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SMITHIES, John Andrew
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Secretario
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    190475840001
    BLASHILL, Thomas William
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Director
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    United StatesAmerican181117260001
    SMITHIES, John Andrew
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Director
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    EnglandBritish153425220003
    ALLEN, Paul David
    Blakenall Lane
    Leamore
    WS31HH Walsall
    70
    West Midlands
    United Kingdom
    Secretario
    Blakenall Lane
    Leamore
    WS31HH Walsall
    70
    West Midlands
    United Kingdom
    British129651850001
    BALDWIN, Robert Michael
    19 Woodlands Avenue
    WS5 3LN Walsall
    West Midlands
    Secretario
    19 Woodlands Avenue
    WS5 3LN Walsall
    West Midlands
    English35556690001
    DODDS, Caroline
    Harperley
    Penn Lane Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    West Midlands
    Secretario
    Harperley
    Penn Lane Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    West Midlands
    British51615270002
    PRENTICE, Hamish Murray
    12 Rose Gate
    Aglionby
    CA4 8AJ Carlisle
    Cumbria
    Secretario
    12 Rose Gate
    Aglionby
    CA4 8AJ Carlisle
    Cumbria
    British23060180001
    TOWELL, Derrick James
    110 Kineton Green Road
    B92 7EE Solihull
    West Midlands
    Secretario
    110 Kineton Green Road
    B92 7EE Solihull
    West Midlands
    British107375020001
    TUCKER, Louhon
    1161 Johnson Street
    Naperville 60540
    Illinois
    Usa
    Secretario
    1161 Johnson Street
    Naperville 60540
    Illinois
    Usa
    American98409710001
    WEBB, Karl
    28 Rumbush Lane
    Dickens Heath
    B90 1RA Solihull
    Secretario
    28 Rumbush Lane
    Dickens Heath
    B90 1RA Solihull
    British83233170002
    CMH SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    Secretario designado corporativo
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    900000940001
    ALLEN, Paul David
    Blakenall Lane
    Leamore
    WS31HH Walsall
    70
    West Midlands
    United Kingdom
    Director
    Blakenall Lane
    Leamore
    WS31HH Walsall
    70
    West Midlands
    United Kingdom
    British129651850001
    BALDWIN, Robert Michael
    19 Woodlands Avenue
    WS5 3LN Walsall
    West Midlands
    Director
    19 Woodlands Avenue
    WS5 3LN Walsall
    West Midlands
    EnglandEnglish35556690001
    CHAHALIS, Scott Christian
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    Director
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    UsaUnited States157829560001
    COWHIG, Timothy Joseph
    45 Carbery Avenue
    BH6 3LN Bournemouth
    Dorset
    Director
    45 Carbery Avenue
    BH6 3LN Bournemouth
    Dorset
    British111232550001
    DAVIES, John Bernard
    22 Meadowside
    Ashford
    EX31 4BS Barnstaple
    Devon
    Director
    22 Meadowside
    Ashford
    EX31 4BS Barnstaple
    Devon
    British2874530001
    DAVIES, John Roger
    8 The Grange
    Kings Bromley
    DE13 7HT Burton On Trent
    Staffordshire
    Director
    8 The Grange
    Kings Bromley
    DE13 7HT Burton On Trent
    Staffordshire
    British29214160002
    DODDS, Caroline
    Harperley
    Penn Lane Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    West Midlands
    Director
    Harperley
    Penn Lane Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish51615270002
    HINDS, John
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    Director
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    UsaAmerican185679720001
    LILLY, Robert
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    Director
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    EnglandBritish97998580001
    LILLY, Robert
    28 Doran Close
    B63 1JZ Halesowen
    West Midlands
    Director
    28 Doran Close
    B63 1JZ Halesowen
    West Midlands
    EnglandBritish97998580001
    PRENTICE, Hamish Murray
    12 Rose Gate
    Aglionby
    CA4 8AJ Carlisle
    Cumbria
    Director
    12 Rose Gate
    Aglionby
    CA4 8AJ Carlisle
    Cumbria
    British23060180001
    PRITZKER, Robert Alan
    1n Franklin Ste 2420
    FOREIGN Chicago
    Illinois 60606
    Usa
    Director
    1n Franklin Ste 2420
    FOREIGN Chicago
    Illinois 60606
    Usa
    United StatesAmerican47230840001
    ROGERS, John Leonard
    The Old House
    The Square
    NN6 9SD Hannington
    Northamptonshire
    Director
    The Old House
    The Square
    NN6 9SD Hannington
    Northamptonshire
    United KingdomBritish19597130001
    SANKEY, David Baldwin
    Innage House
    TF11 9AB Shifnal
    Shropshire
    Director
    Innage House
    TF11 9AB Shifnal
    Shropshire
    United KingdomBritish6346070001
    SHIPLEY, Robert
    The Cottage Chapel Lane
    Ombersley
    WR9 0DT Worcester
    Director
    The Cottage Chapel Lane
    Ombersley
    WR9 0DT Worcester
    British43762210001
    SMITH, Christopher Joseph
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    Director
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    UsaAmerican157830370001
    TOWELL, Derrick James
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    Director
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish107375020001
    TUCKER, Louhon
    1161 Johnson Street
    Naperville 60540
    Illinois
    Usa
    Director
    1161 Johnson Street
    Naperville 60540
    Illinois
    Usa
    United StatesAmerican98409710001
    VRESICS, John J
    22 Riderwood Road
    Barrington
    Illinois 60010
    Usa
    Director
    22 Riderwood Road
    Barrington
    Illinois 60010
    Usa
    United StatesUsa152264500001
    WEBB, Karl
    28 Rumbush Lane
    Dickens Heath
    B90 1RA Solihull
    Director
    28 Rumbush Lane
    Dickens Heath
    B90 1RA Solihull
    British83233170002
    WHITE, Richard William
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    Director
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    EnglandBritish184103760001
    CMH DIRECTORS LIMITED
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    Director designado corporativo
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    900000930001
    CMH SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    Director designado corporativo
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    900000940001

    ¿Tiene CASTORS INTERNATIONAL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 07 ago 2014
    Entregado el 13 ago 2014
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 13 ago 2014Registro de una carga (MR01)
    • 06 jun 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Letter of charge
    Creado el 03 oct 1995
    Entregado el 07 oct 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from global castors limited and/or british castors limited and/or J.B.D.plastics limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All monies at any time to the credit of any accounts in the books of the bank.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 07 oct 1995Registro de un cargo (395)
    • 21 nov 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 02 nov 1994
    Entregado el 18 nov 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of assignment the keyman life assurance policy issued by general accident life assurance limited numbered 2679598LY on the life of john roger davies in the sum of £500,000 and all monies including bonuses benefits and other advantages which are payable or accrue thereunder.
    Personas con derecho
    • The British Linen Bank Limited
    Transacciones
    • 18 nov 1994Registro de un cargo (395)
    • 21 nov 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Letter of charge
    Creado el 25 abr 1994
    Entregado el 29 abr 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from british castors limited and/or global castors limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All monies nor or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 29 abr 1994Registro de un cargo (395)
    • 21 nov 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 22 abr 1994
    Entregado el 03 may 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The British Linen Bank Limited
    Transacciones
    • 03 may 1994Registro de un cargo (395)
    • 21 nov 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Single debenture
    Creado el 22 abr 1994
    Entregado el 28 abr 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Stone Investments (Number 2) Limited
    Transacciones
    • 28 abr 1994Registro de un cargo (395)
    • 21 nov 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene CASTORS INTERNATIONAL LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    29 dic 2016Inicio de la administración
    03 ene 2018Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Jason Bell
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Profesional
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Edward Williams
    Grant Thornton Uk Llp Colmore Building
    Colmore Circus
    B4 6AT Birmingham
    Profesional
    Grant Thornton Uk Llp Colmore Building
    Colmore Circus
    B4 6AT Birmingham
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Profesional
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    2
    FechaTipo
    03 ene 2018Inicio de la liquidación
    12 abr 2021Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Edward Williams
    Grant Thornton Uk Llp Colmore Building
    Colmore Circus
    B4 6AT Birmingham
    Profesional
    Grant Thornton Uk Llp Colmore Building
    Colmore Circus
    B4 6AT Birmingham
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Profesional
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Jason Bell
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Profesional
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0