JISC SERVICES LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | JISC SERVICES LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
Número de empresa | 02881024 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | No |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de JISC SERVICES LIMITED?
- Otras actividades de telecomunicaciones (61900) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra JISC SERVICES LIMITED?
Dirección de la sede social | 4 Portwall Lane BS1 6NB Bristol England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de JISC SERVICES LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
JISC COLLECTIONS AND JANET LIMITED | 05 dic 2012 | 05 dic 2012 |
THE JNT ASSOCIATION | 10 dic 1993 | 10 dic 1993 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de JISC SERVICES LIMITED?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 jul 2025 |
Próximas cuentas vencen el | 30 abr 2026 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 jul 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para JISC SERVICES LIMITED?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 10 dic 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 24 dic 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 10 dic 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para JISC SERVICES LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 10 dic 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2024 | 33 páginas | AA | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2023 | 32 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 dic 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 dic 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2022 | 36 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Stephen Douglas Kennett como director el 01 oct 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2021 | 33 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 dic 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mrs Heidi Michele Fraser-Krauss como director el 16 sept 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Paul Barrie Feldman como director el 16 sept 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2020 | 37 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 dic 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Robert Roy Haymon-Collins como director el 06 nov 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Philip Richards como director el 12 may 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Ms Nicola Jane Arnold como director el 29 ene 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2019 | 33 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 dic 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de C/O Jisc One Castlepark Tower Hill Bristol BS2 0JA England a 4 Portwall Lane Bristol BS1 6NB | 1 páginas | AD02 | ||
Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado 4 Portwall Lane Bristol BS1 6NB | 1 páginas | AD04 | ||
Domicilio social registrado cambiado de One Castlepark Tower Hill Bristol BS2 0JA a 4 Portwall Lane Bristol BS1 6NB el 02 dic 2019 | 1 páginas | AD01 | ||
Nombramiento de Mr Stephen Douglas Kennett como director el 23 oct 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Timothy Kidd como director el 25 jul 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Mark Anthony Wright como director el 30 jun 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2018 | 34 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de JISC SERVICES LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLBAN, Alice Jane | Secretario | Portwall Lane BS1 6NB Bristol 4 England | 184850510001 | |||||||
ARNOLD, Nicola Jane | Director | Portwall Lane BS1 6NB Bristol 4 England | England | British | Accountant | 170740660001 | ||||
COLBAN, Alice Jane | Director | Portwall Lane BS1 6NB Bristol 4 England | England | British | Chief Operating Officer And Deputy Chief Executive | 196261320001 | ||||
FRASER-KRAUSS, Heidi Michele | Director | Portwall Lane BS1 6NB Bristol 4 England | United Kingdom | British, | Chief Executive | 183731710001 | ||||
BRANSTON, Paul Richard | Secretario | 20 Kings Road TW1 2QS Twickenham | British | Finance Director | 48880840002 | |||||
BREAKS, Michael Lenox | Secretario | 2 Corrennie Gardens EH10 6DG Edinburgh Midlothian | British | University Librarian | 63803680001 | |||||
MCGILL, Ian David | Secretario | 4 Gilbard Court Chineham RG24 8RG Basingstoke Hampshire | British | Company Secretary | 11839950001 | |||||
RICHARDSON, Daff | Secretario | Flat 1 Otley House 36 High Street OX20 1TG Woodstock Oxfordshire | British | 52355670001 | ||||||
TAYLOR, Andrew Nigel | Secretario | Library Avenue, Harwell Oxford OX11 0SG Didcot Lumen House Oxon England | 156199870001 | |||||||
WRIGHT, Mark Anthony | Secretario | Library Avenue, Harwell Oxford OX11 0SG Didcot Lumen House Oxon England | 172248200001 | |||||||
AITKEN, Stuart Christie, Dr | Director | 113 Hindes Road HA1 1RS Harrow Middlesex | England | British | I T Executive | 111980510001 | ||||
ANDREWS, Geoffrey Neil | Director | Lon Cae Glas Llanbedr D C LL15 1US Ruthin Brackendene Denbighshire | Wales | British | Director | 69349930003 | ||||
ARAK, Robin Graeme, Dr | Director | 36 Roedean Crescent BN2 5RH Brighton East Sussex | British | Chief Executive | 26967250003 | |||||
ARBUTHNOTT, John | Director | The Old Rectory Llangynhafal LL16 4LN Denbigh Clwyd Wales | British | Consultant | 37092290003 | |||||
BAIN, Malcolm, Dr | Director | 4 Leonard Gardens KY16 8RD St Andrews Fife | Scotland | British | It Director | 182464150001 | ||||
BAKER, Robin Richard Sebastian, Professor | Director | Library Avenue, Harwell Oxford OX11 0SG Didcot Lumen House Oxon England | England | British | Director And Chief Executive | 174359800001 | ||||
BRANSTON, Paul Richard | Director | 20 Kings Road TW1 2QS Twickenham | England | British | Finance Director | 48880840002 | ||||
BREAKS, Michael Lenox | Director | 2 Corrennie Gardens EH10 6DG Edinburgh Midlothian | British | University Librarian | 63803680001 | |||||
BRINK, Chris Hendrik, Professor | Director | Library Avenue, Harwell Oxford OX11 0SG Didcot Lumen House Oxon | United Kingdom | British, South African, Australian | Vice-Chancellor | 133098830004 | ||||
BURROWS, David Stuart | Director | Green Lane RG9 1LS Henley On Thames Hurst Oxfordshire | United Kingdom | British | General Mgr Software | 72884880004 | ||||
CLARK, Mark John, Professor | Director | 38 Beech Crescent SK12 1AP Poynton Cheshire | British | It Director | 60501120001 | |||||
DART, Neville | Director | Library Avenue, Harwell Oxford OX11 0SG Didcot Lumen House Oxon England | England | British | It Manager | 148772980001 | ||||
DAVIES, Brian Watson | Director | 36 Barleyfields OX11 0BJ Didcot Oxfordshire England | British | Associate Director | 37092280001 | |||||
DAY, Robert Anthony, Dr | Director | 11 Goldwell Drive RG14 1HZ Newbury Berkshire | United Kingdom | British | Director | 98194080001 | ||||
DEMPSTER, Brent | Director | Library Avenue, Harwell Oxford OX11 0SG Didcot Lumen House Oxon England | United Kingdom | British | Hr Proffessional | 166481220001 | ||||
ESTELLE, Lorraine | Director | c/o Jisc Collections Lancaster Place WC2E 7EN London Brettenham House England | England | Bristish | Chief Executive Officer | 117901250001 | ||||
FELDMAN, Paul Barrie, Dr | Director | Portwall Lane BS1 6NB Bristol 4 England | England | British | Chief Executive | 202040200001 | ||||
FIELD, George Richard | Director | 76/5 Mortonhall Park Crescent EH17 8SX Edinburgh | British | University Teacher | 48424710002 | |||||
FORD, Brian, Doctor | Director | Ramsden Farm House High Street OX7 3AU Ramsden Oxfordshire | British | Managing Director | 81667980001 | |||||
GILLAM, Roger John | Director | Library Avenue, Harwell Oxford OX11 0SG Didcot Lumen House Oxon England | United Kingdom | British | Rcuk Executive Group Rep | 80314460001 | ||||
GILLAM, Roger John | Director | Willard House Garford OX13 5PF Abingdon Oxfordshire | United Kingdom | British | Director | 80314460001 | ||||
GILMORE, Brian | Director | Library Avenue, Harwell Oxford OX11 0SG Didcot Lumen House Oxon England | Scotland | British | Computer Professional | 148771630001 | ||||
GRIFFITHS, Ian David | Director | 67 Mansfield Road Papplewick NG15 8FJ Nottingham Nottinghamshire | England | British | It Director | 81074350001 | ||||
GUMMETT, Philip, Professor | Director | Tower Hill BS2 0JA Bristol One Castlepark England | England | British | Retired | 181494460001 | ||||
HALL, Martin John, Professor | Director | Tower Hill BS2 0JA Bristol One Castlepark England | United Kingdom | British | Vice Chancellor | 149469260001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de JISC SERVICES LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jisc | 06 abr 2016 | Tower Hill BS2 0JA Bristol One Castlepark England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0