338 EUSTON ROAD LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | 338 EUSTON ROAD LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02884931 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | No |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de 338 EUSTON ROAD LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra 338 EUSTON ROAD LIMITED?
Dirección de la sede social | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de 338 EUSTON ROAD LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
NALDO LIMITED | 06 ene 1994 | 06 ene 1994 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de 338 EUSTON ROAD LIMITED?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2025 |
Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para 338 EUSTON ROAD LIMITED?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 06 ene 2026 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 20 ene 2026 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 06 ene 2025 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para 338 EUSTON ROAD LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 06 ene 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2024 | 24 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Catherine Fiona Sayers como director el 22 ene 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 06 ene 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Keith Mcclure como director el 22 dic 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Nick Taunt como director el 22 dic 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Miss Catherine Fiona Sayers como director el 17 nov 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 23 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Nigel Mark Webb como director el 30 jun 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 06 ene 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2022 | 22 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Jonathan Charles Mcnuff como director el 18 mar 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Michael John Meadows como director el 16 mar 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Nick Taunt como director el 18 mar 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Gavin Bergin como director el 18 mar 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2021 | 22 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 06 ene 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Notification de Regent's Place Holding 2 Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 jul 2019 | 2 páginas | PSC02 | ||
Cessation de Regent's Place Holding Company Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 jul 2019 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2020 | 23 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 06 ene 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 06 ene 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2019 | 21 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Mr Nigel Mark Webb el 04 jul 2019 | 2 páginas | CH01 | ||
Cese del nombramiento de Timothy Andrew Roberts como director el 31 mar 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de 338 EUSTON ROAD LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Secretario corporativo | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
BARZYCKI, Sarah Morrell | Director | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | Head Of Finance | 58016770004 | ||||||||
BERGIN, Gavin | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 251327820001 | ||||||||
MCCLURE, Keith | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 317380490001 | ||||||||
MCNUFF, Jonathan Charles | Director | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 205624050001 | ||||||||
MEADOWS, Michael John | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Town Planner | 215228040001 | ||||||||
CLARKE, Peter Courtenay | Secretario | Langkawi 2 Ashlea Road SL9 8NY Chalfont St Peter Buckinghamshire | British | 78691990001 | ||||||||||
EKPO, Ndiana | Secretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | Other | 138446320001 | ||||||||||
SCUDAMORE, Rebecca Jane | Secretario | 40 Canbury Avenue KT2 6JP Kingston Upon Thames Surrey | Other | 72249480003 | ||||||||||
COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario designado corporativo | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||||||
BELL, Lucinda Margaret | Director | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | Chartered Accountant | 32809050044 | ||||||||
BERRY, David Charles | Director | Portland Dene Valley Way SL9 7PN Gerrards Cross Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 166550001 | |||||||||
BOWDEN, Robert Edward | Director | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 152497530001 | ||||||||
CARTER, Simon Geoffrey | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Treasury Executive | 170891060001 | ||||||||
CLARKE, Peter Courtenay | Director | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 78691990003 | ||||||||
GROSE, Benjamin Toby | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 146546000001 | ||||||||
HESTER, Stephen Alan Michael | Director | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | Chief Executive | 51688320001 | |||||||||
JONES, Andrew Marc | Director | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | Company Director | 82020730004 | ||||||||
KALMAN, Stephen Lionel | Director | 81 Eastbury Road HA6 3AP Northwood Middlesex | England | British | Chartered Surveyor | 1188110001 | ||||||||
RITBLAT, John, Sir | Director | The Doric Villa 20 York Terrace East Regents Park NW1 4PT London | England | British | Chairman & Md-Brit Land Co Plc | 41694870001 | ||||||||
RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan | Director | 37 Queens Grove NW8 6HN London | United Kingdom | British | Company Director | 35758050004 | ||||||||
ROBERTS, Graham Charles | Director | 6a Lower Belgrave Street SW1W 0LJ London | England | British | Chartered Accountant | 79807180002 | ||||||||
ROBERTS, Timothy Andrew | Director | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | England | British | Chartered Surveyor | 63986410004 | ||||||||
SAYERS, Catherine Fiona | Director | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | Company Secretary | 285600850001 | ||||||||
SMITH, Stephen Paul | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | Company Director | 148183670001 | ||||||||
TAUNT, Nick | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 275050860001 | ||||||||
VANDEVIVERE, Jean-Marc | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | French | Company Director | 170947050001 | ||||||||
WEBB, Nigel Mark | Director | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | Head Of Developments | 58059360001 | ||||||||
WESTON SMITH, John Harry | Director | 10 Eldon Grove Hampstead NW3 5PT London | England | British | Chartered Secretary | 13547380001 | ||||||||
COMBINED NOMINEES LIMITED | Director designado corporativo | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NA London | 900000090001 | |||||||||||
COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Director designado corporativo | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de 338 EUSTON ROAD LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regent's Place Holding 2 Limited | 31 jul 2019 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Regent's Place Holding Company Limited | 06 ene 2017 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0