IOP 02886867 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaIOP 02886867 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02886867
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de IOP 02886867 LIMITED?

    • Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra IOP 02886867 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de IOP 02886867 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PEER FREEHOLDS LIMITED12 ene 199412 ene 1994

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de IOP 02886867 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 jul 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para IOP 02886867 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    11 páginasLIQ13

    Cese del nombramiento de Martin Brendan Birrane como director el 09 jun 2018

    1 páginasTM01

    Cessation de Martin Brendan Birrane en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 jun 2018

    1 páginasPSC07

    Cambio de datos del director Mr James Howard Dawson el 24 ene 2018

    2 páginasCH01

    Domicilio social registrado cambiado de The Peer Suite the Hop Exchange 24 Southwark Street London SE1 1TY a Two Snowhill Birmingham B4 4GA el 22 may 2017

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 27 abr 2017

    LRESSP

    Declaración de confirmación presentada el 02 ene 2017 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name27 oct 2016

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 13 oct 2016

    RES15

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2015

    18 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 12 ene 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital15 ene 2016

    Estado de capital el 15 ene 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cancelación total de la carga 5

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 6

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 7

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 028868670010

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 9

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 8

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 028868670011

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 2

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 3

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 4

    1 páginasMR04

    Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga 1

    2 páginasMR05

    Cancelación total de la carga 1

    2 páginasMR04

    ¿Quiénes son los directivos de IOP 02886867 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BREEZE, Michael David
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    Secretario
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    181173070001
    BIRRANE, Susan Alice
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    Director
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    GibraltarBritish7828640008
    BIRRANE-RULE, Amanda
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    Director
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    United KingdomBritish67689710002
    BREEZE, Michael David
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    Director
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    EnglandBritish184073430001
    DAWSON, Howard James
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    Director
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    EnglandBritish152733740001
    MANDER, Richard Charles
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    Director
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    United KingdomBritish55797010002
    SMITH, Peter James
    5 Maryland Court
    Rainham
    ME8 8QY Gillingham
    Kent
    Secretario
    5 Maryland Court
    Rainham
    ME8 8QY Gillingham
    Kent
    British7736140001
    WALLWORK, Paul Antony Hewitt
    The Peer Suite
    The Hop Exchange
    SE1 1TY 24 Southwark Street
    London
    Secretario
    The Peer Suite
    The Hop Exchange
    SE1 1TY 24 Southwark Street
    London
    174564620001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Secretario designado corporativo
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    BIRRANE, Bridget Kathleen
    The Peer Suite
    The Hop Exchange
    SE1 1TY 24 Southwark Street
    London
    Director
    The Peer Suite
    The Hop Exchange
    SE1 1TY 24 Southwark Street
    London
    EnglandBritish91838040001
    BIRRANE, Martin Brendan
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    Director
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    GibraltarIrish7736150006
    COUCHMAN, Robert Wilfred
    20 Rectory Park
    Sanderstead
    CR2 9JN South Croydon
    Surrey
    Director
    20 Rectory Park
    Sanderstead
    CR2 9JN South Croydon
    Surrey
    EnglandBritish159317370002
    SMITH, Peter James
    5 Maryland Court
    Rainham
    ME8 8QY Gillingham
    Kent
    Director
    5 Maryland Court
    Rainham
    ME8 8QY Gillingham
    Kent
    United KingdomBritish7736140001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Director designado corporativo
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Director designado corporativo
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de IOP 02886867 LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Mr Martin Brendan Birrane
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    06 abr 2016
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    Nacionalidad: Irish
    País de residencia: Gibraltar
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    Peer Group Plc
    The Hop Exchange
    24 Southwark Street
    SE1 1TY London
    The Peer Suite
    United Kingdom
    06 abr 2016
    The Hop Exchange
    24 Southwark Street
    SE1 1TY London
    The Peer Suite
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro1265425
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene IOP 02886867 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 21 abr 2015
    Entregado el 29 abr 2015
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Deutsche Pfandbriefbank Ag
    Transacciones
    • 29 abr 2015Registro de una carga (MR01)
    • 06 oct 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 23 oct 2013
    Entregado el 06 nov 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    The freehold land known as saxon house, sunbury, surrey (registered as SY432619). The freehold land known as centurion house, crewe gates farm industrial estate, crewe, cheshire (registered as CH393677), the freehold land known as paternoster house, brunel way, thetford, norfolk (NK174417) and all properties set out in security previously given by the company in favour of the chargee.
    Deudor actuando como fiduciario desnudo:
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Deutsche Pfandbriefbank Ag
    Transacciones
    • 06 nov 2013Registro de una carga (MR01)
    • 06 oct 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of confirmation
    Creado el 23 oct 2012
    Entregado el 30 oct 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and peer freeholds (newcastle) limited to the fiance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Deutsche Pfandbriefbank Ag as Agent and Security Trustee for the Finance Parties
    Transacciones
    • 30 oct 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 06 oct 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Supplemental debenture
    Creado el 10 jun 2004
    Entregado el 16 jun 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The new property being all the f/h land and buildings k/a 34-40 windsor house, high street, esher t/no SY692349 all gross rental income as such relates to the new property; all guarantees now or in the future of all gross rental income. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hypo Real Estate Bank International, London Branch (The Successor Agent)
    Transacciones
    • 16 jun 2004Registro de un cargo (395)
    • 06 oct 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Supplemental debenture (supplemental to a debenture dated 30 march 2000)
    Creado el 28 oct 2002
    Entregado el 02 nov 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to each finance party on any account whatsoever.
    Breve descripción
    Freehold land 35, 37, 39, 41, 43, 45 and 47 high street and 2, 4, 6, 8 and 10 cromwell road redhill t/n SY475297. By way of assignment all gross rental income, all guarantees now or in the future of all gross rental income, all agreements, policies of insurance and warranties. By way of fixed charge the benefit of all rights and claims, all guarantees, warranties and representations. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hvb Real Estate Capital Limited (The Facilty Agent)
    Transacciones
    • 02 nov 2002Registro de un cargo (395)
    • 06 oct 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Third party charge over shares
    Creado el 23 ago 2001
    Entregado el 01 sept 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to each finance document and of the company to each finance party under or pursuant to the charge over shares
    Breve descripción
    All the company's right title and interest in and to the securities bring all stocks shares bonds and securities of any kind (marketable or otherwise) negotiable instruments and and warrants beneficially owned by the company comprised within the borrower and all interest dividends rights and benefits arising therefrom. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hvb Real Estate Capital Limited (The "Facility Agent")as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transacciones
    • 01 sept 2001Registro de un cargo (395)
    • 06 oct 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Supplemental debenture
    Creado el 11 jul 2000
    Entregado el 18 jul 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All that the property k/a middle entry shopping centre tamworth t/n SF170234 property conveyed by a conveyance dated 25/03/1970 the "new properties" all gross rental income,all guarantees,all agreements policies of insurance and warranties please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hvb Real Estate Capital Limited
    Transacciones
    • 18 jul 2000Registro de un cargo (395)
    • 06 oct 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 30 mar 2000
    Entregado el 11 abr 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hvb Real Estate Capital Limited (As Agent and Trustee for the Finance Parties)
    Transacciones
    • 11 abr 2000Registro de un cargo (395)
    • 28 ago 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Supplemental debenture (supplemental to a debenture dated 30TH july 1996 made between the company and the bank)
    Creado el 01 may 1997
    Entregado el 07 may 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of legal mortgage all estates or interests in mace industrial estate ashford kent t/nos.K253827 and K307368 and unit 10 maesglas retail park newport road newport gwent t/no.WA164510. By way of assignment all gross rental income and all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft (The Bank)
    Transacciones
    • 07 may 1997Registro de un cargo (395)
    • 28 ago 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Supplemental debenture supplemental to a debenture dated 30TH july 1996 and issued by the company
    Creado el 18 nov 1996
    Entregado el 26 nov 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of legal mortgage all estates or interest in the new properties being l/h-land known as pemberton house stafford court telford shropshire t/n-SL90860. F/h-land known as st martin's house hatfield hertfordshire t/n-HD244828. F/h-land known as saxon house sunbury surrey t/n-SY432619. (For the other 4 properties charged see ch microfiche). By way of assignment: all gross rental income insofar as such relates to the new properties and the rights of the company to receive the same;. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bayerische Hypotheken-Und Weschel-Bank Aktiengessellschaft
    Transacciones
    • 26 nov 1996Registro de un cargo (395)
    • 28 ago 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 30 jul 1996
    Entregado el 07 ago 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All indebtedness obligations and liabilities due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bayerische Hypotheken -Und Weschel -Bank Akteingesselshaft
    Transacciones
    • 07 ago 1996Registro de un cargo (395)
    • 29 jul 2015Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    • 29 jul 2015Satisfacción de una carga (MR04)

    ¿Tiene IOP 02886867 LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    27 abr 2017Inicio de la liquidación
    09 nov 2018Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Edward Terence Kerr
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Profesional
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Malcolm Cohen
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Profesional
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0