TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02891007 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 10 Kings Hill Avenue Kings Hill ME19 4LT West Malling Kent United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ATTENTIV SYSTEMS GROUP LIMITED | 18 nov 2005 | 18 nov 2005 |
| ATTENTIV SYSTEMS GROUP PLC | 18 feb 2004 | 18 feb 2004 |
| ATTENTIV SYSTEMS GROUP LIMITED | 14 ene 2004 | 14 ene 2004 |
| LYNX GROUP LIMITED | 06 jun 2002 | 06 jun 2002 |
| LYNX FINANCIAL SYSTEMS (RETAIL BANKING) LIMITED | 13 jul 1998 | 13 jul 1998 |
| QUADRA COMPUTER SERVICES LIMITED | 07 mar 1994 | 07 mar 1994 |
| QUADRA LIMITED | 25 ene 1994 | 25 ene 1994 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2011 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 25 ene 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Janne Kaarlo Salminen el 23 feb 2012 | 4 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Jameson como secretario el 24 feb 2012 | 2 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Richard Jameson como director el 24 feb 2012 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Nigel Anthony Ernest Brown como director el 23 feb 2012 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Ground Floor, the Arenson Centre Arenson Way Houghton Regis Dunstable Bedfordshire LU5 5UL United Kingdom el 24 feb 2012 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 25 ene 2012 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011 | 13 páginas | AA | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010 | 14 páginas | AA | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Ari Peltonen como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Janne Kaarlo Salminen como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 25 ene 2011 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Paul Richard Jameson el 18 feb 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Ari Petteri Peltonen el 18 feb 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del secretario Paul Jameson el 18 feb 2011 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||||||
Estado de capital el 14 ene 2011
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Gainsborough House Houghton Hall Park Houghton Regis Bedfordshire LU5 5XF el 10 may 2010 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009 | 14 páginas | AA | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROWN, Nigel Anthony Ernest | Director | Kings Hill Avenue Kings Hill ME19 4LT West Malling 10 Kent | United Kingdom | British | 64884990001 | |||||
| SALMINEN, Janne Kaarlo | Director | Kings Hill Avenue Kings Hill ME19 4LT West Malling 10 Kent United Kingdom | Finland | Finnish | 161336610001 | |||||
| FAIRCLOUGH, Ian Peter | Secretario | 17 Claremont Road CV31 3EH Leamington Spa Warwickshire | British | 55444950001 | ||||||
| JAMESON, Paul | Secretario | Kings Hill Avenue Kings Hill ME19 4LT West Malling 10 Kent United Kingdom | British | 108959640001 | ||||||
| MILNER, Andrew | Secretario | 12 Park Lane Upper Cumberworth HD8 8NP Huddersfield West Yorkshire | British | 62567380001 | ||||||
| SINNETT, Paul Martin | Secretario | Mill Croft Barn Water Stratford Road MK18 4PD Tingewick | British | 71468530002 | ||||||
| SINNETT, Paul Martin | Secretario | 11 The Woodlands Chesterton OX6 8TN Bicester Oxfordshire | British | 71468530001 | ||||||
| WOOD, Philip Basil | Secretario | Portelet High Street Croydon SG8 0DR Royston Hertfordshire | British | 72282230002 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BERTRAM, Peter Michael | Director | Torrells Pursers Lane Peaslake GU5 9RE Guildford Surrey | England | British | 52852920002 | |||||
| COUZENS, Michael Reginald Joseph | Director | 11 Virginia Drive GU25 4RX Virginia Water Surrey | British | 91121570002 | ||||||
| DOUGLAS MANN, Stewart Charles Hamilton | Director | 17 Queensdale Road W11 4SB London | England | British | 46258180001 | |||||
| FISHER, Linda Jean | Director | 5 Priory Orchard Flamstead AL3 8BU St Albans Hertfordshire | British | 37491520001 | ||||||
| HOLMEN, Knut | Director | Dagalivn. 25b No-0776 Oslo Norway | Norwegian | 129202940001 | ||||||
| HONE, Michael Frank | Director | 3 Coniston Road Dronfield Woodhouse S18 8PY Dronfield Derbyshire | British | 37491510002 | ||||||
| JACKLIN, Ian Charles | Director | 37 Brookhouse Hill Fulwood S10 3TB Sheffield South Yorkshire | England | British | 37491500001 | |||||
| JAMESON, Paul Richard | Director | Kings Hill Avenue Kings Hill ME19 4LT West Malling 10 Kent United Kingdom | England | British | 109810380001 | |||||
| KERNAHAN, Adrian Clive | Director | 10 Medlows AL5 3AY Harpenden Hertfordshire | British | 29600080004 | ||||||
| LAST, Richard | Director | The Leys Farm Banbury Road Great Tew OX7 4DL Chipping Norton Oxfordshire | United Kingdom | British | 80537570001 | |||||
| LINDGREN, Peter | Director | Drakskeppsragen 55 Taby Se-18363 Sweden | Swedish | 106852790001 | ||||||
| LISCOMBE, David Kenneth | Director | Pear Tree Farm Ainsworth Lane Crowton CW8 2RS Northwich Cheshire | British | 6387640001 | ||||||
| LUUPPALA, Harri Pentti Kalervo | Director | Hakatie 15 FOREIGN Tampere Fi-33880 Finland | Finnish | 106853820001 | ||||||
| MILNER, Andrew | Director | 12 Park Lane Upper Cumberworth HD8 8NP Huddersfield West Yorkshire | British | 62567380001 | ||||||
| PELTOLA, Veli Erik | Director | Alberganesplanadi 9a5 FOREIGN Espoo Fi-02600 Finland | Finnish | 106852630001 | ||||||
| PELTONEN, Ari Petteri | Director | Arenson Way Houghton Regis LU5 5UL Dunstable Ground Floor, The Arenson Centre Bedfordshire United Kingdom | Finland | Finnish | 139265650001 | |||||
| SINNETT, Paul Martin | Director | Mill Croft Barn Water Stratford Road MK18 4PD Tingewick | England | British | 71468530002 | |||||
| WEBBER, David Paul, Mr. | Director | 12 Rotten Row Great Brickhill MK17 9BA Milton Keynes Buckinghamshire | British | 47915530002 | ||||||
| WILLIAMS, David | Director | 2 Seven Stiles Drive Marple SK6 6LT Stockport Cheshire | British | 57223140001 | ||||||
| WOOD, Philip Basil | Director | Portelet High Street Croydon SG8 0DR Royston Hertfordshire | England | British | 72282230002 | |||||
| WYETH, David, Dr | Director | 35 Barlings Road AL5 2AW Harpenden Hertfordshire | British | 4060250001 |
¿Tiene TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Accession deed | Creado el 25 jun 2002 Entregado el 03 jul 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to the dnb finance parties and/or the suk finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of assignment of intellectual property rights and floating charge | Creado el 02 mar 1994 Entregado el 08 mar 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed charge upon the trade names "BS5" and "summit" floating charges upon all other the undertaking and all other property and assets of the company both present and future; any property and assets of the company both present and future by way of fixed charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 02 mar 1994 Entregado el 08 mar 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 08 feb 1994 Entregado el 16 feb 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0