TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED

TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02891007
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    10 Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    Kent
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ATTENTIV SYSTEMS GROUP LIMITED18 nov 200518 nov 2005
    ATTENTIV SYSTEMS GROUP PLC18 feb 200418 feb 2004
    ATTENTIV SYSTEMS GROUP LIMITED14 ene 200414 ene 2004
    LYNX GROUP LIMITED06 jun 200206 jun 2002
    LYNX FINANCIAL SYSTEMS (RETAIL BANKING) LIMITED13 jul 199813 jul 1998
    QUADRA COMPUTER SERVICES LIMITED07 mar 199407 mar 1994
    QUADRA LIMITED25 ene 199425 ene 1994

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 25 ene 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital05 feb 2013

    Estado de capital el 05 feb 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Janne Kaarlo Salminen el 23 feb 2012

    4 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Paul Jameson como secretario el 24 feb 2012

    2 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Paul Richard Jameson como director el 24 feb 2012

    2 páginasTM01

    Nombramiento de Nigel Anthony Ernest Brown como director el 23 feb 2012

    3 páginasAP01

    Domicilio social registrado cambiado de Ground Floor, the Arenson Centre Arenson Way Houghton Regis Dunstable Bedfordshire LU5 5UL United Kingdom el 24 feb 2012

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 25 ene 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    13 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    14 páginasAA

    Cese del nombramiento de Ari Peltonen como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Janne Kaarlo Salminen como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 25 ene 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Paul Richard Jameson el 18 feb 2011

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Ari Petteri Peltonen el 18 feb 2011

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Paul Jameson el 18 feb 2011

    1 páginasCH03

    Estado de capital el 14 ene 2011

    • Capital: GBP 100
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    legacy

    1 páginasSH20

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Reduce share prem to nil 07/01/2011
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Domicilio social registrado cambiado de Gainsborough House Houghton Hall Park Houghton Regis Bedfordshire LU5 5XF el 10 may 2010

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    14 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BROWN, Nigel Anthony Ernest
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    10
    Kent
    Director
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    10
    Kent
    United KingdomBritish64884990001
    SALMINEN, Janne Kaarlo
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    10
    Kent
    United Kingdom
    Director
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    10
    Kent
    United Kingdom
    FinlandFinnish161336610001
    FAIRCLOUGH, Ian Peter
    17 Claremont Road
    CV31 3EH Leamington Spa
    Warwickshire
    Secretario
    17 Claremont Road
    CV31 3EH Leamington Spa
    Warwickshire
    British55444950001
    JAMESON, Paul
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    10
    Kent
    United Kingdom
    Secretario
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    10
    Kent
    United Kingdom
    British108959640001
    MILNER, Andrew
    12 Park Lane
    Upper Cumberworth
    HD8 8NP Huddersfield
    West Yorkshire
    Secretario
    12 Park Lane
    Upper Cumberworth
    HD8 8NP Huddersfield
    West Yorkshire
    British62567380001
    SINNETT, Paul Martin
    Mill Croft Barn
    Water Stratford Road
    MK18 4PD Tingewick
    Secretario
    Mill Croft Barn
    Water Stratford Road
    MK18 4PD Tingewick
    British71468530002
    SINNETT, Paul Martin
    11 The Woodlands
    Chesterton
    OX6 8TN Bicester
    Oxfordshire
    Secretario
    11 The Woodlands
    Chesterton
    OX6 8TN Bicester
    Oxfordshire
    British71468530001
    WOOD, Philip Basil
    Portelet
    High Street Croydon
    SG8 0DR Royston
    Hertfordshire
    Secretario
    Portelet
    High Street Croydon
    SG8 0DR Royston
    Hertfordshire
    British72282230002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BERTRAM, Peter Michael
    Torrells Pursers Lane
    Peaslake
    GU5 9RE Guildford
    Surrey
    Director
    Torrells Pursers Lane
    Peaslake
    GU5 9RE Guildford
    Surrey
    EnglandBritish52852920002
    COUZENS, Michael Reginald Joseph
    11 Virginia Drive
    GU25 4RX Virginia Water
    Surrey
    Director
    11 Virginia Drive
    GU25 4RX Virginia Water
    Surrey
    British91121570002
    DOUGLAS MANN, Stewart Charles Hamilton
    17 Queensdale Road
    W11 4SB London
    Director
    17 Queensdale Road
    W11 4SB London
    EnglandBritish46258180001
    FISHER, Linda Jean
    5 Priory Orchard
    Flamstead
    AL3 8BU St Albans
    Hertfordshire
    Director
    5 Priory Orchard
    Flamstead
    AL3 8BU St Albans
    Hertfordshire
    British37491520001
    HOLMEN, Knut
    Dagalivn. 25b
    No-0776 Oslo
    Norway
    Director
    Dagalivn. 25b
    No-0776 Oslo
    Norway
    Norwegian129202940001
    HONE, Michael Frank
    3 Coniston Road
    Dronfield Woodhouse
    S18 8PY Dronfield
    Derbyshire
    Director
    3 Coniston Road
    Dronfield Woodhouse
    S18 8PY Dronfield
    Derbyshire
    British37491510002
    JACKLIN, Ian Charles
    37 Brookhouse Hill
    Fulwood
    S10 3TB Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    37 Brookhouse Hill
    Fulwood
    S10 3TB Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish37491500001
    JAMESON, Paul Richard
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    10
    Kent
    United Kingdom
    Director
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    10
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish109810380001
    KERNAHAN, Adrian Clive
    10 Medlows
    AL5 3AY Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    10 Medlows
    AL5 3AY Harpenden
    Hertfordshire
    British29600080004
    LAST, Richard
    The Leys Farm
    Banbury Road Great Tew
    OX7 4DL Chipping Norton
    Oxfordshire
    Director
    The Leys Farm
    Banbury Road Great Tew
    OX7 4DL Chipping Norton
    Oxfordshire
    United KingdomBritish80537570001
    LINDGREN, Peter
    Drakskeppsragen 55
    Taby
    Se-18363
    Sweden
    Director
    Drakskeppsragen 55
    Taby
    Se-18363
    Sweden
    Swedish106852790001
    LISCOMBE, David Kenneth
    Pear Tree Farm Ainsworth Lane
    Crowton
    CW8 2RS Northwich
    Cheshire
    Director
    Pear Tree Farm Ainsworth Lane
    Crowton
    CW8 2RS Northwich
    Cheshire
    British6387640001
    LUUPPALA, Harri Pentti Kalervo
    Hakatie 15
    FOREIGN Tampere
    Fi-33880
    Finland
    Director
    Hakatie 15
    FOREIGN Tampere
    Fi-33880
    Finland
    Finnish106853820001
    MILNER, Andrew
    12 Park Lane
    Upper Cumberworth
    HD8 8NP Huddersfield
    West Yorkshire
    Director
    12 Park Lane
    Upper Cumberworth
    HD8 8NP Huddersfield
    West Yorkshire
    British62567380001
    PELTOLA, Veli Erik
    Alberganesplanadi 9a5
    FOREIGN Espoo
    Fi-02600
    Finland
    Director
    Alberganesplanadi 9a5
    FOREIGN Espoo
    Fi-02600
    Finland
    Finnish106852630001
    PELTONEN, Ari Petteri
    Arenson Way
    Houghton Regis
    LU5 5UL Dunstable
    Ground Floor, The Arenson Centre
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Director
    Arenson Way
    Houghton Regis
    LU5 5UL Dunstable
    Ground Floor, The Arenson Centre
    Bedfordshire
    United Kingdom
    FinlandFinnish139265650001
    SINNETT, Paul Martin
    Mill Croft Barn
    Water Stratford Road
    MK18 4PD Tingewick
    Director
    Mill Croft Barn
    Water Stratford Road
    MK18 4PD Tingewick
    EnglandBritish71468530002
    WEBBER, David Paul, Mr.
    12 Rotten Row
    Great Brickhill
    MK17 9BA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Director
    12 Rotten Row
    Great Brickhill
    MK17 9BA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British47915530002
    WILLIAMS, David
    2 Seven Stiles Drive
    Marple
    SK6 6LT Stockport
    Cheshire
    Director
    2 Seven Stiles Drive
    Marple
    SK6 6LT Stockport
    Cheshire
    British57223140001
    WOOD, Philip Basil
    Portelet
    High Street Croydon
    SG8 0DR Royston
    Hertfordshire
    Director
    Portelet
    High Street Croydon
    SG8 0DR Royston
    Hertfordshire
    EnglandBritish72282230002
    WYETH, David, Dr
    35 Barlings Road
    AL5 2AW Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    35 Barlings Road
    AL5 2AW Harpenden
    Hertfordshire
    British4060250001

    ¿Tiene TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Accession deed
    Creado el 25 jun 2002
    Entregado el 03 jul 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to the dnb finance parties and/or the suk finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Skandia UK Limited (As "Security Agent")
    Transacciones
    • 03 jul 2002Registro de un cargo (395)
    • 08 abr 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of assignment of intellectual property rights and floating charge
    Creado el 02 mar 1994
    Entregado el 08 mar 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge upon the trade names "BS5" and "summit" floating charges upon all other the undertaking and all other property and assets of the company both present and future; any property and assets of the company both present and future by way of fixed charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • 3I Group PLC
    Transacciones
    • 08 mar 1994Registro de un cargo (395)
    • 14 nov 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 02 mar 1994
    Entregado el 08 mar 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • 3I Group PLC
    Transacciones
    • 08 mar 1994Registro de un cargo (395)
    • 14 nov 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 08 feb 1994
    Entregado el 16 feb 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 16 feb 1994Registro de un cargo (395)
    • 03 jul 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0