TOP TEN HOLDINGS PLC

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTOP TEN HOLDINGS PLC
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad anónima cotizada
    Número de empresa 02891251
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TOP TEN HOLDINGS PLC?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra TOP TEN HOLDINGS PLC?

    Dirección de la sede social
    11th Floor Landmark St Peter's Square
    1 Oxford St
    M1 4PB Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TOP TEN HOLDINGS PLC?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    XS LEISURE PLC14 jun 199914 jun 1999
    SANCTUARY LEISURE PLC20 ene 199420 ene 1994

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TOP TEN HOLDINGS PLC?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2013

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TOP TEN HOLDINGS PLC?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    33 páginasLIQ14

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 02 jul 2022

    30 páginasLIQ03

    Domicilio social registrado cambiado de 4 Hardman Square Spinningfields Manchester a 11th Floor Landmark St Peter's Square 1 Oxford St Manchester M1 4PB el 15 nov 2021

    2 páginasAD01

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 02 jul 2021

    32 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 02 jul 2020

    28 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 02 jul 2019

    30 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 02 jul 2018

    38 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 02 jul 2017

    38 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 02 jul 2016

    33 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 02 jul 2015

    23 páginas4.68

    Orden judicial de insolvencia

    Court order insolvency:re ian corfield ceasing to hold office as liquidator
    12 páginasLIQ MISC OC

    Aviso de cese de funciones como liquidador voluntario

    1 páginas4.40

    Domicilio social registrado cambiado de Unit 8 Verulam Industrial Estate London Road St Albans Hertfordshire AL1 1JF a 4 Hardman Square Spinningfields Manchester el 22 jul 2014

    2 páginasAD01

    Declaración de asuntos con el formulario adjunto 4.19

    17 páginas4.20

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación el 03 jul 2014

    LRESEX

    Cese del nombramiento de un director

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Alan Weston como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de John Kerr como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Allen Walsh como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Gary Bennett como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Gary Bennett como secretario

    1 páginasTM02

    Cambio de datos del director Alan Harry Weston el 12 feb 2014

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 20 ene 2014 avec liste globale des actionnaires

    18 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 feb 2014

    Estado de capital el 18 feb 2014

    • Capital: GBP 5,101,121.4
    SH01

    ¿Quiénes son los directivos de TOP TEN HOLDINGS PLC?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ARIS, Paul
    81 Flora Thompson Drive
    MK16 8SR Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Secretario
    81 Flora Thompson Drive
    MK16 8SR Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    British43131730001
    BENNETT, Gary Roger
    Unit 8 Verulam Industrial Estate
    London Road
    AL1 1JF St Albans
    Hertfordshire
    Secretario
    Unit 8 Verulam Industrial Estate
    London Road
    AL1 1JF St Albans
    Hertfordshire
    British105612540002
    BUNT, Philip Alan
    176 Whitchurch Lane
    HA8 6QJ Edgware
    Secretario
    176 Whitchurch Lane
    HA8 6QJ Edgware
    BritishCompany Secretary33027500001
    ROSENBERG, Anthony
    Horsewalk Cottage
    Akeley Road Lillingstone
    MK18 5BF Lovell
    Buckinghamshire
    Secretario
    Horsewalk Cottage
    Akeley Road Lillingstone
    MK18 5BF Lovell
    Buckinghamshire
    BritishDirector98819810001
    WESTON, Alan Harry
    72 Hillside Gardens
    HA8 8HD Edgware
    Middlesex
    Secretario
    72 Hillside Gardens
    HA8 8HD Edgware
    Middlesex
    BritishChartered Accountant48545280003
    FILEX SERVICES LIMITED
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    Secretario corporativo
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    3620420001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secretario designado corporativo
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    BENNETT, Gary Roger
    Unit 8 Verulam Industrial Estate
    London Road
    AL1 1JF St Albans
    Hertfordshire
    Director
    Unit 8 Verulam Industrial Estate
    London Road
    AL1 1JF St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritishAccountant105612540002
    BROCKLEBANK, Aubrey Thomas, Sir
    Hunters Lodge St Andrews Lane
    Titchmarsh
    NN14 3DN Kettering
    Northamptonshire
    Director
    Hunters Lodge St Andrews Lane
    Titchmarsh
    NN14 3DN Kettering
    Northamptonshire
    Gb-GbnBritishCompany Director56733000005
    BUNT, Philip Alan
    176 Whitchurch Lane
    HA8 6QJ Edgware
    Director
    176 Whitchurch Lane
    HA8 6QJ Edgware
    United KingdomBritishChartered Accountant33027500001
    GOULDEN, Neil Geoffrey
    One The Shires
    RG41 4SZ Wokingham
    Berkshire
    Director
    One The Shires
    RG41 4SZ Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritishManaging Director21686380003
    JAY, Peter Harry
    Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    100
    Director
    Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    100
    United KingdomBritishSolicitor34963720001
    KERR, John Graham
    Unit 8 Verulam Industrial Estate
    London Road
    AL1 1JF St Albans
    Hertfordshire
    Director
    Unit 8 Verulam Industrial Estate
    London Road
    AL1 1JF St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director91841230002
    MACDONALD, David
    30 Sycamore Close
    Burbage
    LE10 2JU Hinckley
    Leicestershire
    Director
    30 Sycamore Close
    Burbage
    LE10 2JU Hinckley
    Leicestershire
    BritishOperations Director58279490001
    ROBERTS, Philip Bruce
    1 Fairfield Road
    Drury
    CH7 3EE Buckley
    Clwyd
    Director
    1 Fairfield Road
    Drury
    CH7 3EE Buckley
    Clwyd
    BritishCompany Director13669690001
    ROSENBERG, Anthony
    Horsewalk Cottage
    Akeley Road Lillingstone
    MK18 5BF Lovell
    Buckinghamshire
    Director
    Horsewalk Cottage
    Akeley Road Lillingstone
    MK18 5BF Lovell
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director98819810001
    ROSENBERG HURST, Kathryn Macia
    Yewhurst
    Chorleywood
    WD3 4ER Rickmansworth
    Hertfordshire
    Director
    Yewhurst
    Chorleywood
    WD3 4ER Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishMarketing Director38207730001
    SIMONS, Richard Ivan
    Flat 1 66 Maresfield Gardens
    Hampstead
    NW3 5TD London
    Director
    Flat 1 66 Maresfield Gardens
    Hampstead
    NW3 5TD London
    United KingdomBritishDirector7157150002
    WALSH, Allen Richard
    Unit 8 Verulam Industrial Estate
    London Road
    AL1 1JF St Albans
    Hertfordshire
    Director
    Unit 8 Verulam Industrial Estate
    London Road
    AL1 1JF St Albans
    Hertfordshire
    United Kingdom BritishDirector96098180001
    WESTON, Alan Harry
    Unit 8 Verulam Industrial Estate
    London Road
    AL1 1JF St Albans
    Hertfordshire
    Director
    Unit 8 Verulam Industrial Estate
    London Road
    AL1 1JF St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Accountant48545280004
    WESTON, Ivan
    Little Court Cottage Nan Clarks Lane
    NW7 4HH London
    Director
    Little Court Cottage Nan Clarks Lane
    NW7 4HH London
    BritishDirector2263350001
    WESTON, Samuel Norman
    Wellers Mead
    Old Mill Road
    UB9 5AS Denham
    Buckinghamshire
    Director
    Wellers Mead
    Old Mill Road
    UB9 5AS Denham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishManaging Director12413340001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Director designado corporativo
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    ¿Tiene TOP TEN HOLDINGS PLC alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Assignment
    Creado el 15 ago 2006
    Entregado el 19 ago 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All of its rights titles benefits and interests in and to the share purchase agreement and the tax deed. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 19 ago 2006Registro de un cargo (395)
    Assignment
    Creado el 20 ene 2006
    Entregado el 24 ene 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All the rights,titles,benefits and interests of the company whatsoever present and future whether proprietary,contractual or otherwise under or arising out of or evidenced by a share purchase agreement dated 22ND decmeber 2005. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 24 ene 2006Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 16 jul 2003
    Entregado el 18 jul 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    24/26 chapel street camborne cornwall t/n CL93666. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 18 jul 2003Registro de un cargo (395)
    • 23 sept 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 23 dic 2002
    Entregado el 31 dic 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 31 dic 2002Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 07 ago 2001
    Entregado el 11 ago 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Planned Amusements Limited
    Transacciones
    • 11 ago 2001Registro de un cargo (395)
    • 19 dic 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 18 jul 2000
    Entregado el 04 ago 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 04 ago 2000Registro de un cargo (395)
    • 08 dic 2000Nombramiento de un receptor o gerente (405 (1))
    • 31 may 2002Aviso de cese de funciones como receptor o gerente (405 (2))
    • 19 dic 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
      • Número de expediente 1
    Debenture
    Creado el 18 jul 2000
    Entregado el 22 jul 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under clause 2.2 of a supplemental agreement dated 18TH july 2000 and this debenture
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Allied Leisure PLC
    Transacciones
    • 22 jul 2000Registro de un cargo (395)
    • 19 dic 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 31 mar 1998
    Entregado el 18 abr 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a business acquisition agreement dated 6TH december 1997 and this deed
    Breve descripción
    Various properties as specified in the schedule to the form 395 all buildings fixtures fixed plant and machinery. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Allied Leisure PLC
    Transacciones
    • 18 abr 1998Registro de un cargo (395)
    • 19 dic 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 31 mar 1998
    Entregado el 08 abr 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H 75 to 79 high street and 76 to 81 king street dudley T.n WM438702 f/h the dean snooker and bowls centre foxes bridge road cinderford t/n GR87850 F.h billericay transport depot radford way mountnessing t/n EX346834. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The British Linen Bank Limited
    Transacciones
    • 08 abr 1998Registro de un cargo (395)
    • 19 dic 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene TOP TEN HOLDINGS PLC algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    18 jul 2000Fecha del instrumento
    Administrador judicial nombrado
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Christopher Kim Rayment
    Pannell Kerr Forster
    New Garden House
    EC1N 8JA 78 Hatton Garden
    London
    Profesional
    Pannell Kerr Forster
    New Garden House
    EC1N 8JA 78 Hatton Garden
    London
    Michael Oldham
    Pannell Kerr Forster
    New Garden House
    EC1M 9JA 78 Hatton Garden
    London
    Profesional
    Pannell Kerr Forster
    New Garden House
    EC1M 9JA 78 Hatton Garden
    London
    Bryan Jackson
    Pannell Kerr Forster
    New Garden House
    EC1N 8JA 78 Hatton Garden
    London
    Profesional
    Pannell Kerr Forster
    New Garden House
    EC1N 8JA 78 Hatton Garden
    London
    2
    FechaTipo
    15 jun 2001Fecha de la reunión para aprobar el CVA
    06 ago 2003Fecha de finalización o terminación del CVA
    Acuerdo voluntario de reestructuración empresarial (CVA)
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Lee Antony Manning
    Kroll Buchler Phillips
    84 Grosvenor Street
    W1K 3LN London
    Profesional
    Kroll Buchler Phillips
    84 Grosvenor Street
    W1K 3LN London
    Gary Peter Squires
    Kroll Buchler Phillips
    84 Grosvenor Street
    W1K 3LN London
    Profesional
    Kroll Buchler Phillips
    84 Grosvenor Street
    W1K 3LN London
    3
    FechaTipo
    03 jul 2014Inicio de la liquidación
    26 ago 2023Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Ian James Corfield
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Profesional
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Daniel Robert Whiteley Smith
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Profesional
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0