EXOR CORPORATION LIMITED

EXOR CORPORATION LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaEXOR CORPORATION LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02898430
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de EXOR CORPORATION LIMITED?

    • Otras actividades de servicios de tecnología de la información (62090) / Información y comunicación

    ¿Dónde se encuentra EXOR CORPORATION LIMITED?

    Dirección de la sede social
    9th Floor No. 20
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de EXOR CORPORATION LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    LEARNMUCH PROJECTS LIMITED15 feb 199415 feb 1994

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de EXOR CORPORATION LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 nov 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para EXOR CORPORATION LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 30 nov 2015

    19 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 15 feb 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 mar 2016

    Estado de capital el 04 mar 2016

    • Capital: GBP 3,904,752.05
    SH01

    Cese del nombramiento de Paul William Eaton como secretario el 01 oct 2015

    1 páginasTM02

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 30 nov 2014

    20 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 15 feb 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital14 abr 2015

    Estado de capital el 14 abr 2015

    • Capital: GBP 3,904,752.05
    SH01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 30 nov 2013

    20 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 15 feb 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital16 abr 2014

    Estado de capital el 16 abr 2014

    • Capital: GBP 3,904,752.05
    SH01

    Cese del nombramiento de Stephen Voller como director

    1 páginasTM01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 30 nov 2012

    25 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 15 feb 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Nicholas Johnson como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Nicholas Johnson como director

    1 páginasTM01

    Exercice comptable précédent prolongé du 31 may 2012 au 30 nov 2012

    1 páginasAA01

    Déclaration annuelle établie au 15 feb 2012 avec liste complète des actionnaires

    12 páginasAR01

    Renuncia del auditor

    2 páginasAUD

    Misceláneos

    Section 519
    1 páginasMISC

    Domicilio social registrado cambiado de * Clifton Heights Clifton Bristol BS8 1EJ* el 14 nov 2011

    1 páginasAD01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 may 2011

    21 páginasAA

    Nombramiento de David Hollister como director

    2 páginasAP01

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Cese del nombramiento de John Lynch como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Andrew Rowlinson como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de EXOR CORPORATION LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HOLLISTER, David
    Floor No. 20
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    9th
    United Kingdom
    Director
    Floor No. 20
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    9th
    United Kingdom
    UsaAmericanChief Financial Officer161824250001
    JOHNSON, Andrew Neil
    Floor No. 20
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    9th
    United Kingdom
    Director
    Floor No. 20
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    9th
    United Kingdom
    UsaBritishVice President Software Development & Consultancy148386100001
    DASHFIELD, Kay Rosalind Clare
    Clifton Heights
    Clifton
    BS8 1EJ Bristol
    Secretario
    Clifton Heights
    Clifton
    BS8 1EJ Bristol
    British46710460004
    EATON, Paul William
    Copthorne Bank
    Copthorne
    RH10 3JQ Crawley
    Alford
    West Sussex
    England
    Secretario
    Copthorne Bank
    Copthorne
    RH10 3JQ Crawley
    Alford
    West Sussex
    England
    155343000001
    BYRON COMPANY SERVICES LIMITED
    7 Berkeley Square
    Clifton
    BS8 1HG Bristol
    Secretario corporativo
    7 Berkeley Square
    Clifton
    BS8 1HG Bristol
    37866710001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BEARDSHALL, Samuel Francis Rodney
    Clifton Heights
    Clifton
    BS8 1EJ Bristol
    Director
    Clifton Heights
    Clifton
    BS8 1EJ Bristol
    United KingdomBritishDirector47184440001
    DARKE, Lawrence Constable
    4 Ribston Mews
    GL1 5EU Gloucester
    Director
    4 Ribston Mews
    GL1 5EU Gloucester
    BritishDirector73000100002
    DASHFIELD, Kay Rosalind Clare
    Badgers Wood 8 Church Road
    Easton In Gordano
    BS20 0PQ Bristol
    North Somerset
    Director
    Badgers Wood 8 Church Road
    Easton In Gordano
    BS20 0PQ Bristol
    North Somerset
    United KingdomBritishDirector46710460004
    JOHNSON, Nicholas John
    Floor No. 20
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    9th
    United Kingdom
    Director
    Floor No. 20
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    9th
    United Kingdom
    EnglandBritishServices Director216618540001
    LITTLEDALE, Robert Wheatley
    Highfield The Slade
    Charlbury
    OX7 3SJ Chipping Norton
    Oxfordshire
    Director
    Highfield The Slade
    Charlbury
    OX7 3SJ Chipping Norton
    Oxfordshire
    BritishDirector1450690001
    LOARRIDGE, Russell John, Mr.
    Clifton Heights
    Clifton
    BS8 1EJ Bristol
    Director
    Clifton Heights
    Clifton
    BS8 1EJ Bristol
    UkBritishSales Director133183080002
    LYNCH, John Edward
    Ne 16th Street
    33304 Fort Lauderdale
    2225
    Florida
    Usa
    Director
    Ne 16th Street
    33304 Fort Lauderdale
    2225
    Florida
    Usa
    UsaAmericanSoftware Executive148387790001
    ROWLINSON, Andrew
    Clifton Heights
    Clifton
    BS8 1EJ Bristol
    Director
    Clifton Heights
    Clifton
    BS8 1EJ Bristol
    EnglandBritishDirector73000000001
    SMITH, Stephen Rhodes
    2 Princes Building
    Clifton
    BS8 4LB Bristol
    Avon
    Director
    2 Princes Building
    Clifton
    BS8 4LB Bristol
    Avon
    United KingdomBritishDirector46536530001
    TAYLOR, Bryan Lloyd
    Hatch Cottage
    Kent Street, Cowfold
    RH13 8BG Horsham
    West Sussex
    Director
    Hatch Cottage
    Kent Street, Cowfold
    RH13 8BG Horsham
    West Sussex
    EnglandBritishDirector71356520002
    VOLLER, Stephen Roy
    The Grange
    60 West Street
    BS6 6LJ Banwell
    North Somerset
    Director
    The Grange
    60 West Street
    BS6 6LJ Banwell
    North Somerset
    EnglandBritishDirector47184600007
    WARD, John
    37 Country Road
    Mamaroneck
    Ny 10543
    Usa
    Director
    37 Country Road
    Mamaroneck
    Ny 10543
    Usa
    BritishDirector73000370001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Tiene EXOR CORPORATION LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 22 oct 2008
    Entregado el 25 oct 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 25 oct 2008Registro de un cargo (395)
    • 05 ene 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 27 mar 2007
    Entregado el 14 abr 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Robert Hampson and Douglas Hampson
    Transacciones
    • 14 abr 2007Registro de un cargo (395)
    • 21 ene 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 20 mar 2002
    Entregado el 10 abr 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Robert Hampson, Mark O'hare and Douglas Hampson
    Transacciones
    • 10 abr 2002Registro de un cargo (395)
    • 13 ene 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 26 oct 2001
    Entregado el 02 nov 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the deed
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • 3I Group PLC
    Transacciones
    • 02 nov 2001Registro de un cargo (395)
    • 01 ago 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 04 oct 2000
    Entregado el 11 oct 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 11 oct 2000Registro de un cargo (395)
    • 02 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 31 jul 2000
    Entregado el 03 ago 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an investment agreement and a pik note instrument both of even date
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • 3I Group PLC
    Transacciones
    • 03 ago 2000Registro de un cargo (395)
    • 01 ago 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 06 mar 1996
    Entregado el 13 mar 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 13 mar 1996Registro de un cargo (395)
    • 20 ene 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0