CANTIUM ESTATES LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | CANTIUM ESTATES LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02902074 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CANTIUM ESTATES LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra CANTIUM ESTATES LIMITED?
Dirección de la sede social | 125 Old Broad Street EC2N 1AR London |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CANTIUM ESTATES LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CANTIUM ESTATES LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelaci ón voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 4 páginas | DS01 | ||||||||||
legacy | 2 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 19 dic 2019
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Grace Parsons-Hann como secretario el 16 sept 2019 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Sunita Kaushal como secretario el 05 ago 2019 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Sunita Kaushal como director el 05 ago 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 28 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 11 mar 2019 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 029020740003 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 029020740002 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 feb 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr John Forrester como director el 31 dic 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Manuel Uria Fernandez como director el 31 dic 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Sunita Kaushal como director el 31 dic 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Steven John Watts como director el 31 dic 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 7 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 4 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de los objetos de la sociedad | 2 páginas | CC04 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 8 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CANTIUM ESTATES LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARSONS-HANN, Grace | Secretario | Old Broad Street EC2N 1AR London 125 United Kingdom | 263117370001 | |||||||
FORRESTER, John | Director | Old Broad Street EC2N 1AR London 125 | United Kingdom | British | Global President | 180421110001 | ||||
PATEL, Parimal Raojibhai | Director | Old Broad Street EC2N 1AR London 125 | England | British | Cfo | 110799560001 | ||||
URIA FERNANDEZ, Manuel | Director | Old Broad Street EC2N 1AR London 125 | England | British | Cfo | 209898500001 | ||||
ALLY, Bibi Rahima | Secretario | 68 Ruskin Road SM5 3DH Carshalton Surrey | British | 38963210001 | ||||||
COOK, Philip Michael | Secretario | 7 Orchard Avenue AL5 2DW Harpenden Hertfordshire | British | 44542950002 | ||||||
HICKSON, Robin Lister | Secretario | 23 Meadowbrook RH8 9LT Oxted Surrey | British | Chartered Accountant | 39528960002 | |||||
HOLE, Patrick David | Secretario | Old Broad Street EC2N 2BQ London 125 | 165635520001 | |||||||
KAUSHAL, Sunita | Secretario | Old Broad Street EC2N 1AR London 125 | 192648450001 | |||||||
KEDDIE, Fiona | Secretario | Old Broad Street EC2N 2BQ London 125 Uk | British | 159535860001 | ||||||
KNOWLES, Elizabeth Christine | Secretario | Rowas Lodge Limpley Stoke BA3 6HD Bath | British | Chartered Surveyor | 37512410001 | |||||
O'MAHONEY, John William | Secretario | 78 Broomleaf Road GU9 8DH Farnham Surrey | British | Company Secretary | 10030840002 | |||||
BERNARD, Nicholas Raymond Thomas | Director | 150 Victoria Rise Clapham SW4 0NW London | British | Chartered Accountant | 44375830001 | |||||
BLAXLAND, Richard Bryan | Director | Gleamingwood 10 Walderslade Road ME4 6NX Chatham Kent | England | British | Chartered Accountant | 9530670001 | ||||
BONACCORSO, Robert Philip | Director | 40 Miller Street North Sydney Ugl Level 10 Nsw2060 Australia | Australia | Australian | Director | 148966520001 | ||||
BROOKS, Richard John | Director | Old Broad Street EC2N 2BQ London Dtz 125 Uk | England | British | Uk Finance Director | 137141840001 | ||||
CHILD, Colin Charles | Director | Waterside House Headbourne Worthy SO23 7JR Winchester Hants | England | British | Chartered Accountant | 125146440001 | ||||
COLLETT, Brian | Director | 254 Old Church Road Chingford E4 8BT London | British | Company Director | 32267100002 | |||||
GODDARD, Terence Philip | Director | St Annes Grange MK17 0BH Newton Longville Bucks | England | British | Company Director | 15955560001 | ||||
HICKSON, Robin Lister | Director | 23 Meadowbrook RH8 9LT Oxted Surrey | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 39528960002 | ||||
HINDE, Robert Walter | Director | Old Pond Farm Harvel DA13 0BS Gravesend Kent | British | Company Director | 3224990001 | |||||
HODGSON, Timothy James | Director | Orchard House 33 Tudor Road TW12 2NG Hampton Middlesex | United Kingdom | British | Company Director | 32809750001 | ||||
IDZIK, Paul Thomas | Director | Parliament View SE1 7XH London Apartment A43 | American British (Dual Nationality) | Chief Executive Officer | 142840070001 | |||||
KAUSHAL, Sunita | Director | Old Broad Street EC2N 1AR London 125 | United Kingdom | British | General Counsel & Company Secretary, Emea | 210791240001 | ||||
KNOWLES, Elizabeth Christine | Director | Rowas Lodge Limpley Stoke BA3 6HD Bath | British | Chartered Surveyor | 37512410001 | |||||
LAY, Richard Neville | Director | Meadow Cottage Winderton OX15 5JF Banbury Oxfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 76458250001 | ||||
LEUPEN, Richard Anthony | Director | 40 Miller Street North Sydney Ugl Level 10 Nsw 2060 Australia | Australia | Australian | Ceo | 104341100001 | ||||
MACKANESS, Alexandra Antonia | Director | 156 Campden Hill Road W8 7AS London | British | Investment Banker | 39096000001 | |||||
MASTERSON, Christopher Mary | Director | 19 Tower Road TW14 4PD Twickenham Middlesex | British | Company Director | 35526310001 | |||||
MAYNARD, Timothy Sven | Director | Cressford Waterend Lane AL3 7JZ Redbourn Hertfordshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 154455200001 | ||||
MCARDLE, Murray Bede | Director | 40 Miller Street North Sydney Ugl Level 10 Nsw 2060 Australia | Australia | Australian | Lawyer | 180412880001 | ||||
MENTZINES, Dennis Dionysios | Director | Level 10 40 Miller Street North Sydney Ugl Nsw2060 Australia | Australia | Australian | Lawyer | 180412180001 | ||||
SMYTH, Timothy Wallace | Director | 8 St Matthews Avenue KT6 6JJ Surbiton Surrey | British | Accountant | 16375950001 | |||||
STRUCKETT, Mark Douglas | Director | Cranmere House Pook Lane Lavant PO18 0AD Chichester West Sussex | England | British | Chartered Surveyor | 18760280003 | ||||
THOMSON, James Michael Douglas | Director | Old Broad Street EC2N 2BQ London Dtz 125 United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 71716020003 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CANTIUM ESTATES LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dtz Europe Limited | 01 jun 2016 | Old Broad Street EC2N 1AR London 125 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene CANTIUM ESTATES LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creado el 07 nov 2014 Entregado el 14 nov 2014 | Satisfecho en su totalidad | ||
Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 07 nov 2014 Entregado el 14 nov 2014 | Satisfecho en su totalidad | ||
Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fixed and floating charge | Creado el 10 may 1994 Entregado el 16 may 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0