EDMONTON GROUP LIMITED

EDMONTON GROUP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaEDMONTON GROUP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02904479
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de EDMONTON GROUP LIMITED?

    • (7420) /

    ¿Dónde se encuentra EDMONTON GROUP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de EDMONTON GROUP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    DBK GROUP LIMITED05 jun 200905 jun 2009
    DBK BACK LIMITED16 oct 200616 oct 2006
    BACK GROUP LIMITED18 jul 200018 jul 2000
    THE DAVID BACK GROUP LIMITED31 mar 199431 mar 1994
    OAKBRIGHT LIMITED03 mar 199403 mar 1994

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de EDMONTON GROUP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2009

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para EDMONTON GROUP LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para EDMONTON GROUP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    14 páginas4.72

    Aviso de cese de funciones como liquidador voluntario

    1 páginas4.40

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Orden judicial de insolvencia

    Court order insolvency:replacement liquidator
    36 páginasLIQ MISC OC

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 31 ene 2014

    9 páginas4.68

    Domicilio social registrado cambiado de Enterprise House 115 Edmund Street Birmingham B3 2HJ el 16 abr 2013

    2 páginasAD01

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 31 ene 2013

    9 páginas4.68

    Informe de progreso del administrador hasta 03 feb 2012

    9 páginas2.24B

    Aviso de cambio de la administración a la liquidación voluntaria de acreedores

    1 páginas2.34B

    Domicilio social registrado cambiado de 321 Bradford Street Birmingham B5 6ET United Kingdom el 24 ago 2011

    2 páginasAD01

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    1 páginasF2.18

    Declaración de la propuesta del administrador

    21 páginas2.17B

    Declaración de asuntos con el formulario 2.14B

    11 páginas2.16B

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed dbk group LIMITED\certificate issued on 01/04/11
    3 páginasCERTNM
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 18 mar 2011

    RES15

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 18 mar 2011

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Nombramiento de un administrador

    1 páginas2.12B

    Cese del nombramiento de Gordon Balharrie como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Jonathan Addis como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Roger Adams como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 15 feb 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital11 mar 2010

    Estado de capital el 11 mar 2010

    • Capital: GBP 84.95
    SH01

    Cambio de datos del director Andrew Martin Kennedy el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2009

    22 páginasAA

    Cambio de datos del director Gordon Alexander Balharrie el 30 mar 2007

    1 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de EDMONTON GROUP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MASSEY, Andrew Joseph
    Ranikhet
    Wenlock Road
    WV16 5AZ Bridgnorth
    Shropshire
    Secretario
    Ranikhet
    Wenlock Road
    WV16 5AZ Bridgnorth
    Shropshire
    British62344120004
    BERRY, Duncan Steven
    27 Oakham Road
    Harborne
    B17 9DQ Birmingham
    West Midlands
    Director
    27 Oakham Road
    Harborne
    B17 9DQ Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritishQuantity Surveyor94586760001
    DOWNING, Timothy James
    Cruck Barn
    Chetton
    WV16 6UF Bridgnorth
    Shropshire
    Director
    Cruck Barn
    Chetton
    WV16 6UF Bridgnorth
    Shropshire
    EnglandBritishDirector38793840002
    KELLY, Steven Paul
    Middle Mill
    Stratford Road Wooton Wawen
    B95 6BY Henley In Arden
    Warwickshire
    Director
    Middle Mill
    Stratford Road Wooton Wawen
    B95 6BY Henley In Arden
    Warwickshire
    EnglandBritishQuantity Surveyor94587020002
    KENNEDY, Andrew Martin
    The Folly
    Hurn Court Hurn
    BH23 6BH Christchurch
    Dorset
    England
    Director
    The Folly
    Hurn Court Hurn
    BH23 6BH Christchurch
    Dorset
    England
    United KingdomBritishQuantity Surveyor51174310001
    WADLOW, Lawrence
    19 Lakeside Drive
    Monkspath
    B90 4SX Solihull
    West Midlands
    Secretario
    19 Lakeside Drive
    Monkspath
    B90 4SX Solihull
    West Midlands
    British38794190001
    WEBB, Paul John
    11 Woodstock Crescent
    Dorridge
    B93 8DA Solihull
    West Midlands
    Secretario
    11 Woodstock Crescent
    Dorridge
    B93 8DA Solihull
    West Midlands
    BritishQuantity Surveyor38794230001
    RUTLAND SECRETARIES LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Secretario designado corporativo
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    900005290001
    ADAMS, Roger William
    60 Golf Links Road
    BH22 8BZ Ferndown
    Dorset
    Director
    60 Golf Links Road
    BH22 8BZ Ferndown
    Dorset
    United KingdomBritishQuantity Surveyor49690040001
    ADDIS, Jonathan Peter
    Park Hill
    B13 8DS Birmingham
    98
    West Midlands
    United Kingdom
    Director
    Park Hill
    B13 8DS Birmingham
    98
    West Midlands
    United Kingdom
    EnglandBritishGroup Finance Director260439420001
    BACK, David Ronald
    Fairfield
    Old Warwick Road, Lapworth
    B94 6JZ Solihull
    West Midlands
    Director
    Fairfield
    Old Warwick Road, Lapworth
    B94 6JZ Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishQuantity Surveyor38545940001
    BALHARRIE, Gordon Alexander
    Waverley Avenue
    Berrylands
    KT5 9HD Surbiton
    23
    Surrey
    Director
    Waverley Avenue
    Berrylands
    KT5 9HD Surbiton
    23
    Surrey
    United KingdomBritishQuantity Surveyor158788510001
    BLACK, Philip Howard
    119 Wentworth Road
    B17 9SU Birmingham
    Director
    119 Wentworth Road
    B17 9SU Birmingham
    BritishDirector87058240001
    DANDO, Ralph Henry
    Poplar Cottage
    Pebmarsh
    CO9 2QE Halstead
    Essex
    Director
    Poplar Cottage
    Pebmarsh
    CO9 2QE Halstead
    Essex
    BritishCivil Engineer142509180001
    MUSE, Alan George
    5 Grove Road
    SL4 1JE Windsor
    Berkshire
    Director
    5 Grove Road
    SL4 1JE Windsor
    Berkshire
    BritishProject Manager66902080002
    STEWART, Alan Wright
    17 Warren Drive
    DY3 3RQ Dudley
    West Midlands
    Director
    17 Warren Drive
    DY3 3RQ Dudley
    West Midlands
    EnglandBritishProject Manager66105690001
    WADLOW, Lawrence
    19 Lakeside Drive
    Monkspath
    B90 4SX Solihull
    West Midlands
    Director
    19 Lakeside Drive
    Monkspath
    B90 4SX Solihull
    West Midlands
    BritishQuantity Surveyor38794190001
    WEBB, Paul John
    11 Woodstock Crescent
    Dorridge
    B93 8DA Solihull
    West Midlands
    Director
    11 Woodstock Crescent
    Dorridge
    B93 8DA Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishQuantity Surveyor38794230001
    RUTLAND DIRECTORS LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Director designado corporativo
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    900005280001

    ¿Tiene EDMONTON GROUP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 30 mar 2007
    Entregado el 11 abr 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Roger William Adams, Andrew Martin Kennedy, Gordon Alexander Balharrie
    Transacciones
    • 11 abr 2007Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 12 ago 2005
    Entregado el 23 ago 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 23 ago 2005Registro de un cargo (395)
    Assignment of life policy
    Creado el 12 ago 2005
    Entregado el 23 ago 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Any right to receive payment in the policy of insurance number 14/6176818-0 and all bonuses and benefits. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 23 ago 2005Registro de un cargo (395)
    Assignment of life policy
    Creado el 12 ago 2005
    Entregado el 23 ago 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Any right to receive payment in the policy of insurance number 14/6176896-2 and all bonuses and benefits. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 23 ago 2005Registro de un cargo (395)
    Assignment of life policy
    Creado el 12 ago 2005
    Entregado el 23 ago 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Any right to receive payment in the policy of insurance number 14/6176803-2 and all bonuses and benefits. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 23 ago 2005Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 01 oct 2004
    Entregado el 13 oct 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 13 oct 2004Registro de un cargo (395)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creado el 01 jun 2001
    Entregado el 05 jun 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All the company's right title benefit and interest in and to the account with the bank denominated in sterling designated lloyds tsb bank PLC re;-back group limited now numbered 07318904 and any account(s) replacing the same. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 05 jun 2001Registro de un cargo (395)
    • 19 may 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Single debenture
    Creado el 04 may 1994
    Entregado el 10 may 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 10 may 1994Registro de un cargo (395)
    • 19 may 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene EDMONTON GROUP LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    01 feb 2012Fin de la administración
    04 feb 2011Inicio de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Profesional
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    David James Bennett
    Enterprise House 115 Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    Profesional
    Enterprise House 115 Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    2
    FechaTipo
    01 feb 2012Inicio de la liquidación
    13 abr 2015Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Profesional
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    David James Bennett
    Enterprise House 115 Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    Profesional
    Enterprise House 115 Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    David Michael Riley
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Profesional
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0