CASSEL PROPERTIES LIMITED

CASSEL PROPERTIES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCASSEL PROPERTIES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02906143
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CASSEL PROPERTIES LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra CASSEL PROPERTIES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    5 Wigmore Street
    London
    W1U 1PB
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CASSEL PROPERTIES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    DE FACTO 343 LIMITED08 mar 199408 mar 1994

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CASSEL PROPERTIES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2012

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CASSEL PROPERTIES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    2 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 02 mar 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital15 mar 2013

    Estado de capital el 15 mar 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2012

    13 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 02 mar 2012

    6 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2011

    16 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 02 mar 2011

    6 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2010

    16 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2009

    15 páginasAA

    Cambio de datos del director Christopher George White el 01 may 2010

    3 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Maurice Moses Benady el 01 may 2010

    3 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 02 mar 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Trafalgar Officers Limited el 02 mar 2010

    1 páginasCH02

    Cambio de datos del secretario Reit(Corporate Services) Limited el 09 dic 2009

    1 páginasCH04

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2008

    15 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    4 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    4 páginas288a

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Quoting section 175 of the companies act 2006 10/11/2008
    RES13

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Quoting section 175 of the companies act 2006 10/11/2008
    RES13

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Quoting section 175 of the companies act 2006 10/11/2008
    RES13

    Resoluciones

    Resolutions
    4 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01
    capital

    Resoluciones

    Quoting section 175 of the companies act 2006 10/11/2008
    RES13

    ¿Quiénes son los directivos de CASSEL PROPERTIES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Secretario corporativo
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro3143222
    79571870006
    BENADY, Maurice Moses
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    Director
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    GibraltarBritish69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Director
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Director corporativo
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro6745658
    135316290001
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Secretario
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    GILBERT, Nicholas Jay
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    Secretario
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    British81344240001
    JOBBINS, Stuart
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    Secretario
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    British108146440001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Secretario
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    British58693930003
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Secretario designado corporativo
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006100001
    BELL, John Drummond
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish63940900001
    EVANS, Andreas Frederick
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    Director
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    United KingdomBritish9485290003
    EVANS, Dominic Redvers
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    British7095590001
    EVANS, Roderick Michael
    Oakhill House
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    Director
    Oakhill House
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    British40175270002
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Director
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    HORSBROUGH, Pauline Elizabeth
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    Director
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish4961270001
    MCKENDRICK, Charles
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    Director
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    United KingdomBritish173983190001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Director
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    United KingdomBritish58693930003
    TURNER, Philip Arthur
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    Director
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    British66424440001
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Director corporativo
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002
    TRAVERS SMITH LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Director designado corporativo
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006090001
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Director designado corporativo
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006100001

    ¿Tiene CASSEL PROPERTIES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Security agreement
    Creado el 05 sept 2007
    Entregado el 12 sept 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the all assets present and future including goodwill uncalled capital book debts buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Eurohypo Ag, London Branch
    Transacciones
    • 12 sept 2007Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 09 jun 1999
    Entregado el 14 jun 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Bradmarsh business park,temple row,rotherham. T/no SYK395251; land on the east side of millshaw ring road, beeston, leeds, t/no WYK582753 and WYK633485; land on the north side of university, boulevard, stockton on tees t/no CE137161.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 14 jun 1999Registro de un cargo (395)
    • 12 feb 2002Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 03 dic 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    • 27 jul 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment of performance bond
    Creado el 08 jul 1997
    Entregado el 10 jul 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The loan facility of £7,100,000 made available by the chargee to the company pursuant to a facility letter dated 6TH december 1996
    Breve descripción
    The benefit of a perforamce bond made 14TH may 1997 between gmi construction group PLC and de montfort insurance company PLC and the company in the sum of £354,995.
    Personas con derecho
    • Societe Generale
    Transacciones
    • 10 jul 1997Registro de un cargo (395)
    • 04 dic 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment of performance bond
    Creado el 18 jun 1997
    Entregado el 27 jun 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The loan facility of £7,100,000 made availible by the chargee to the company pursuant to a facility letter dated 6TH december 1996
    Breve descripción
    The benefit of a performance bond made 6TH may 1997 between gmi construction group PLC and de montfort insurance company PLC and the company in the sum of £393,490.
    Personas con derecho
    • Societe Generale
    Transacciones
    • 27 jun 1997Registro de un cargo (395)
    • 04 dic 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 18 jun 1997
    Entregado el 23 jun 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the facility letter dated 6 december 1996 in respect of loan facility of up to £7,100,000 and this charge
    Breve descripción
    The f/h land at barclay house,stockton upon tees.t/no.CE137161 and land at millshaw,leeds.t/no.WYK582753. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Societe Generaleas Agent for the Banks (As Defined)
    Transacciones
    • 23 jun 1997Registro de un cargo (395)
    • 08 may 1998Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 08 may 1998Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 04 dic 1999Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 11 abr 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0