NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED

NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaNORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02906527
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CHRYSALIS TELEVISION MIDLANDS LIMITED11 dic 200211 dic 2002
    CHRYSALIS ENTERTAINMENT LIMITED 02 mar 200102 mar 2001
    WATCHMAKER PRODUCTIONS LIMITED09 mar 199409 mar 1994

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 09 mar 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2015

    2 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 09 mar 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital14 mar 2016

    Estado de capital el 14 mar 2016

    • Capital: GBP 500,100
    SH01

    Cese del nombramiento de Robert John Johnston Brown como secretario el 12 nov 2015

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Robert John Johnston Brown como director el 12 nov 2015

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Ms Angela Mcmullen como secretario el 12 nov 2015

    2 páginasAP03

    Nombramiento de Ms Angela Mcmullen como director el 12 nov 2015

    2 páginasAP01

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2014

    2 páginasAA

    Cambio de datos del director Mrs Victoria Jane Turton el 25 ago 2015

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Ms Sara Kate Geater como director el 01 may 2015

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Robert John Johnston Brown como director el 30 abr 2015

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Robert John Johnston Brown como secretario el 30 abr 2015

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Neil Irvine Bright como director el 30 abr 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Neil Irvine Bright como secretario el 30 abr 2015

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 09 mar 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital09 mar 2015

    Estado de capital el 09 mar 2015

    • Capital: GBP 500,100
    SH01

    Cese del nombramiento de Stephen Roger Morrison como director el 24 sept 2014

    1 páginasTM01

    Exercice comptable en cours prolongé du 31 ago 2014 au 31 dic 2014

    1 páginasAA01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ago 2013

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 09 mar 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital17 mar 2014

    Estado de capital el 17 mar 2014

    • Capital: GBP 500,100
    SH01

    Nombramiento de Neil Irvine Bright como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Neil Irvine Bright como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Adam Jones como secretario

    1 páginasTM02

    ¿Quiénes son los directivos de NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MCMULLEN, Angela
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Secretario
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    202644090001
    GEATER, Sara Kate
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Director
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    EnglandBritish98319220002
    MCMULLEN, Angela
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Director
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    EnglandBritish202627200001
    TURTON, Victoria Jane
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Director
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    EnglandBritish46116480001
    BRIGHT, Neil Irvine
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Secretario
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    181020820001
    BROWN, Robert John Johnston
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Secretario
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    197749270001
    JONES, Adam Maxwell
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Secretario
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    156806080001
    PFEIL, John Christopher
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Secretario
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    British93412530001
    POTTERELL, Clive Ronald
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    Secretario
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    British3182530002
    CCS SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secretario designado corporativo
    120 East Road
    N1 6AA London
    900001720001
    MARYLEBONE SECRETARIES LIMITED
    Regina House
    124 Finchley Road
    NW3 5JS London
    Secretario corporativo
    Regina House
    124 Finchley Road
    NW3 5JS London
    36806500003
    BEDELL, Elaine Anne
    28 Malvern Road
    E8 3LP London
    Director
    28 Malvern Road
    E8 3LP London
    EnglandBritish40408170001
    BRIGHT, Neil Irvine
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Director
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    United KingdomBritish180993450001
    BROWN, Robert John Johnston
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Director
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    United KingdomBritish120406860001
    BURNS, Julian Delisle
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Director
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    United KingdomBritish17986720005
    BUTTERFIELD, Nigel Robert Adamson
    Bullrush Farm Hillgrove
    Lurgashall
    GU28 9EP Petworth
    West Sussex
    Director
    Bullrush Farm Hillgrove
    Lurgashall
    GU28 9EP Petworth
    West Sussex
    United KingdomBritish36186210001
    COLPANI, Paola
    Little Garth
    Crutches Lane, Jordans
    HP9 2TG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    Little Garth
    Crutches Lane, Jordans
    HP9 2TG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Italian68180770001
    DREWETT, Richard Searle
    67 Cole Park Road
    TW1 1HT Twickenham
    Middlesex
    Director
    67 Cole Park Road
    TW1 1HT Twickenham
    Middlesex
    British32319910001
    DUNCANSON, Neil Alexander
    3 The Fairway
    RM14 1BS Upminster
    Essex
    Director
    3 The Fairway
    RM14 1BS Upminster
    Essex
    EnglandBritish20540470002
    HANCOCK, Roger Thomas
    Bedford House 79 Marine Parade
    BN2 1AJ Brighton
    East Sussex
    Director
    Bedford House 79 Marine Parade
    BN2 1AJ Brighton
    East Sussex
    British15363800001
    JAMES, Clive Vivian
    536 Willoughby House
    Barbican
    EC2Y 8BN London
    Director
    536 Willoughby House
    Barbican
    EC2Y 8BN London
    British71516870002
    JONES, Adam Maxwell
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Director
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    United KingdomBritish124674500006
    LENTON, Paul Richard
    27 Great Bushey Drive
    Totteridge
    N20 8QN London
    Director
    27 Great Bushey Drive
    Totteridge
    N20 8QN London
    EnglandBritish82173510001
    MORRISON, Stephen Roger
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Director
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    United KingdomBritish63326820002
    NORTH, Norman Peter
    13a Bellevue Road
    SW17 7EG London
    Director
    13a Bellevue Road
    SW17 7EG London
    British43663740002
    PFEIL, John Christopher
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Director
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    EnglandBritish93412530001
    PILSWORTH, Michael John
    Glebe House
    Church Lane
    LU6 2DJ Eaton Bray
    Bedfordshire
    Director
    Glebe House
    Church Lane
    LU6 2DJ Eaton Bray
    Bedfordshire
    British82502160001
    SPURGEON, Christopher Nigel
    91 Lonsdale Road
    Barnes
    SW13 9DA London
    Director
    91 Lonsdale Road
    Barnes
    SW13 9DA London
    United KingdomBritish95569230001
    WOHLGEMUTH, John Richard Steven
    48d Primrose Hill Road
    NW3 3AA London
    Director
    48d Primrose Hill Road
    NW3 3AA London
    British38684180002
    CCS DIRECTORS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Director designado corporativo
    120 East Road
    N1 6AA London
    900001710001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Berkshire House
    United Kingdom
    06 abr 2016
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Berkshire House
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro02315596
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Supplemental deed
    Creado el 21 jun 2005
    Entregado el 09 jul 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each group company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 09 jul 2005Registro de un cargo (395)
    • 23 ene 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 29 ago 2003
    Entregado el 09 sept 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Chrysalis Group PLC
    Transacciones
    • 09 sept 2003Registro de un cargo (395)
    • 30 oct 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 29 ago 2003
    Entregado el 06 sept 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each group company to the chargee under the terms of the aformentioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 06 sept 2003Registro de un cargo (395)
    • 23 ene 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge
    Creado el 09 oct 1998
    Entregado el 13 oct 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and/or future indebtedness of the company to the chargee on any account in connection with the film project (as defined) and all other liabilities under the terms of the charge
    Breve descripción
    All of its rights title and interest in and to the following in relation to the film project in all media and in all territories throughout the world to the full extent of its interest therein as follows:- (a) all literary property and ancillary rights in relation to the film project.(b) all rights to lease licence sell or otherwise deal with and exploit all rights in the film project.(c) all contracts and contract rights,agreements for personal services or otherwise.(d) all other rights and properties acquired or to be acquired by the company in connection with the film project.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Northern Ireland Film Commission
    Transacciones
    • 13 oct 1998Registro de un cargo (395)
    • 05 ago 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creado el 17 jul 1995
    Entregado el 21 jul 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A fixed charge over all the "deposit(s)" referred to in the schedule. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 21 jul 1995Registro de un cargo (395)
    • 15 ago 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0