VALVE TRAIN COMPONENTS LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | VALVE TRAIN COMPONENTS LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02908669 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | Sí |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de VALVE TRAIN COMPONENTS LIMITED?
- forja, estampado, punzonado y conformado de metales; metalurgia de polvos (25500) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra VALVE TRAIN COMPONENTS LIMITED?
Dirección de la sede social | Charlotte House Stanier Way The Wyvern Business Park DE21 6BF Derby |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de VALVE TRAIN COMPONENTS LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
MARTIN & FIELD COMPONENTS LIMITED | 28 jun 1994 | 28 jun 1994 |
FORAY 659 LIMITED | 15 mar 1994 | 15 mar 1994 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de VALVE TRAIN COMPONENTS LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para VALVE TRAIN COMPONENTS LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 19 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 23 sept 2022 | 14 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 23 sept 2021 | 12 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Unit 9 Attwood Road, Zone 1 Burntwood Business Park Burntwood Staffordshire WS7 3GJ England a Charlotte House Stanier Way the Wyvern Business Park Derby DE21 6BF el 19 oct 2020 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de solvencia | 7 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 28 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Susan Boeding como director el 23 nov 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 26 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 25 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Charles Mellowes como director el 30 jun 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Thomas John Glaister como director el 01 jul 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 27 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Ringway Industrial Estate Eastern Avenue Lichfield Staffordshire WS13 7SF England a Unit 9 Attwood Road, Zone 1 Burntwood Business Park Burntwood Staffordshire WS7 3GJ el 11 mar 2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 ene 2016 avec liste complète des actionnaires | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Unit 9 Attwood Road Zone 1, Burntwood Business Park Burntwood Staffordshire WS7 3GJ a Ringway Industrial Estate Eastern Avenue Lichfield Staffordshire WS13 7SF el 26 feb 2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 ene 2015 avec liste complète des actionnaires | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 29 dic 2014
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de VALVE TRAIN COMPONENTS LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENDRES, Todd, Mr. | Secretario | West Glen Oaks Lane 53092 Mequon 1212 Wisconsin United States | 156725660001 | |||||||
ENDRES, Todd, Mr. | Director | West Glen Oaks Lane 53092 Mequon 1212 Wisconsin Usa | United States | American | Chief Financial Officer | 156730420001 | ||||
MELLOWES, John W, Ceo | Director | 1212 West Glen Oaks Lane 53092 Mequon 1212 West Glen Oaks Lane United States | United States | American | Ceo | 187151140001 | ||||
BROGDEN, William James | Secretario | Hopton Hall Hopton Wirksworth DE4 4DF Matlock Derbyshire | British | Dir/Sec | 32619040002 | |||||
COUPER, John Marvin | Secretario | 113865 W. Morningview Ct. FOREIGN New Berlin Wisconsin 53151 Usa | American | Chief Financial Officer | 117652750001 | |||||
GREW, Cedric Maurice | Secretario | 9 Orams Lane ST19 9EA Brewood Staffordshire | British | Director | 80645610001 | |||||
HALLINAN, Garry | Secretario | 18 Garnet Close Stonnall WS9 9EL Walsall Staffordshire | British | 47117500001 | ||||||
LEWIS, Daniele Claire | Secretario | 10 Newhall Street B3 3LX Birmingham | British | Solicitor | 39439930001 | |||||
MANDERS, Douglas Nigel | Secretario designado | 44 Beebee Road WS10 9RX Wednesbury West Midlands | British | 900003700001 | ||||||
MCDONALD, Ross Edward | Secretario | 115 Walsall Road Four Oaks B74 4NP Sutton Coldfield West Midlands | British | 44092870003 | ||||||
MEAD, Susan Irene | Secretario | 16 Moss Way B74 2BT Sutton Coldfield West Midlands | British | 68974200001 | ||||||
TANDY, Steven John | Secretario | The Laurels 38 Rowan Drive Handsacre WS15 4TQ Rugeley Staffordshire | English | Director | 58221120003 | |||||
BOEDING, Susan | Director | West Glen Oaks Lane 53092 Mequon 1212 Wisconsin Usa | United States | American | Vice President & General Manager | 176333940002 | ||||
BOWCOCK, David Norman | Director designado | 115 Humphrey Middlemore Drive Harborne Birmingham England | British | 900007760001 | ||||||
BRERETON, Gary | Director | 5 Nancy Talbot Close Ashbrook Lane WS15 3FD Abbots Bromley Rogeley Staffordshire | British | Director | 115516410001 | |||||
BROGDEN, Charles Robert | Director | 23 The Friary WS13 6QH Lichfield Staffordshire | British | Company Director | 13453400001 | |||||
BROGDEN, Charles Robert | Director | 23 The Friary WS13 6QH Lichfield Staffordshire | British | Company Director | 13453400001 | |||||
BROGDEN, William James | Director | Hopton Hall Hopton Wirksworth DE4 4DF Matlock Derbyshire | England | British | Chairman | 32619040002 | ||||
BROGDEN, William James | Director | Hopton Hall Hopton Wirksworth DE4 4DF Matlock Derbyshire | England | British | Company Director | 32619040002 | ||||
COUPER, John Marvin | Director | 113865 W. Morningview Ct. FOREIGN New Berlin Wisconsin 53151 Usa | Usa | American | Chief Financial Officer | 117652750001 | ||||
DAVIES, Graham Alan | Director | Hawthorn House Ironstone Road Rawnsley WS12 5QB Cannock Staffordshire | British | Company Director | 41565600001 | |||||
GIBBON, Robert Mervyn | Director | Windrush Wawensmere Road Wootton Wawen B95 6BN Henley In Arden Warwickshire | United Kingdom | British | Company Director | 122763130001 | ||||
GLAISTER, Thomas John | Director | 1212 West Glen Oaks Lane 53092 Mequon Charter Manufacturing Co., Inc. Wisconsin Usa | Usa | American | President And Chief Operating | 117652780002 | ||||
GREW, Cedric Maurice | Director | 9 Orams Lane ST19 9EA Brewood Staffordshire | British | Company Director | 80645610001 | |||||
HENDERSON, Peter John Thomas | Director | 7 East Gate ST19 9HY Brewood Staffordshire | England | British | Managing Director | 146053970001 | ||||
HENDERSON, Peter John Thomas | Director | 7 East Gate ST19 9HY Brewood Staffordshire | England | British | Manufacturing Director | 146053970001 | ||||
LEWIS, Daniele Claire | Director | 10 Newhall Street B3 3LX Birmingham | British | Solicitor | 39439930001 | |||||
MANDERS, Douglas Nigel | Director designado | 44 Beebee Road WS10 9RX Wednesbury West Midlands | British | 900003700001 | ||||||
MCDONALD, Ross Edward | Director | 115 Walsall Road Four Oaks B74 4NP Sutton Coldfield West Midlands | British | Chartered Secretary | 44092870003 | |||||
MELLOWES, Charles | Director | West Glen Oaks Lane 53092 Mequon 1212 Usa | Usa | American | Business Executive | 194228640001 | ||||
MELLOWES, John Allen | Director | 1212 West Glen Oaks Lane 53092 Mequon Charter Manufacturing Co., Inc. Wisconsin Usa | Usa | American | Chairman And Chief Executive O | 117652930002 | ||||
MURRAY, Peter Alan | Director | 352 Regatta Drive Port Washington Winconsin 53074 Usa | Usa | Canadian | Vice President & General Manag | 117652660001 | ||||
SHEPHERD, Peter David | Director | 10 Mirfield Road B91 1JD Solihull West Midlands | England | British | Accountant | 47155840001 | ||||
TANDY, Steven John | Director | The Laurels 38 Rowan Drive Handsacre WS15 4TQ Rugeley Staffordshire | English | Director | 58221120003 | |||||
TOMKINSON, Derek William | Director | 95 Main Road Wigginton B79 9DU Tamworth Staffordshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 60224840002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de VALVE TRAIN COMPONENTS LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charter Automotive Llc | 06 abr 2016 | 1212 W. Glen Oaks Lane 53092 Mequion Corporate Ozaukee United States | No | ||||
| |||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene VALVE TRAIN COMPONENTS LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Aircraft mortgage | Creado el 30 sept 2004 Entregado el 05 oct 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £232,318.13 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción Robinson R44 helicoptor registration mark g-valv serial number 1421. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage debenture | Creado el 04 jul 2001 Entregado el 11 jul 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Trust deed | Creado el 13 dic 1996 Entregado el 24 dic 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada The sum of £700,000 due or to become due from the company to the chargee; and to the stockholders (as defined); and all other monies due or to become due from the company to the stockholders | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Trust deed | Creado el 13 dic 1996 Entregado el 24 dic 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada The sum of £100,000 due or to become due from the company to the chargee; and to the stockholders (as defined); and all other monies due or to become due from the company to the stockholders | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage debenture | Creado el 25 ene 1995 Entregado el 06 feb 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
¿Tiene VALVE TRAIN COMPONENTS LIMITED algún caso de insolvencia?
Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0