VALVE TRAIN COMPONENTS LIMITED

VALVE TRAIN COMPONENTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaVALVE TRAIN COMPONENTS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02908669
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de VALVE TRAIN COMPONENTS LIMITED?

    • forja, estampado, punzonado y conformado de metales; metalurgia de polvos (25500) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra VALVE TRAIN COMPONENTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Charlotte House Stanier Way
    The Wyvern Business Park
    DE21 6BF Derby
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de VALVE TRAIN COMPONENTS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MARTIN & FIELD COMPONENTS LIMITED28 jun 199428 jun 1994
    FORAY 659 LIMITED15 mar 199415 mar 1994

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de VALVE TRAIN COMPONENTS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para VALVE TRAIN COMPONENTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    19 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 23 sept 2022

    14 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 23 sept 2021

    12 páginasLIQ03

    Domicilio social registrado cambiado de Unit 9 Attwood Road, Zone 1 Burntwood Business Park Burntwood Staffordshire WS7 3GJ England a Charlotte House Stanier Way the Wyvern Business Park Derby DE21 6BF el 19 oct 2020

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 24 sept 2020

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    7 páginasLIQ01

    Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    28 páginasAA

    Cese del nombramiento de Susan Boeding como director el 23 nov 2018

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    26 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    25 páginasAA

    Cese del nombramiento de Charles Mellowes como director el 30 jun 2017

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Thomas John Glaister como director el 01 jul 2016

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    27 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de Ringway Industrial Estate Eastern Avenue Lichfield Staffordshire WS13 7SF England a Unit 9 Attwood Road, Zone 1 Burntwood Business Park Burntwood Staffordshire WS7 3GJ el 11 mar 2016

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 31 ene 2016 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital26 feb 2016

    Estado de capital el 26 feb 2016

    • Capital: GBP 500,000
    SH01

    Domicilio social registrado cambiado de Unit 9 Attwood Road Zone 1, Burntwood Business Park Burntwood Staffordshire WS7 3GJ a Ringway Industrial Estate Eastern Avenue Lichfield Staffordshire WS13 7SF el 26 feb 2016

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    18 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 ene 2015 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital09 feb 2015

    Estado de capital el 09 feb 2015

    • Capital: GBP 3,723,117
    SH01

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 29 dic 2014

    • Capital: GBP 3,723,117
    3 páginasSH01

    ¿Quiénes son los directivos de VALVE TRAIN COMPONENTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ENDRES, Todd, Mr.
    West Glen Oaks Lane
    53092 Mequon
    1212
    Wisconsin
    United States
    Secretario
    West Glen Oaks Lane
    53092 Mequon
    1212
    Wisconsin
    United States
    156725660001
    ENDRES, Todd, Mr.
    West Glen Oaks Lane
    53092 Mequon
    1212
    Wisconsin
    Usa
    Director
    West Glen Oaks Lane
    53092 Mequon
    1212
    Wisconsin
    Usa
    United StatesAmericanChief Financial Officer156730420001
    MELLOWES, John W, Ceo
    1212 West Glen Oaks Lane
    53092 Mequon
    1212 West Glen Oaks Lane
    United States
    Director
    1212 West Glen Oaks Lane
    53092 Mequon
    1212 West Glen Oaks Lane
    United States
    United StatesAmericanCeo187151140001
    BROGDEN, William James
    Hopton Hall
    Hopton Wirksworth
    DE4 4DF Matlock
    Derbyshire
    Secretario
    Hopton Hall
    Hopton Wirksworth
    DE4 4DF Matlock
    Derbyshire
    BritishDir/Sec32619040002
    COUPER, John Marvin
    113865 W. Morningview Ct.
    FOREIGN New Berlin
    Wisconsin 53151
    Usa
    Secretario
    113865 W. Morningview Ct.
    FOREIGN New Berlin
    Wisconsin 53151
    Usa
    AmericanChief Financial Officer117652750001
    GREW, Cedric Maurice
    9 Orams Lane
    ST19 9EA Brewood
    Staffordshire
    Secretario
    9 Orams Lane
    ST19 9EA Brewood
    Staffordshire
    BritishDirector80645610001
    HALLINAN, Garry
    18 Garnet Close
    Stonnall
    WS9 9EL Walsall
    Staffordshire
    Secretario
    18 Garnet Close
    Stonnall
    WS9 9EL Walsall
    Staffordshire
    British47117500001
    LEWIS, Daniele Claire
    10 Newhall Street
    B3 3LX Birmingham
    Secretario
    10 Newhall Street
    B3 3LX Birmingham
    BritishSolicitor39439930001
    MANDERS, Douglas Nigel
    44 Beebee Road
    WS10 9RX Wednesbury
    West Midlands
    Secretario designado
    44 Beebee Road
    WS10 9RX Wednesbury
    West Midlands
    British900003700001
    MCDONALD, Ross Edward
    115 Walsall Road
    Four Oaks
    B74 4NP Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secretario
    115 Walsall Road
    Four Oaks
    B74 4NP Sutton Coldfield
    West Midlands
    British44092870003
    MEAD, Susan Irene
    16 Moss Way
    B74 2BT Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secretario
    16 Moss Way
    B74 2BT Sutton Coldfield
    West Midlands
    British68974200001
    TANDY, Steven John
    The Laurels 38 Rowan Drive
    Handsacre
    WS15 4TQ Rugeley
    Staffordshire
    Secretario
    The Laurels 38 Rowan Drive
    Handsacre
    WS15 4TQ Rugeley
    Staffordshire
    EnglishDirector58221120003
    BOEDING, Susan
    West Glen Oaks Lane
    53092 Mequon
    1212
    Wisconsin
    Usa
    Director
    West Glen Oaks Lane
    53092 Mequon
    1212
    Wisconsin
    Usa
    United StatesAmericanVice President & General Manager176333940002
    BOWCOCK, David Norman
    115 Humphrey Middlemore Drive
    Harborne
    Birmingham
    England
    Director designado
    115 Humphrey Middlemore Drive
    Harborne
    Birmingham
    England
    British900007760001
    BRERETON, Gary
    5 Nancy Talbot Close
    Ashbrook Lane
    WS15 3FD Abbots Bromley Rogeley
    Staffordshire
    Director
    5 Nancy Talbot Close
    Ashbrook Lane
    WS15 3FD Abbots Bromley Rogeley
    Staffordshire
    BritishDirector115516410001
    BROGDEN, Charles Robert
    23 The Friary
    WS13 6QH Lichfield
    Staffordshire
    Director
    23 The Friary
    WS13 6QH Lichfield
    Staffordshire
    BritishCompany Director13453400001
    BROGDEN, Charles Robert
    23 The Friary
    WS13 6QH Lichfield
    Staffordshire
    Director
    23 The Friary
    WS13 6QH Lichfield
    Staffordshire
    BritishCompany Director13453400001
    BROGDEN, William James
    Hopton Hall
    Hopton Wirksworth
    DE4 4DF Matlock
    Derbyshire
    Director
    Hopton Hall
    Hopton Wirksworth
    DE4 4DF Matlock
    Derbyshire
    EnglandBritishChairman32619040002
    BROGDEN, William James
    Hopton Hall
    Hopton Wirksworth
    DE4 4DF Matlock
    Derbyshire
    Director
    Hopton Hall
    Hopton Wirksworth
    DE4 4DF Matlock
    Derbyshire
    EnglandBritishCompany Director32619040002
    COUPER, John Marvin
    113865 W. Morningview Ct.
    FOREIGN New Berlin
    Wisconsin 53151
    Usa
    Director
    113865 W. Morningview Ct.
    FOREIGN New Berlin
    Wisconsin 53151
    Usa
    UsaAmericanChief Financial Officer117652750001
    DAVIES, Graham Alan
    Hawthorn House Ironstone Road
    Rawnsley
    WS12 5QB Cannock
    Staffordshire
    Director
    Hawthorn House Ironstone Road
    Rawnsley
    WS12 5QB Cannock
    Staffordshire
    BritishCompany Director41565600001
    GIBBON, Robert Mervyn
    Windrush
    Wawensmere Road Wootton Wawen
    B95 6BN Henley In Arden
    Warwickshire
    Director
    Windrush
    Wawensmere Road Wootton Wawen
    B95 6BN Henley In Arden
    Warwickshire
    United KingdomBritishCompany Director122763130001
    GLAISTER, Thomas John
    1212 West Glen Oaks Lane
    53092 Mequon
    Charter Manufacturing Co., Inc.
    Wisconsin
    Usa
    Director
    1212 West Glen Oaks Lane
    53092 Mequon
    Charter Manufacturing Co., Inc.
    Wisconsin
    Usa
    UsaAmericanPresident And Chief Operating117652780002
    GREW, Cedric Maurice
    9 Orams Lane
    ST19 9EA Brewood
    Staffordshire
    Director
    9 Orams Lane
    ST19 9EA Brewood
    Staffordshire
    BritishCompany Director80645610001
    HENDERSON, Peter John Thomas
    7 East Gate
    ST19 9HY Brewood
    Staffordshire
    Director
    7 East Gate
    ST19 9HY Brewood
    Staffordshire
    EnglandBritishManaging Director146053970001
    HENDERSON, Peter John Thomas
    7 East Gate
    ST19 9HY Brewood
    Staffordshire
    Director
    7 East Gate
    ST19 9HY Brewood
    Staffordshire
    EnglandBritishManufacturing Director146053970001
    LEWIS, Daniele Claire
    10 Newhall Street
    B3 3LX Birmingham
    Director
    10 Newhall Street
    B3 3LX Birmingham
    BritishSolicitor39439930001
    MANDERS, Douglas Nigel
    44 Beebee Road
    WS10 9RX Wednesbury
    West Midlands
    Director designado
    44 Beebee Road
    WS10 9RX Wednesbury
    West Midlands
    British900003700001
    MCDONALD, Ross Edward
    115 Walsall Road
    Four Oaks
    B74 4NP Sutton Coldfield
    West Midlands
    Director
    115 Walsall Road
    Four Oaks
    B74 4NP Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishChartered Secretary44092870003
    MELLOWES, Charles
    West Glen Oaks Lane
    53092 Mequon
    1212
    Usa
    Director
    West Glen Oaks Lane
    53092 Mequon
    1212
    Usa
    UsaAmericanBusiness Executive194228640001
    MELLOWES, John Allen
    1212 West Glen Oaks Lane
    53092 Mequon
    Charter Manufacturing Co., Inc.
    Wisconsin
    Usa
    Director
    1212 West Glen Oaks Lane
    53092 Mequon
    Charter Manufacturing Co., Inc.
    Wisconsin
    Usa
    UsaAmericanChairman And Chief Executive O117652930002
    MURRAY, Peter Alan
    352 Regatta Drive
    Port Washington
    Winconsin 53074
    Usa
    Director
    352 Regatta Drive
    Port Washington
    Winconsin 53074
    Usa
    UsaCanadianVice President & General Manag117652660001
    SHEPHERD, Peter David
    10 Mirfield Road
    B91 1JD Solihull
    West Midlands
    Director
    10 Mirfield Road
    B91 1JD Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishAccountant47155840001
    TANDY, Steven John
    The Laurels 38 Rowan Drive
    Handsacre
    WS15 4TQ Rugeley
    Staffordshire
    Director
    The Laurels 38 Rowan Drive
    Handsacre
    WS15 4TQ Rugeley
    Staffordshire
    EnglishDirector58221120003
    TOMKINSON, Derek William
    95 Main Road
    Wigginton
    B79 9DU Tamworth
    Staffordshire
    Director
    95 Main Road
    Wigginton
    B79 9DU Tamworth
    Staffordshire
    United KingdomBritishChartered Accountant60224840002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de VALVE TRAIN COMPONENTS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Charter Automotive Llc
    1212 W. Glen Oaks Lane
    53092 Mequion
    Corporate
    Ozaukee
    United States
    06 abr 2016
    1212 W. Glen Oaks Lane
    53092 Mequion
    Corporate
    Ozaukee
    United States
    No
    Forma jurídicaLimited Liability Company
    Autoridad legalWisconsin Limited Liability Company Act
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene VALVE TRAIN COMPONENTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Aircraft mortgage
    Creado el 30 sept 2004
    Entregado el 05 oct 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £232,318.13 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Robinson R44 helicoptor registration mark g-valv serial number 1421. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lombard North Central PLC
    Transacciones
    • 05 oct 2004Registro de un cargo (395)
    • 16 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 04 jul 2001
    Entregado el 11 jul 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 11 jul 2001Registro de un cargo (395)
    • 01 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Trust deed
    Creado el 13 dic 1996
    Entregado el 24 dic 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The sum of £700,000 due or to become due from the company to the chargee; and to the stockholders (as defined); and all other monies due or to become due from the company to the stockholders
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • William James Brogden and Charles Robert Brogden ("the Trustee")
    Transacciones
    • 24 dic 1996Registro de un cargo (395)
    • 16 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Trust deed
    Creado el 13 dic 1996
    Entregado el 24 dic 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The sum of £100,000 due or to become due from the company to the chargee; and to the stockholders (as defined); and all other monies due or to become due from the company to the stockholders
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • William James Brogden and Charles Robert Brogden ("the Trustees")
    Transacciones
    • 24 dic 1996Registro de un cargo (395)
    • 16 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 25 ene 1995
    Entregado el 06 feb 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 06 feb 1995Registro de un cargo (395)
    • 17 may 1995Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 05 oct 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene VALVE TRAIN COMPONENTS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    24 sept 2020Inicio de la liquidación
    03 oct 2023Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Martin Frederick Peter Smith
    Charlotte House Stainer Way
    The Wyvern Business Park
    DE21 6BF Derby
    Profesional
    Charlotte House Stainer Way
    The Wyvern Business Park
    DE21 6BF Derby
    Nicola Joanne Meadows
    Charlotte House Stanier Way
    The Wyvern Business Park
    DE21 9LH Derby
    Profesional
    Charlotte House Stanier Way
    The Wyvern Business Park
    DE21 9LH Derby

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0