THALES INFORMATION SYSTEMS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | THALES INFORMATION SYSTEMS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02937836 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de THALES INFORMATION SYSTEMS LIMITED?
- Otras actividades de servicios de tecnología de la información (62090) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra THALES INFORMATION SYSTEMS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 350 Longwater Avenue Green Park RG2 6GF Reading Berkshire United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de THALES INFORMATION SYSTEMS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| SYSECA LIMITED | 01 jul 1996 | 01 jul 1996 |
| FERRANTI SYSECA LIMITED | 29 jul 1994 | 29 jul 1994 |
| BLUELOCK LIMITED | 10 jun 1994 | 10 jun 1994 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de THALES INFORMATION SYSTEMS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para THALES INFORMATION SYSTEMS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 10 jun 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark David Hearn como director el 03 may 2017 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Michael William Peter Seabrook el 02 ago 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 10 jun 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Notification de Thales Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark David Hearn como director el 12 may 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mark David Hearn como director el 03 may 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 2 Dashwood Lang Road the Bourne Business Park Addlestone Weybridge Surrey KT15 2NX a 350 Longwater Avenue Green Park Reading Berkshire RG2 6GF el 09 may 2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark David Hearn como director el 03 may 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Ewen Angus Mccrorie como director el 03 may 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Peter Murphy como director el 03 may 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Michael William Peter Seabrook como director el 03 may 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 10 jun 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 26 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 10 jun 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 43 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 10 jun 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 04 dic 2013
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de THALES INFORMATION SYSTEMS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEABROOK, Michael William Peter | Secretario | Longwater Avenue Green Park RG2 6GF Reading 350 Berkshire United Kingdom | British | 70900110002 | ||||||
| MCCRORIE, Ewen Angus | Director | Longwater Avenue Green Park RG2 6GF Reading 350 Berkshire United Kingdom | Scotland | British | 93611530001 | |||||
| SEABROOK, Michael William Peter | Director | Longwater Avenue Green Park RG2 6GF Reading 350 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 70900110004 | |||||
| HAAGEN, Jean Yves Bernard Francois | Secretario | Greenbanks Pewley Point Pewley Hill GU1 3SP Guildford Surrey | French | 72580730001 | ||||||
| HANDLEY, James Edward | Secretario | 97 Shackstead Lane GU7 1RL Godalming Surrey | British | 64888090001 | ||||||
| MITCHELL, Alastair James | Secretario | 14 Harvest Close SO22 4DW Winchester Hampshire | British | 14840450001 | ||||||
| PARMENTER, Martin David, Mr. | Secretario | Cherrywood 4 Keymer Gardens RH15 0AF Burgess Hill West Sussex | British | 14344050002 | ||||||
| TAWNEY, Christopher | Secretario | 13 Titchwell Road SW18 3LW London | British | 19822860002 | ||||||
| LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Secretario designado corporativo | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||
| ALDRIN, Olivier Daniel | Director | 24 Rue Paul Bert Suresnes 92150 France | French | 67341520001 | ||||||
| ASBEE, Brian Charles Arthur | Director | The Hollies Townside HP17 8BG Haddenham Berkshire | British | 25535010001 | ||||||
| AUGENDRE, Thierry | Director | 7 Rue Paul Barruel FOREIGN Paris 75025 France | French | 98949970001 | ||||||
| AUGENDRE, Thierry | Director | 91 Rue De C Abbe Groult Paris France 75015 | French | 40906340001 | ||||||
| BALDWIN, David Hamilton | Director | 2 Dashwood Lang Road The Bourne Business Park KT15 2NX Addlestone Weybridge Surrey | United Kingdom | British | 136371820001 | |||||
| BARRATT, Justin Stephen Richard | Director | 2 Dashwood Lang Road The Bourne Business Park KT15 2NX Addlestone Weybridge Surrey | British | 95835340002 | ||||||
| BATLEY, Peter Thomas | Director | Elm Grove Chaddesden DE21 6SF Derby 22 Derbyshire | United Kingdom | British | 80368510001 | |||||
| BUSBY, Mark Gordon | Director | 2 Dashwood Lang Road The Bourne Business Park KT15 2NX Addlestone Weybridge Surrey | United Kingdom | British | 147432090001 | |||||
| CHEVALIER, Jean Luc | Director | 17 Rue Saint-Louis Saint-Germain-En-Laye 78100 France | French | 101108380001 | ||||||
| DAVIES, William Rees | Director | 25 Park Road SM3 8PY Sutton Surrey | British | 65040460001 | ||||||
| DE POURTALES, Edouard | Director | 82 Boulevard Malesherbes FOREIGN 75008 Paris France | French | 49229270001 | ||||||
| DUPLAIX, Christine | Director | 34 Rue Paul Doumer 78140 Velizy France | French | 45405080001 | ||||||
| HEARN, Mark David | Director | Longwater Avenue Green Park RG2 6GF Reading 350 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 73186160002 | |||||
| HEARN, Mark David | Director | 2 Dashwood Lang Road The Bourne Business Park KT15 2NX Addlestone Weybridge Surrey | United Kingdom | British | 73186160002 | |||||
| HILL, Stephen George | Director | Scures Hill RG27 9JR Nately Scures Freshfields House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 171525960001 | |||||
| HOURCADE, Jean Charles | Director | 45 Rue Du Chateau D Eau Paris France FOREIGN 75010 | Frenchh | 40906490002 | ||||||
| KING, Andrew William | Director | 2 Dashwood Lang Road The Bourne Business Park KT15 2NX Addlestone Weybridge Surrey | England | British | 155303150001 | |||||
| LEPEYTRE, Jean Paul | Director | 8bis Rue Pierre Curie Igny 94430 France | French | 76695280001 | ||||||
| LOCKWOOD, David Charles | Director | 2 Dashwood Lang Road The Bourne Business Park KT15 2NX Addlestone Weybridge Surrey | England | British | 69836380002 | |||||
| MEAU, Jean-Christophe Michel | Director | Pavillion 43, Residence Corneille 80 Rie Corneille Le Chesnay 78150 France | French | 133395450001 | ||||||
| MITCHELL, Alastair James | Director | 14 Harvest Close SO22 4DW Winchester Hampshire | British | 14840450001 | ||||||
| MURPHY, John Peter | Director | 2 Dashwood Lang Road The Bourne Business Park KT15 2NX Addlestone Weybridge Surrey | England | Irish | 108840190001 | |||||
| PORTER, Martin Timothy | Director | Oak Tree House Withinlee Road Mottram St Andrew SK10 4AU Macclesfield Cheshire | England | British | 44521900001 | |||||
| PRICE, David John | Director | Ashe Hill Ashe RG25 3AE Basingstoke Hampshire | United Kingdom | British | 75259760004 | |||||
| ROUSSEL, Didier | Director | 110 Chemin De La Cote Du Moulin FOREIGN Letang La Ville 78620 France | British | 40906540001 | ||||||
| SEABROOK, Michael William Peter | Director | 40 Horsell Park Close Horsell GU21 4LZ Woking Surrey | United Kingdom | British | 70900110002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de THALES INFORMATION SYSTEMS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thales Uk Limited | 06 abr 2016 | Longwater Avenue RG2 6GF Reading 350 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0