VHE EQUIPMENT SERVICES LIMITED

VHE EQUIPMENT SERVICES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaVHE EQUIPMENT SERVICES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02939633
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de VHE EQUIPMENT SERVICES LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra VHE EQUIPMENT SERVICES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    3175 Century Way
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de VHE EQUIPMENT SERVICES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SHAFTON ENGINEERING SERVICES LIMITED11 jul 199411 jul 1994
    SOUNDTEST LIMITED16 jun 199416 jun 1994

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de VHE EQUIPMENT SERVICES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2022

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para VHE EQUIPMENT SERVICES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    5 páginasDS01

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10
    resolution

    Resolución de capitalización o emisión de acciones de bonificación

    The sum of £24604 be capitalised 13/07/2023
    RES14

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    resolution

    Resolución de capitalización o emisión de acciones de bonificación

    Capitalise sum of £31564 12/07/2023
    RES14
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10

    Estado de capital el 14 jul 2023

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 13 jul 2023

    • Capital: GBP 24,605
    3 páginasSH01

    Estado de capital el 13 jul 2023

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 12 jul 2023

    • Capital: GBP 31,565
    3 páginasSH01

    Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2022

    5 páginasAA

    Cambio de datos del director Renew Corporate Director Limited el 01 oct 2019

    1 páginasCH02

    Cambio de datos del secretario Renew Nominees Limited el 01 oct 2019

    1 páginasCH04

    Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 8

    4 páginasMR04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2021

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2020

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de VHE EQUIPMENT SERVICES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    RENEW NOMINEES LIMITED
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    3175 Century Way
    England
    Secretario corporativo
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    3175 Century Way
    England
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro02939633
    41291250014
    SCOTT, Paul
    Century Way
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    3175
    England
    Director
    Century Way
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    3175
    England
    EnglandBritish63708460003
    WILSON, Gordon Ian
    Century Way
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    3175
    England
    Director
    Century Way
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    3175
    England
    United KingdomBritish263424170001
    RENEW CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    3175 Century Way
    England
    Director corporativo
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    3175 Century Way
    England
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro4843611
    91993060004
    BARKER, Roger Winston
    24 Burn Bridge Oval
    HG3 1LP Harrogate
    North Yorkshire
    Secretario
    24 Burn Bridge Oval
    HG3 1LP Harrogate
    North Yorkshire
    British59419910001
    GREASLEY, Antony Frederick
    Padside Hall
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    North Yorkshire
    Secretario
    Padside Hall
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    North Yorkshire
    British69165360001
    LITTLEHALES, Richard
    10 Oaklands Avenue
    Adel
    LS16 8NR Leeds
    West Yorkshire
    Secretario
    10 Oaklands Avenue
    Adel
    LS16 8NR Leeds
    West Yorkshire
    British57288230001
    PARKINSON, John
    Pinewoods Larchwood
    Scarcroft
    LS14 3BN Leeds
    West Yorkshire
    Secretario
    Pinewoods Larchwood
    Scarcroft
    LS14 3BN Leeds
    West Yorkshire
    British10307790002
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Secretario designado corporativo
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    BARKER, Roger Winston
    24 Burn Bridge Oval
    HG3 1LP Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    24 Burn Bridge Oval
    HG3 1LP Harrogate
    North Yorkshire
    British59419910001
    FEAST, Roger
    43 Merchant Court
    61 Wapping Wall
    E1W 3SJ London
    Director
    43 Merchant Court
    61 Wapping Wall
    E1W 3SJ London
    British66800550001
    GREASLEY, Antony Frederick
    Padside Hall
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    Padside Hall
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish69165360001
    LITTLEHALES, Richard
    Aisling Cottage
    Back Church Lane
    LS16 8DW Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Aisling Cottage
    Back Church Lane
    LS16 8DW Leeds
    West Yorkshire
    British57288230002
    MCARTHUR, Alexander Nigel
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    Director
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    British1571200002
    PARKINSON, John
    Pinewoods Larchwood
    Scarcroft
    LS14 3BN Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Pinewoods Larchwood
    Scarcroft
    LS14 3BN Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish10307790002
    PEARSON, Valerie
    Phoenix House
    Hawthorn Park
    LS14 1PQ Leeds
    Director
    Phoenix House
    Hawthorn Park
    LS14 1PQ Leeds
    British82999480006
    SAMUEL, John William Young Strachan
    Charnwood Easby Drive
    LS29 9AZ Ilkley
    West Yorkshire
    Director
    Charnwood Easby Drive
    LS29 9AZ Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritish3909060002
    STIFF, Stephen
    Century Way
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    3175
    England
    Director
    Century Way
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    3175
    England
    United KingdomBritish111161720001
    THOMSON, Brian Malcolm
    Amber Manor Farm
    Alice Head Road Stonedge
    S45 0DQ Ashover
    Derbyshire
    Director
    Amber Manor Farm
    Alice Head Road Stonedge
    S45 0DQ Ashover
    Derbyshire
    British5774340006
    UNDERWOOD, Philip John
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Director
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    British59420330011
    WALDRON, Brian Geoffrey
    Fir Tree Cottage 4 Chapel Lane
    Billingley
    S72 0HZ Barnsley
    South Yorkshire
    Director
    Fir Tree Cottage 4 Chapel Lane
    Billingley
    S72 0HZ Barnsley
    South Yorkshire
    GibraltarBritish4324630001
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Director designado corporativo
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de VHE EQUIPMENT SERVICES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    Yew Trees
    West Yorkshire
    United Kingdom
    01 ago 2016
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    Yew Trees
    West Yorkshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaPublic Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalUnited Kingdom (England)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro1457182
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene VHE EQUIPMENT SERVICES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee & debenture
    Creado el 03 oct 2007
    Entregado el 19 oct 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 19 oct 2007Registro de un cargo (395)
    • 23 mar 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 05 ene 2005
    Entregado el 20 ene 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 20 ene 2005Registro de un cargo (395)
    • 02 jul 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 02 jul 1996
    Entregado el 09 jul 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £237,222 and all other sums due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The items set out in the schedule to form 395 together with all accessories spare parts component parts and all improvements and renewals thereof and all books manuals and handbooks.
    Personas con derecho
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transacciones
    • 09 jul 1996Registro de un cargo (395)
    • 10 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 03 jun 1996
    Entregado el 13 jun 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a land on the east side of engine lane shafton near barnsley south yorks and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 13 jun 1996Registro de un cargo (395)
    • 02 jul 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creado el 21 sept 1995
    Entregado el 27 sept 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All the plant machinery chattels or other equipment listed in the scedule to the form 395 inclusive of kue ken 114 serial no. M819, kue ken 114 serial no. M4820 and kue ken 120 serial no. M4839 together with any parts thereof and all additions and alterations etc. thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Yorkshire Bank PLC
    Transacciones
    • 27 sept 1995Registro de un cargo (395)
    • 10 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 06 jul 1995
    Entregado el 11 jul 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £584,676 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Various goods including all books manuals handbooks technical date drawings etc belonging to the goods as set out in the schedule to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transacciones
    • 11 jul 1995Registro de un cargo (395)
    • 10 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 23 sept 1994
    Entregado el 06 oct 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 06 oct 1994Registro de un cargo (395)
    • 02 jul 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 23 sept 1994
    Entregado el 06 oct 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/as shafton workshops, shafton, barnsley, south yorkshire t/no SYK44893.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 06 oct 1994Registro de un cargo (395)
    • 02 jul 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0