HOME CARE SERVICES (KENT) LIMITED

HOME CARE SERVICES (KENT) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHOME CARE SERVICES (KENT) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02941943
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HOME CARE SERVICES (KENT) LIMITED?

    • Otras actividades de asistencia sanitaria (86900) / Actividades sanitarias y de asistencia social
    • Otras actividades de servicios n.c.p. (96090) / Otras actividades de servicios

    ¿Dónde se encuentra HOME CARE SERVICES (KENT) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Connaught House
    The Crescent Colchester
    CO4 9QB Business Park Colchester
    Essex
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HOME CARE SERVICES (KENT) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HOME CARE SERVICES (KENT) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 23 jun 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital03 jul 2012

    Estado de capital el 03 jul 2012

    • Capital: GBP 987.5
    SH01

    Cese del nombramiento de Angela Culhane como director el 25 jun 2012

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2011

    17 páginasAA

    Nombramiento de Jonathan David Calow como secretario el 08 dic 2011

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Care Uk Services Limited como secretario el 08 dic 2011

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 23 jun 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2010

    18 páginasAA

    Nombramiento de Paul John Watson como director

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del director Michael Robert Parish el 10 ago 2010

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 23 jun 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cambio de datos del director Paul Justin Humphreys el 01 jun 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Michael Robert Parish el 01 jun 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Care Uk Services Limited el 01 jun 2010

    2 páginasCH04

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación del Memorándum de Asociación

    RES01

    legacy

    28 páginasMG01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2009

    17 páginasAA

    Nombramiento de Deborah Jane Marriott-Boam como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Geoffrey Benn como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Douglas Umbers como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Angela Hector Culhane como director

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de HOME CARE SERVICES (KENT) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CALOW, Jonathan David
    Connaught House
    The Crescent Colchester
    CO4 9QB Business Park Colchester
    Essex
    Secretario
    Connaught House
    The Crescent Colchester
    CO4 9QB Business Park Colchester
    Essex
    165497840001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    Connaught House
    The Crescent Colchester
    CO4 9QB Business Park Colchester
    Essex
    Director
    Connaught House
    The Crescent Colchester
    CO4 9QB Business Park Colchester
    Essex
    United KingdomBritish33223550003
    MARRIOTT-BOAM, Deborah Jane
    Connaught House
    The Crescent Colchester
    CO4 9QB Business Park Colchester
    Essex
    Director
    Connaught House
    The Crescent Colchester
    CO4 9QB Business Park Colchester
    Essex
    United KingdomBritish151689670001
    PARISH, Michael Robert
    Connaught House
    The Crescent Colchester
    CO4 9QB Business Park Colchester
    Essex
    Director
    Connaught House
    The Crescent Colchester
    CO4 9QB Business Park Colchester
    Essex
    EnglandBritish78828750003
    WATSON, Paul John
    Connaught House
    The Crescent Colchester
    CO4 9QB Business Park Colchester
    Essex
    Director
    Connaught House
    The Crescent Colchester
    CO4 9QB Business Park Colchester
    Essex
    United KingdomBritish82460360003
    BYARD, Michael Edwin
    33 Preston Parade
    Seasalter
    CT5 4AD Whitstable
    Kent
    Secretario
    33 Preston Parade
    Seasalter
    CT5 4AD Whitstable
    Kent
    British27785530003
    HUMPHREYS, Paul Justin
    Hall Barn Creeting Hall Farm
    Creeting Saint Peter
    IP6 8QZ Ipswich
    Suffolk
    Secretario
    Hall Barn Creeting Hall Farm
    Creeting Saint Peter
    IP6 8QZ Ipswich
    Suffolk
    British33223550003
    TAYLOR, Ann
    27 Maple Avenue
    ME16 0DB Maidstone
    Kent
    Secretario
    27 Maple Avenue
    ME16 0DB Maidstone
    Kent
    British63482920002
    CARE UK SERVICES LIMITED
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro2482660
    125332040002
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secretario designado corporativo
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BENN, Geoffrey Richard
    15 Mimosa Close
    CM1 6NW Chelmsford
    Essex
    Director
    15 Mimosa Close
    CM1 6NW Chelmsford
    Essex
    EnglandBritish73786580001
    BOOKER, Roger Ian
    Fairview
    17a Queens Road
    WA15 9HF Hale
    Cheshire
    Director
    Fairview
    17a Queens Road
    WA15 9HF Hale
    Cheshire
    United KingdomBritish14044530003
    BYARD, Lesley Ann Elizabeth
    33 Preston Parade
    Seasalter
    CT5 4AD Whitstable
    Kent
    Director
    33 Preston Parade
    Seasalter
    CT5 4AD Whitstable
    Kent
    British95062480001
    BYARD, Michael Edwin
    33 Preston Parade
    Seasalter
    CT5 4AD Whitstable
    Kent
    Director
    33 Preston Parade
    Seasalter
    CT5 4AD Whitstable
    Kent
    British27785530003
    CRIPPS, Nigel John
    Culverlands
    48 Ham Shades Lane
    CT5 1NX Whitstable
    Kent
    Director
    Culverlands
    48 Ham Shades Lane
    CT5 1NX Whitstable
    Kent
    United KingdomBritish69102100001
    CULHANE, Angela
    Connaught House
    The Crescent Colchester
    CO4 9QB Business Park Colchester
    Essex
    Director
    Connaught House
    The Crescent Colchester
    CO4 9QB Business Park Colchester
    Essex
    EnglandBritish68602910001
    HASTINGS, Roy
    Wallis Road
    RG21 3DN Basingstoke
    20
    Hampshire
    Director
    Wallis Road
    RG21 3DN Basingstoke
    20
    Hampshire
    United KingdomBritish130098430001
    KING, John Stewart
    136b Ashford Road
    Bearsted
    ME14 4NA Maidstone
    Kent
    Director
    136b Ashford Road
    Bearsted
    ME14 4NA Maidstone
    Kent
    British67938600002
    QUINN, David Laurence, Mr.
    6 Whitecross Road
    HP17 8BA Haddenham
    Buckinghamshire
    Director
    6 Whitecross Road
    HP17 8BA Haddenham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish123356660001
    RICHARDSON, Mark John
    7 Ruskins View
    CT6 7AE Herne Bay
    Kent
    Director
    7 Ruskins View
    CT6 7AE Herne Bay
    Kent
    United KingdomBritish95705320001
    SCUTT, Susan Ann
    39 Woodlea
    Leybourne
    ME19 5QY West Malling
    Kent
    Director
    39 Woodlea
    Leybourne
    ME19 5QY West Malling
    Kent
    British39682480001
    TAYLOR, Ann
    27 Maple Avenue
    ME16 0DB Maidstone
    Kent
    Director
    27 Maple Avenue
    ME16 0DB Maidstone
    Kent
    EnglandBritish63482920002
    TEMPLE, Norman Edward
    The Dingle North Foreland Avenue
    CT10 3QR Broadstairs
    Kent
    Director
    The Dingle North Foreland Avenue
    CT10 3QR Broadstairs
    Kent
    EnglandBritish30220700001
    UMBERS, Douglas
    SO53
    Director
    SO53
    United KingdomBritish90541690001
    VOCKINS, Anthony Frederick
    4 Main Street
    Croxton Kerrial
    NG32 1QF Grantham
    The Old Post Office
    Lincolnshire
    Director
    4 Main Street
    Croxton Kerrial
    NG32 1QF Grantham
    The Old Post Office
    Lincolnshire
    EnglandBritish130512090002
    WAITT, Laurence John
    The Winters Oast 21 Chantry Park
    Sarre
    CT7 0LG Birchington
    Kent
    Director
    The Winters Oast 21 Chantry Park
    Sarre
    CT7 0LG Birchington
    Kent
    EnglandBritish97725530002
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Director designado corporativo
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    ¿Tiene HOME CARE SERVICES (KENT) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 21 jul 2010
    Entregado el 26 jul 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personas con derecho
    • Ing Bank Nv, London Branch (As Security Agent)
    Transacciones
    • 26 jul 2010Registro de un cargo (MG01)
    Debenture
    Creado el 10 dic 2009
    Entregado el 23 dic 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 23 dic 2009Registro de un cargo (MG01)
    • 28 jul 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 12 mar 2009
    Entregado el 13 mar 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 13 mar 2009Registro de un cargo (395)
    • 28 jul 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 17 may 2002
    Entregado el 27 may 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 27 may 2002Registro de un cargo (395)
    • 08 ago 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Single debenture
    Creado el 19 sept 1994
    Entregado el 21 sept 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 21 sept 1994Registro de un cargo (395)
    • 16 jul 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0