META VISION SYSTEMS LIMITED

META VISION SYSTEMS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMETA VISION SYSTEMS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02943066
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de META VISION SYSTEMS LIMITED?

    • fabricación de equipos electrónicos de control de procesos industriales (26512) / Industrias manufactureras
    • fabricación de otros equipos eléctricos (27900) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra META VISION SYSTEMS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    2nd Floor Arcadia House
    15 Forlease Road
    SL6 1RX Maidenhead
    Berkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de META VISION SYSTEMS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    META TECHNOLOGY LIMITED25 jul 199425 jul 1994
    GYROTRADE LIMITED27 jun 199427 jun 1994

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de META VISION SYSTEMS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para META VISION SYSTEMS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    26 páginasLIQ14

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 03 sept 2022

    24 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 03 sept 2021

    27 páginasLIQ03

    Domicilio social registrado cambiado de 81 Station Road Station Road Marlow SL7 1NS England a 2nd Floor Arcadia House 15 Forlease Road Maidenhead Berkshire SL6 1RX el 09 mar 2021

    2 páginasAD01

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 03 sept 2020

    23 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 03 sept 2019

    22 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 03 sept 2018

    28 páginasLIQ03

    Constitución del comité de acreedores o de liquidación

    7 páginasCOM1

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación el 04 sept 2017

    LRESEX

    Declaración de asuntos

    12 páginasLIQ02

    Domicilio social registrado cambiado de 81 Station Road Station Road Marlow Bucks SL7 1NS England a 81 Station Road Station Road Marlow SL7 1NS el 13 jun 2017

    1 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de Unit 3 Oakfield House Oakfield Industrial Est, Stanton Harcourt Road, Eynsham, Witney Oxfordshire OX29 4th a 81 Station Road Station Road Marlow Bucks SL7 1NS el 13 jun 2017

    1 páginasAD01

    Registro de la carga 029430660007, creada el 24 may 2017

    19 páginasMR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    18 páginasAA

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 20 sept 2016

    • Capital: GBP 1,089,514.513
    9 páginasSH01

    Cese del nombramiento de Jonathan Paul Moore como director el 20 sept 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David Brian Long como director el 20 sept 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Sarah Margaret Bunney como director el 20 sept 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Robert John Beattie como director el 20 sept 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Sarah Margaret Bunney como secretario el 20 sept 2016

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 27 jun 2016 avec liste complète des actionnaires

    11 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital29 jun 2016

    Estado de capital el 29 jun 2016

    • Capital: GBP 1,060,514.513
    SH01

    Cese del nombramiento de Wolfgang Roman Kolbl como director el 31 ene 2016

    1 páginasTM01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2014

    21 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de META VISION SYSTEMS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    LIANG, Yuan Fang
    Southbrae Drive
    G13 1TU Glasgow
    131
    Scotland
    Director
    Southbrae Drive
    G13 1TU Glasgow
    131
    Scotland
    United KingdomBritishScientist66534740003
    BUNNEY, Sarah Margaret
    Unit 3 Oakfield House
    Oakfield Industrial Est, Stanton
    OX29 4TH Harcourt Road, Eynsham, Witney
    Oxfordshire
    Secretario
    Unit 3 Oakfield House
    Oakfield Industrial Est, Stanton
    OX29 4TH Harcourt Road, Eynsham, Witney
    Oxfordshire
    148956720001
    MOORE, Jonathan Paul
    Paddock Wells
    Church Hanborough
    OX29 8AB Witney
    Oxfordshire
    Secretario
    Paddock Wells
    Church Hanborough
    OX29 8AB Witney
    Oxfordshire
    BritishSoftwear Consultant22132670002
    WOOLLARD, Kylie
    1 Hurst Lane
    Freeland
    OX29 8JA Witney
    Oxfordshire
    Secretario
    1 Hurst Lane
    Freeland
    OX29 8JA Witney
    Oxfordshire
    British89342560002
    KEY LEGAL SERVICES (SECRETARIAL) LIMITED
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    Secretario designado corporativo
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    900004240001
    BAILEY, Michael Anthony
    1 Radical Ride
    Finchampstead
    RG40 4UH Wokingham
    Berkshire
    Director
    1 Radical Ride
    Finchampstead
    RG40 4UH Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritishOperations Director55355190004
    BEATTIE, Robert John
    47 Stewartfield Drive
    East Kilbride
    G74 4UA Glasgow
    Director
    47 Stewartfield Drive
    East Kilbride
    G74 4UA Glasgow
    ScotlandBritishManaging Director32748890002
    BUNNEY, Sarah Margaret
    The Bakehouse
    Byfield Road, Priors Marston
    CV47 7RP Southam
    Warwickshire
    Director
    The Bakehouse
    Byfield Road, Priors Marston
    CV47 7RP Southam
    Warwickshire
    United KingdomBritishFinancial Director86684550001
    BURTON, Stephen
    The Rectory
    Carsington
    DE4 4DE Matlock
    Derbyshire
    Director
    The Rectory
    Carsington
    DE4 4DE Matlock
    Derbyshire
    United KingdomBritishChairman47675260003
    CLARK, Paul
    73 Steventon Road
    Drayton
    OX14 4LA Abingdon
    Oxfordshire
    Director
    73 Steventon Road
    Drayton
    OX14 4LA Abingdon
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector18118620001
    KOLBL, Wolfgang Roman, Dr
    2 Rose Avenue
    OX14 1XX Abingdon
    Oxfordshire
    Director
    2 Rose Avenue
    OX14 1XX Abingdon
    Oxfordshire
    United KingdomAustrianSales Director58590290004
    KOLBL, Wolfgang Roman, Doctor
    8 Pendil Close
    Wellington
    TF1 2PQ Telford
    Salop
    Director
    8 Pendil Close
    Wellington
    TF1 2PQ Telford
    Salop
    AustrianSales And Marketing Manager58590290003
    LOIZOU, Panos Andreas
    Unit 3 Oakfield House
    Oakfield Industrial Est, Stanton
    OX29 4TH Harcourt Road, Eynsham, Witney
    Oxfordshire
    Director
    Unit 3 Oakfield House
    Oakfield Industrial Est, Stanton
    OX29 4TH Harcourt Road, Eynsham, Witney
    Oxfordshire
    EnglandBritishBusiness Consultant141422590001
    LONG, David Brian
    2a Lynne Walk
    KT10 9DZ Esher
    Surrey
    Director
    2a Lynne Walk
    KT10 9DZ Esher
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director40011570003
    MERRIMAN, James Anthony
    64 Barton Road
    Haslingfield
    CB3 7LL Cambridge
    Cambridgeshire
    Director
    64 Barton Road
    Haslingfield
    CB3 7LL Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishManagement Consultant39988230001
    MOORE, Jonathan Paul
    Paddock Wells
    Church Hanborough
    OX29 8AB Witney
    Oxfordshire
    Director
    Paddock Wells
    Church Hanborough
    OX29 8AB Witney
    Oxfordshire
    United KingdomBritishTechnical Director22132670002
    MOORE, Jonathan Paul
    Paddock Wells
    Church Hanborough
    OX29 8AB Witney
    Oxfordshire
    Director
    Paddock Wells
    Church Hanborough
    OX29 8AB Witney
    Oxfordshire
    United KingdomBritishSoftware Consultant22132670002
    PRYCE, Andrew William, Dr
    13 Turnstone Green
    Langford Village
    OX26 6TT Bicester
    Oxfordshire
    Director
    13 Turnstone Green
    Langford Village
    OX26 6TT Bicester
    Oxfordshire
    United KingdomBritishMarketing Director73936780001
    THACKER, Stephen
    17 Rue Giffard
    Ile Perrot
    Quebec
    J7v 7e9
    Canada
    Director
    17 Rue Giffard
    Ile Perrot
    Quebec
    J7v 7e9
    Canada
    CanadianCompany President68711930002
    WILSON, Michael
    18 Cherwell Court
    Britannia Road
    OX16 5DE Banbury
    Oxfordshire
    Director
    18 Cherwell Court
    Britannia Road
    OX16 5DE Banbury
    Oxfordshire
    BritishCompany Director122543840001
    WOOLLARD, Kylie
    1 Hurst Lane
    Freeland
    OX29 8JA Witney
    Oxfordshire
    Director
    1 Hurst Lane
    Freeland
    OX29 8JA Witney
    Oxfordshire
    BritishFinance Director89342560002
    KEY LEGAL SERVICES (NOMINEES) LIMITED
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    Director designado corporativo
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    900004230001

    ¿Tiene META VISION SYSTEMS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 24 may 2017
    Entregado el 24 may 2017
    Pendiente
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Yuan Fang Liang
    Transacciones
    • 24 may 2017Registro de una carga (MR01)
    Rent deposit deed
    Creado el 28 may 2010
    Entregado el 29 may 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    £5773.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    The sum of £5773.00 see image for full details.
    Personas con derecho
    • Ws Surplus Supplies Limited
    Transacciones
    • 29 may 2010Registro de un cargo (MG01)
    Debenture
    Creado el 04 feb 2008
    Entregado el 09 feb 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Strathdon Holdings Limited
    Transacciones
    • 09 feb 2008Registro de un cargo (395)
    Deposit deed
    Creado el 08 jun 2005
    Entregado el 09 jun 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    £5,773.00 due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Rent deposit of £5,773.00.
    Personas con derecho
    • W.S.Surplus Supplies Limited
    Transacciones
    • 09 jun 2005Registro de un cargo (395)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creado el 18 jul 2002
    Entregado el 24 jul 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The deposit and all such rights to the repayment thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 24 jul 2002Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 02 jun 1997
    Entregado el 04 jun 1997
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 04 jun 1997Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 21 jul 1994
    Entregado el 28 jul 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 28 jul 1994Registro de un cargo (395)
    • 17 oct 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene META VISION SYSTEMS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    04 sept 2017Inicio de la liquidación
    03 nov 2023Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Christopher Newell
    81 Station Road
    SL7 1NS Marlow
    Bucks
    Profesional
    81 Station Road
    SL7 1NS Marlow
    Bucks
    Francis F A Wessely
    81 Station Road
    SL7 1NS Marlow
    Bucks
    Profesional
    81 Station Road
    SL7 1NS Marlow
    Bucks

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0