META VISION SYSTEMS LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | META VISION SYSTEMS LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02943066 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | Sí |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de META VISION SYSTEMS LIMITED?
- fabricación de equipos electrónicos de control de procesos industriales (26512) / Industrias manufactureras
- fabricación de otros equipos eléctricos (27900) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra META VISION SYSTEMS LIMITED?
Dirección de la sede social | 2nd Floor Arcadia House 15 Forlease Road SL6 1RX Maidenhead Berkshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de META VISION SYSTEMS LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
META TECHNOLOGY LIMITED | 25 jul 1994 | 25 jul 1994 |
GYROTRADE LIMITED | 27 jun 1994 | 27 jun 1994 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de META VISION SYSTEMS LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2015 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para META VISION SYSTEMS LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores | 26 páginas | LIQ14 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 03 sept 2022 | 24 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 03 sept 2021 | 27 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 81 Station Road Station Road Marlow SL7 1NS England a 2nd Floor Arcadia House 15 Forlease Road Maidenhead Berkshire SL6 1RX el 09 mar 2021 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 03 sept 2020 | 23 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 03 sept 2019 | 22 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 03 sept 2018 | 28 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Constitución del comité de acreedores o de liquidación | 7 páginas | COM1 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 2 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de asuntos | 12 páginas | LIQ02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 81 Station Road Station Road Marlow Bucks SL7 1NS England a 81 Station Road Station Road Marlow SL7 1NS el 13 jun 2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Unit 3 Oakfield House Oakfield Industrial Est, Stanton Harcourt Road, Eynsham, Witney Oxfordshire OX29 4th a 81 Station Road Station Road Marlow Bucks SL7 1NS el 13 jun 2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Registro de la carga 029430660007, creada el 24 may 2017 | 19 páginas | MR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 20 sept 2016
| 9 páginas | SH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jonathan Paul Moore como director el 20 sept 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Brian Long como director el 20 sept 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Sarah Margaret Bunney como director el 20 sept 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Robert John Beattie como director el 20 sept 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Sarah Margaret Bunney como secretario el 20 sept 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 27 jun 2016 avec liste complète des actionnaires | 11 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Wolfgang Roman Kolbl como director el 31 ene 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 21 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de META VISION SYSTEMS LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIANG, Yuan Fang | Director | Southbrae Drive G13 1TU Glasgow 131 Scotland | United Kingdom | British | Scientist | 66534740003 | ||||
BUNNEY, Sarah Margaret | Secretario | Unit 3 Oakfield House Oakfield Industrial Est, Stanton OX29 4TH Harcourt Road, Eynsham, Witney Oxfordshire | 148956720001 | |||||||
MOORE, Jonathan Paul | Secretario | Paddock Wells Church Hanborough OX29 8AB Witney Oxfordshire | British | Softwear Consultant | 22132670002 | |||||
WOOLLARD, Kylie | Secretario | 1 Hurst Lane Freeland OX29 8JA Witney Oxfordshire | British | 89342560002 | ||||||
KEY LEGAL SERVICES (SECRETARIAL) LIMITED | Secretario designado corporativo | 20 Station Road Radyr CF15 8AA Cardiff | 900004240001 | |||||||
BAILEY, Michael Anthony | Director | 1 Radical Ride Finchampstead RG40 4UH Wokingham Berkshire | England | British | Operations Director | 55355190004 | ||||
BEATTIE, Robert John | Director | 47 Stewartfield Drive East Kilbride G74 4UA Glasgow | Scotland | British | Managing Director | 32748890002 | ||||
BUNNEY, Sarah Margaret | Director | The Bakehouse Byfield Road, Priors Marston CV47 7RP Southam Warwickshire | United Kingdom | British | Financial Director | 86684550001 | ||||
BURTON, Stephen | Director | The Rectory Carsington DE4 4DE Matlock Derbyshire | United Kingdom | British | Chairman | 47675260003 | ||||
CLARK, Paul | Director | 73 Steventon Road Drayton OX14 4LA Abingdon Oxfordshire | United Kingdom | British | Director | 18118620001 | ||||
KOLBL, Wolfgang Roman, Dr | Director | 2 Rose Avenue OX14 1XX Abingdon Oxfordshire | United Kingdom | Austrian | Sales Director | 58590290004 | ||||
KOLBL, Wolfgang Roman, Doctor | Director | 8 Pendil Close Wellington TF1 2PQ Telford Salop | Austrian | Sales And Marketing Manager | 58590290003 | |||||
LOIZOU, Panos Andreas | Director | Unit 3 Oakfield House Oakfield Industrial Est, Stanton OX29 4TH Harcourt Road, Eynsham, Witney Oxfordshire | England | British | Business Consultant | 141422590001 | ||||
LONG, David Brian | Director | 2a Lynne Walk KT10 9DZ Esher Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 40011570003 | ||||
MERRIMAN, James Anthony | Director | 64 Barton Road Haslingfield CB3 7LL Cambridge Cambridgeshire | British | Management Consultant | 39988230001 | |||||
MOORE, Jonathan Paul | Director | Paddock Wells Church Hanborough OX29 8AB Witney Oxfordshire | United Kingdom | British | Technical Director | 22132670002 | ||||
MOORE, Jonathan Paul | Director | Paddock Wells Church Hanborough OX29 8AB Witney Oxfordshire | United Kingdom | British | Software Consultant | 22132670002 | ||||
PRYCE, Andrew William, Dr | Director | 13 Turnstone Green Langford Village OX26 6TT Bicester Oxfordshire | United Kingdom | British | Marketing Director | 73936780001 | ||||
THACKER, Stephen | Director | 17 Rue Giffard Ile Perrot Quebec J7v 7e9 Canada | Canadian | Company President | 68711930002 | |||||
WILSON, Michael | Director | 18 Cherwell Court Britannia Road OX16 5DE Banbury Oxfordshire | British | Company Director | 122543840001 | |||||
WOOLLARD, Kylie | Director | 1 Hurst Lane Freeland OX29 8JA Witney Oxfordshire | British | Finance Director | 89342560002 | |||||
KEY LEGAL SERVICES (NOMINEES) LIMITED | Director designado corporativo | 20 Station Road Radyr CF15 8AA Cardiff | 900004230001 |
¿Tiene META VISION SYSTEMS LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creado el 24 may 2017 Entregado el 24 may 2017 | Pendiente | ||
Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Rent deposit deed | Creado el 28 may 2010 Entregado el 29 may 2010 | Pendiente | Cantidad garantizada £5773.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción The sum of £5773.00 see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 04 feb 2008 Entregado el 09 feb 2008 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Deposit deed | Creado el 08 jun 2005 Entregado el 09 jun 2005 | Pendiente | Cantidad garantizada £5,773.00 due from the company to the chargee | |
Breve descripción Rent deposit of £5,773.00. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Deposit agreement to secure own liabilities | Creado el 18 jul 2002 Entregado el 24 jul 2002 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The deposit and all such rights to the repayment thereof. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 02 jun 1997 Entregado el 04 jun 1997 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 21 jul 1994 Entregado el 28 jul 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
¿Tiene META VISION SYSTEMS LIMITED algún caso de insolvencia?
Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidación voluntaria de acreedores |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0