LENDLEASE RESIDENTIAL (BH) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | LENDLEASE RESIDENTIAL (BH) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02945014 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de LENDLEASE RESIDENTIAL (BH) LIMITED?
- Construcción de edificios comerciales (41201) / Construcción
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra LENDLEASE RESIDENTIAL (BH) LIMITED?
| Dirección de la sede social | Level 7, 1 Eversholt Street NW1 2DN London United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LENDLEASE RESIDENTIAL (BH) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| LEND LEASE RESIDENTIAL (BH) LIMITED | 21 feb 2013 | 21 feb 2013 |
| THE BEAUFORT HOMES DEVELOPMENT GROUP LIMITED | 21 ago 2003 | 21 ago 2003 |
| THE BEAUFORT HOMES DEVELOPMENT GROUP PLC | 04 abr 1995 | 04 abr 1995 |
| THE BEAUFORT HOMES GROUP PLC | 04 jul 1994 | 04 jul 1994 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de LENDLEASE RESIDENTIAL (BH) LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 jun 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 mar 2027 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para LENDLEASE RESIDENTIAL (BH) LIMITED?
| Última declaración de confirmaci ón cerrada hasta | 28 abr 2027 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 12 may 2027 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 28 abr 2026 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para LENDLEASE RESIDENTIAL (BH) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 28 abr 2026 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2025 | 28 páginas | AA | ||
Modification des détails de Lendlease Residential (Cg) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 nov 2025 | 2 páginas | PSC05 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Level 7 1 Eversholt Street London NW1 2DN England a Level 7, 1 Eversholt Street London NW1 2DN el 20 nov 2025 | 1 páginas | AD01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Pinsent Masons Llp 30 Crown Place London EC2A 4ES England a Level 7 1 Eversholt Street London NW1 2DN el 03 nov 2025 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2024 | 27 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 abr 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Catriona Margaret Stubbs como director el 07 abr 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 5 Merchant Square Level 9 London W2 1BQ England a C/O Pinsent Masons Llp 30 Crown Place London EC2A 4ES el 06 ene 2025 | 1 páginas | AD01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Pinsent Masons Llp 30 Crown Place London EC2A 4ES England a 5 Merchant Square Level 9 London W2 1BQ el 11 dic 2024 | 1 páginas | AD01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 5 Merchant Square Level 9 London W2 1BQ England a C/O Pinsent Masons Llp 30 Crown Place London EC2A 4ES el 09 dic 2024 | 1 páginas | AD01 | ||
Nombramiento de Mr Thomas David Seymour como director el 31 oct 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mrs Catriona Margaret Stubbs como director el 30 oct 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Peter Dominic Leonard como director el 31 oct 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Louise Nicola Bramble como director el 30 oct 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2023 | 27 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 abr 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2022 | 22 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 abr 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Louise Nicola Bramble como director el 12 ene 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Angela Gangemi como director el 12 ene 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Linda Jo-Anne Brown como director el 13 ene 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 20 Triton Street Regent's Place London NW1 3BF a 5 Merchant Square Level 9 London W2 1BQ el 12 sept 2022 | 1 páginas | AD01 | ||
Cese del nombramiento de Kristy Sheridan Lansdown como director el 26 ago 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 abr 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
¿Quiénes son los directivos de LENDLEASE RESIDENTIAL (BH) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANGEMI, Angela | Director | Eversholt Street NW1 2DN London Level 7, 1 United Kingdom | United Kingdom | Australian | 304248460001 | |||||||||
| SEYMOUR, Thomas David | Director | Eversholt Street NW1 2DN London Level 7, 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 322654780001 | |||||||||
| DAVIES, Richard Mark | Secretario | 19 Ennerdale Close CF23 5NZ Cardiff | British | 119165920001 | ||||||||||
| FORD, Christopher Barry | Secretario | 1 Earl Rivers Avenue Heathcote CV34 6EN Warwick Warwickshire | British | 72014800001 | ||||||||||
| JANANDRAN, Thanalakshmi | Secretario | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 United Kingdom | British | 93299990001 | ||||||||||
| MANDEVILLE, Leslie Ronald | Secretario | Peppermill Lodge 6 Award Road GU52 6HE Church Crookham Hampshire | British | 77040370002 | ||||||||||
| MORRIS, Julian | Secretario | 1 The Chestnuts 60 High Street, Theale RG7 5AN Reading Berkshire | British | 67831060003 | ||||||||||
| MOUL, Anthony Peter | Secretario | 3 St Charles Place KT13 8XJ Weybridge Surrey | British | 47859160002 | ||||||||||
| PUTTERGILL, Claire | Secretario | 49 Pine Gardens KT5 8LJ Surbiton Surrey | British | 49527970005 | ||||||||||
| RICK, Ian Mark | Secretario | Croft Lodge Lower Warberry Road TQ1 1QP Torquay | British | 62584480001 | ||||||||||
| ROBERTSON, Alistair James | Secretario | 1 Meadow Close Farrington Gurney BS39 6UY Bristol Avon | British | 73972220001 | ||||||||||
| TAYLOR, Elizabeth | Secretario | 37 Swallow Rise Knaphill GU21 2LH Woking Surrey | British | 53767920002 | ||||||||||
| WHITE, Paul Matthew | Secretario | 74 Locking Close Bowerhill SN12 6XS Melksham Wiltshire | British | 62104870001 | ||||||||||
| CAPITA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Dukes Place EC3A 7NH London 40 United Kingdom |
| 102944500001 | ||||||||||
| RM REGISTRARS LIMITED | Secretario designado corporativo | Second Floor 80 Great Eastern Street EC2A 3RX London | 900000760001 | |||||||||||
| BRADY, Andrew Thornton | Director | 77 Bankhall Lane Hale WA15 0LN Altrincham Cheshire | England | British | 72399640003 | |||||||||
| BRAMBLE, Louise Nicola | Director | Merchant Square Level 9 W2 1BQ London 5 England | England | British | 256411060001 | |||||||||
| BROOKES, David | Director | Home Farm 37 Church Street Cotton In The Elms DE12 7PY Swadlincote Derbyshire | England | British | 125937580001 | |||||||||
| BROWN, Linda Jo-Anne | Director | Merchant Square Level 9 W2 1BQ London 5 England | England | Australian | 280747890001 | |||||||||
| CLARK, John David | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 | England | British | 224239010001 | |||||||||
| COOK, Richard John | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 United Kingdom | England | British | 178588500002 | |||||||||
| COPPELL, Richard Andrew | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 United Kingdom | United Kingdom | British | 140027550001 | |||||||||
| CRESSWELL, Euan James | Director | 38 Northend Batheaston BA1 7ES Bath Pine House | England | British | 52702570003 | |||||||||
| DAVIES, Justin | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 | England | Australian | 247518540002 | |||||||||
| DAY, Joanne Marie, Dr | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 United Kingdom | England | British | 99973050001 | |||||||||
| DECK, Robert John | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 England | United Kingdom | Australian | 157609710001 | |||||||||
| DICKINSON, Mark Davies | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 United Kingdom | United Kingdom | British | 267657020001 | |||||||||
| HEASMAN, Robert Adam | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 United Kingdom | United Kingdom | British | 183229880001 | |||||||||
| HUTCHINSON, Geoffrey | Director | 142 Northolt Road Harrow HA2 0EE Middlesex | United Kingdom | British | 16644000004 | |||||||||
| LANSDOWN, Kristy Sheridan | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 | England | British | 247053230001 | |||||||||
| LEE, Thomas William | Director | 45 Macready House 75 Cranford Street W1H 5LP London | Australian | 108629100002 | ||||||||||
| LEONARD, Peter Dominic | Director | Merchant Square Level 9 W2 1BQ London 5 England | United Kingdom | British | 280048870001 | |||||||||
| LEWIS, Roger St John Hulton | Director | Le Bocage La Rue Du Bocage St Brelade JE3 8BP Jersey Channel Islands | Great Britain | British | 30879310004 | |||||||||
| O'ROURKE, Benjamin Michael | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 United Kingdom | United Kingdom | Australian | 156924720001 | |||||||||
| PERRINS, Robert Charles Grenville | Director | Runnymede Sandpit Hall Road GU24 8AN Chobham Surrey | United Kingdom | British | 40362930004 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de LENDLEASE RESIDENTIAL (BH) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lendlease Residential (Cg) Limited | 06 abr 2016 | Eversholt Street NW1 2DN London Level 7, 1 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0