CAREWATCH CARE SERVICES LIMITED

CAREWATCH CARE SERVICES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCAREWATCH CARE SERVICES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02949558
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CAREWATCH CARE SERVICES LIMITED?

    • Actividades de trabajo social sin alojamiento para personas mayores y discapacitadas (88100) / Actividades sanitarias y de asistencia social

    ¿Dónde se encuentra CAREWATCH CARE SERVICES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    11th Floor Landmark St Peter's Square
    1 Oxford St
    M1 4PB Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CAREWATCH CARE SERVICES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CAREWATCH CARE SERVICES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    22 páginasLIQ14

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 22 jul 2023

    23 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 22 jul 2022

    14 páginasLIQ03

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Grant Thornton Uk Llp 4 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB a 11th Floor Landmark St Peter's Square 1 Oxford St Manchester M1 4PB el 16 nov 2021

    2 páginasAD01

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 22 jul 2021

    38 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 22 jul 2020

    57 páginasLIQ03

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    5 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    5 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    5 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    5 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    5 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    5 páginasNDISC

    Domicilio social registrado cambiado de Libra House Sunrise Parkway Linford Wood Milton Keynes MK14 6PH England a C/O Grant Thornton Uk Llp 4 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB el 14 ago 2019

    2 páginasAD01

    Declaración de asuntos

    7 páginasLIQ02

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación el 23 jul 2019

    LRESEX

    Cese del nombramiento de Mark Rogerson como director el 24 abr 2019

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Philip Jackson como director el 24 abr 2019

    2 páginasAP01

    Exercice comptable précédent raccourci du 30 mar 2018 au 29 mar 2018

    1 páginasAA01

    Cese del nombramiento de Scott Sommervaille Christie como director el 07 feb 2019

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 30 ene 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Kevin Richard Nutt como director el 28 ene 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Craig Hendry como secretario el 28 ene 2019

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Craig Archibald Macdonald Hendry como director el 28 ene 2019

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de CAREWATCH CARE SERVICES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    JACKSON, Philip
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    Director
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    EnglandBritish258380500001
    COLLISON, David
    44 Lowther Road
    SW13 9NU London
    England
    Secretario
    44 Lowther Road
    SW13 9NU London
    England
    British34835160001
    HENDRY, Craig
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    Secretario
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    188958710001
    LEWIS, Karen Deborah
    16 Tongdean Avenue
    BN3 6TL Hove
    East Sussex
    Secretario
    16 Tongdean Avenue
    BN3 6TL Hove
    East Sussex
    British43199080002
    LYON, David Oliver
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    Secretario
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    British51084280003
    LYON, David Oliver
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    Secretario
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    British51084280003
    PALMER, Lorna Catherine
    Cedar House
    78 Portsmouth Road
    KT11 1PP Cobham
    Surrey
    Secretario
    Cedar House
    78 Portsmouth Road
    KT11 1PP Cobham
    Surrey
    British118836500001
    ROBERTS THOMAS, Caroline Emma
    5 Broomsleigh Street
    NW6 1QQ London
    Secretario
    5 Broomsleigh Street
    NW6 1QQ London
    British76032450005
    STEADMAN, Paul James
    Silbury Court
    Silbury Boulevard
    MK9 2AF Milton Keynes
    Building 420
    United Kingdom
    Secretario
    Silbury Court
    Silbury Boulevard
    MK9 2AF Milton Keynes
    Building 420
    United Kingdom
    149308370001
    STEADMAN, Paul James
    Queen Square
    BN1 3FD Brighton
    1
    East Sussex
    Secretario
    Queen Square
    BN1 3FD Brighton
    1
    East Sussex
    149308090001
    STEVENS, Andrew Guy Melville
    Silbury Court
    Silbury Boulevard
    MK9 2AF Milton Keynes
    Building 420
    United Kingdom
    Secretario
    Silbury Court
    Silbury Boulevard
    MK9 2AF Milton Keynes
    Building 420
    United Kingdom
    176884990001
    BOOTY, Stephen Martin
    South Lodge
    Guildford Road
    KT24 5QE Effingham
    Surrey
    Director
    South Lodge
    Guildford Road
    KT24 5QE Effingham
    Surrey
    EnglandBritish147928010001
    CHRISTIE, Scott Sommervaille
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    Director
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    ScotlandBritish104262520001
    DENNY, Nigel John
    Silbury Court
    Silbury Boulevard
    MK9 2AF Milton Keynes
    Building 420
    United Kingdom
    Director
    Silbury Court
    Silbury Boulevard
    MK9 2AF Milton Keynes
    Building 420
    United Kingdom
    EnglandBritish176860610001
    ELLIS, Martyn Anthony
    83 Boss House
    Boss Street
    SE1 2PT London
    Director
    83 Boss House
    Boss Street
    SE1 2PT London
    EnglandBritish95749550002
    HARLAND, David William Romanis
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    Director
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    United KingdomBritish136594420001
    HENDRY, Craig Archibald Macdonald
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    Director
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    ScotlandUnited Kingdom104826820002
    HORGAN, Michael David
    Moreton Lane
    Bishopstone
    HP17 8SQ Aylesbury
    Moreton Barn
    Buckinghamshire
    England
    Director
    Moreton Lane
    Bishopstone
    HP17 8SQ Aylesbury
    Moreton Barn
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish107985980001
    HORGAN, Michael David
    7 Lady Yorke Park
    Seven Hills Road
    SL0 0PD Iver
    Buckinghamshire
    Director
    7 Lady Yorke Park
    Seven Hills Road
    SL0 0PD Iver
    Buckinghamshire
    EnglandBritish107985980001
    JEWITT, Justin Allan Spaven, Professor
    The Stables
    89 Aston End Road Aston
    SG2 7EY Stevenage
    Hertfordshire
    Director
    The Stables
    89 Aston End Road Aston
    SG2 7EY Stevenage
    Hertfordshire
    EnglandBritish39701670001
    LEWIS, Kevin James
    Knutsford House
    Blackgate Lane
    BN5 9HA Henfield
    West Sussex
    Director
    Knutsford House
    Blackgate Lane
    BN5 9HA Henfield
    West Sussex
    British121067560001
    LYON, David Oliver
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish51084280003
    LYON, David Oliver
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish51084280003
    MATTHEWS, Christine
    61 Palin Wood Road
    OL3 5UW Oldham
    Lancashire
    Director
    61 Palin Wood Road
    OL3 5UW Oldham
    Lancashire
    British79885850001
    NEILL, Deborah Ann
    Silbury Court
    Silbury Boulevard
    MK9 2AF Milton Keynes
    Building 420
    Director
    Silbury Court
    Silbury Boulevard
    MK9 2AF Milton Keynes
    Building 420
    United KingdomBritish190155350001
    NUTT, Kevin Richard
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    Director
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    EnglandEnglish243106190001
    OVERGAGE, Simon
    19 Icknield Street
    Beoley
    B98 9AD Redditch
    Director
    19 Icknield Street
    Beoley
    B98 9AD Redditch
    EnglandBritish50370120003
    PEGLER, Philip Michael
    Silbury Court
    Silbury Boulevard
    MK9 2AF Milton Keynes
    Building 420
    United Kingdom
    Director
    Silbury Court
    Silbury Boulevard
    MK9 2AF Milton Keynes
    Building 420
    United Kingdom
    United KingdomBritish163278630001
    RICHARDS, Paul William
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    Director
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    EnglandBritish171470760003
    ROGERSON, Mark
    Frith End Road
    GU35 0RA Bordon
    Calenzana
    England
    Director
    Frith End Road
    GU35 0RA Bordon
    Calenzana
    England
    EnglandBritish168247970003
    STEADMAN, Paul James
    The Glades
    HP1 2TH Hemel Hempstead
    7
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Director
    The Glades
    HP1 2TH Hemel Hempstead
    7
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141046340001
    STEVENS, Andrew Guy Melville
    Silbury Court
    Silbury Boulevard
    MK9 2AF Milton Keynes
    Building 420
    United Kingdom
    Director
    Silbury Court
    Silbury Boulevard
    MK9 2AF Milton Keynes
    Building 420
    United Kingdom
    EnglandBritish88041330002
    UNSWORTH, Stephen
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    Director
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    EnglandBritish199259970001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CAREWATCH CARE SERVICES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Carewatch Acquisitions Limited
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    06 abr 2016
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompany Law & Companies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House - England
    Número de registro06662713
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene CAREWATCH CARE SERVICES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 13 feb 2017
    Entregado el 20 feb 2017
    Pendiente
    Breve descripción
    N/A.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (as Security Agent)
    Transacciones
    • 20 feb 2017Registro de una carga (MR01)
    • 24 ene 2019Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 24 ene 2019Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 24 ene 2019Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 24 ene 2019Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 28 ene 2019Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga (MR05)
    Keyman insurance assignment
    Creado el 27 sept 2012
    Entregado el 03 oct 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The security assets being the policy - policy no 016728283-9 date of policy 25 may 2012 name of life assured mr andrew guy neville stevens and the policy benefits see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transacciones
    • 03 oct 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 11 mar 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Keyman insurance assignment
    Creado el 06 mar 2012
    Entregado el 09 mar 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Security assets means each policy and its related policy benefits. Legal & general assurance society p/no 016729425-5 mr philip michael pegler £500,000.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent for the Finance Parties)
    Transacciones
    • 09 mar 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 11 mar 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Supplemental security and confirmation deed
    Creado el 25 nov 2011
    Entregado el 07 dic 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any group company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transacciones
    • 07 dic 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 11 mar 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Rent deposit deed
    Creado el 05 sept 2011
    Entregado el 16 sept 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    £4,020.75 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    The initial deposit being the sum off £4,020.75 see image for full details.
    Personas con derecho
    • Foxhall Business Centre Limited
    Transacciones
    • 16 sept 2011Registro de un cargo (MG01)
    Rent deposit deed
    Creado el 09 nov 2010
    Entregado el 27 nov 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    £11,825.49 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    The deposit.
    Personas con derecho
    • Max Office 2 LLP
    Transacciones
    • 27 nov 2010Registro de un cargo (MG01)
    Insurance assignment of keyman policies
    Creado el 04 nov 2010
    Entregado el 06 nov 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All its present and future right title and interest in and to the keyman policies being axa sun life PLC paul steadman policy no 33759468 sum assured £250,000 term 5 years, see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 06 nov 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 11 mar 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Accession to composite debenture
    Creado el 06 oct 2008
    Entregado el 10 oct 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any group company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transacciones
    • 10 oct 2008Registro de un cargo (395)
    • 11 mar 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 30 ene 1998
    Entregado el 06 feb 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 06 feb 1998Registro de un cargo (395)
    • 29 jul 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 15 may 1995
    Entregado el 23 may 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 23 may 1995Registro de un cargo (395)
    • 25 mar 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene CAREWATCH CARE SERVICES LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    23 jul 2019Inicio de la liquidación
    29 feb 2024Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Daniel Robert Whiteley Smith
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Profesional
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Oliver Haunch
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Profesional
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0