JLA TOTAL CARE LIMITED

JLA TOTAL CARE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaJLA TOTAL CARE LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02951461
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de JLA TOTAL CARE LIMITED?

    • Alquiler y arrendamiento de otras máquinas, equipo y bienes tangibles n.c.p. (77390) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra JLA TOTAL CARE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Meadowcroft Lane, Halifax Road
    Ripponden
    HX6 4AJ West Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de JLA TOTAL CARE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    LAUNDRY FM LIMITED01 jul 199601 jul 1996
    EASY HIRE SOLUTIONS LIMITED27 abr 199527 abr 1995
    JEMBERT 11000 LIMITED22 jul 199422 jul 1994

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de JLA TOTAL CARE LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 oct 2024
    Próximas cuentas vencen el31 jul 2025
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 oct 2023

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para JLA TOTAL CARE LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta30 abr 2025
    Próxima declaración de confirmación vence14 may 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta30 abr 2024
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para JLA TOTAL CARE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cambio de datos del director Mr Ben Gujral el 03 dic 2024

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 oct 2023

    36 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 30 abr 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 oct 2022

    35 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 30 abr 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 oct 2021

    34 páginasAA

    Cese del nombramiento de Mircea Daniel Tanase como director el 04 jul 2022

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Sarah Jane Norton como director el 04 jul 2022

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 30 abr 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Anton James Duvall como director el 28 feb 2022

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Mircea Daniel Tanase como director el 25 feb 2022

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Paul Anthony Eastwood como director el 01 ago 2021

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Anton James Duvall como director el 01 ago 2021

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 oct 2020

    33 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 30 abr 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Paul Anthony Eastwood como director el 28 sept 2020

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Helen Jane Ashton como director el 28 sept 2020

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 oct 2019

    34 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 30 abr 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Registro de la carga 029514610014, creada el 14 abr 2020

    26 páginasMR01

    Nombramiento de Ben Gujral como director el 01 ene 2020

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Paul Justin Humphreys como director el 31 dic 2019

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 oct 2018

    28 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 30 abr 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Helen Jane Ashton como director el 01 ene 2019

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de JLA TOTAL CARE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GUJRAL, Ben
    Meadowcroft Lane, Halifax Road
    Ripponden
    HX6 4AJ West Yorkshire
    Director
    Meadowcroft Lane, Halifax Road
    Ripponden
    HX6 4AJ West Yorkshire
    EnglandBritishDirector265693080002
    NORTON, Sarah Jane
    Halifax Road
    HX6 4AJ Ripponden
    Meadowcroft Lane
    West Yorkshire
    England
    Director
    Halifax Road
    HX6 4AJ Ripponden
    Meadowcroft Lane
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritishDirector297608410001
    WILKINSON, George Stuart
    Rushfield Barn
    Dairy Lane
    HG3 2QP Darley
    North Yorkshire
    Secretario
    Rushfield Barn
    Dairy Lane
    HG3 2QP Darley
    North Yorkshire
    BritishCompany Director96558860001
    JEMBERT FORMATION LIMITED
    Sixth Floor Westgate Point
    Westgate
    LS1 2AX Leeds
    Secretario designado corporativo
    Sixth Floor Westgate Point
    Westgate
    LS1 2AX Leeds
    900010080001
    ASHTON, Helen Jane
    Meadowcroft Lane, Halifax Road
    Ripponden
    HX6 4AJ West Yorkshire
    Director
    Meadowcroft Lane, Halifax Road
    Ripponden
    HX6 4AJ West Yorkshire
    United KingdomBritishChief Executive Officer254469480001
    BARKER, Matthew Howard
    24-28 Greenside
    Pudsey
    LS28 8PU Leeds
    The Old Wine Cellar
    West Yorkshire
    Director
    24-28 Greenside
    Pudsey
    LS28 8PU Leeds
    The Old Wine Cellar
    West Yorkshire
    United KingdomBritishFinance Director148223210001
    BARR, Alan Andrew
    Meadowcroft Lane, Halifax Road
    Ripponden
    HX6 4AJ West Yorkshire
    Director
    Meadowcroft Lane, Halifax Road
    Ripponden
    HX6 4AJ West Yorkshire
    ScotlandBritishDirector121452150001
    BATEMAN, Yvette
    Egerton House
    Scammonden
    HD3 3FR Huddersfield
    Director
    Egerton House
    Scammonden
    HD3 3FR Huddersfield
    BritishDirector27514220001
    BAXTER, Stephen Roy
    Meadowcroft Lane, Halifax Road
    Ripponden
    HX6 4AJ West Yorkshire
    Director
    Meadowcroft Lane, Halifax Road
    Ripponden
    HX6 4AJ West Yorkshire
    ScotlandBritishDirector86622660005
    BURROWS, Steven Michael
    Turvin Farm
    Turvin Cottages
    HX7 5TN Hebden Bridge
    West Yorkshire
    Director
    Turvin Farm
    Turvin Cottages
    HX7 5TN Hebden Bridge
    West Yorkshire
    BritishIt Director67582770002
    CARDIS, Richard Charles
    38 Gledhow Lane
    LS8 1SA Leeds
    West Yorkshire
    Director
    38 Gledhow Lane
    LS8 1SA Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector86900990001
    CRUDDOS, David
    Staveley House
    1 Firs Park
    HG2 9HS Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    Staveley House
    1 Firs Park
    HG2 9HS Harrogate
    North Yorkshire
    BritishDirector103505480001
    DUVALL, Anton James
    Ripponden
    HX6 4AJ Sowerby Bridge
    Meadowcroft Lane
    England
    Director
    Ripponden
    HX6 4AJ Sowerby Bridge
    Meadowcroft Lane
    England
    EnglandBritishChief Finance Officer273833160001
    EASTWOOD, Paul Anthony
    Meadowcroft Lane, Halifax Road
    Ripponden
    HX6 4AJ West Yorkshire
    Director
    Meadowcroft Lane, Halifax Road
    Ripponden
    HX6 4AJ West Yorkshire
    EnglandBritishChief People Officer255032070001
    FINE, Jonathan Joseph
    4 Lyme Park
    Chinley
    SK23 6AG High Peak
    Derbyshire
    Director
    4 Lyme Park
    Chinley
    SK23 6AG High Peak
    Derbyshire
    BritishDirector119453550001
    HIRST, Edward George
    4 Haw Court
    Silkstone
    S75 4JF Barnsley
    South Yorkshire
    Director
    4 Haw Court
    Silkstone
    S75 4JF Barnsley
    South Yorkshire
    BritishCompany Director10136700001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    Meadowcroft Lane, Halifax Road
    Ripponden
    HX6 4AJ West Yorkshire
    Director
    Meadowcroft Lane, Halifax Road
    Ripponden
    HX6 4AJ West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director33223550003
    LAITHWAITE, John
    The Howroyde
    Barkisland
    HX4 0AP Halifax
    West Yorkshire
    Director
    The Howroyde
    Barkisland
    HX4 0AP Halifax
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector2100890002
    LAITHWAITE, Susan Rosemary
    The Howroyde
    Barkisland
    HX4 0AP Halifax
    West Yorkshire
    Director
    The Howroyde
    Barkisland
    HX4 0AP Halifax
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector2100900002
    LEE, Richard Anthony
    Papillion The Hamlet
    Hundhill
    WF8 3DZ Pontefract
    West Yorkshire
    Director
    Papillion The Hamlet
    Hundhill
    WF8 3DZ Pontefract
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector101662110001
    LILLEY, Danik
    Lower Hall
    Barkisland
    HX4 0AG Halifax
    West Yorkshire
    Director
    Lower Hall
    Barkisland
    HX4 0AG Halifax
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector114322860002
    LOGAN, Richard Henry
    Greystones
    Draughton
    BD23 6EG Skipton
    North Yorkshire
    Director
    Greystones
    Draughton
    BD23 6EG Skipton
    North Yorkshire
    United KingdomBritishChartered Accountant65473760003
    MOORCROFT, David Alex Lee
    84 Bridge Lane
    Bramhall
    SK7 3AW Stockport
    Cheshire
    Director
    84 Bridge Lane
    Bramhall
    SK7 3AW Stockport
    Cheshire
    EnglandBritishDirector106528480001
    SWAILES, John Howard
    14 Close Lea Way
    Rastrick
    HD6 3DF Brighouse
    West Yorkshire
    Director
    14 Close Lea Way
    Rastrick
    HD6 3DF Brighouse
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector29291390001
    SWAILES, John Howard
    14 Close Lea Way
    Rastrick
    HD6 3DF Brighouse
    West Yorkshire
    Director
    14 Close Lea Way
    Rastrick
    HD6 3DF Brighouse
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director29291390001
    SWIFT, Christopher John
    6 The Wharf
    Wool Road Dobcross
    OL3 5QR Oldham
    Lancashire
    Director
    6 The Wharf
    Wool Road Dobcross
    OL3 5QR Oldham
    Lancashire
    BritishAccountant47959120001
    TANASE, Mircea Daniel
    Halifax Road
    HX6 4AJ Ripponden
    Meadowcroft Lane
    West Yorkshire
    England
    Director
    Halifax Road
    HX6 4AJ Ripponden
    Meadowcroft Lane
    West Yorkshire
    England
    EnglandIrishInvestment Professional246220040001
    THOMPSON, Peter
    Sun Head
    New Hutton
    LA8 0LR Kendal
    Cumbria
    Director
    Sun Head
    New Hutton
    LA8 0LR Kendal
    Cumbria
    EnglandBritishDirector74438890002
    WILKINSON, George Stuart
    Rushfield Barn
    Dairy Lane
    HG3 2QP Darley
    North Yorkshire
    Director
    Rushfield Barn
    Dairy Lane
    HG3 2QP Darley
    North Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director96558860001
    JEMBERT NOMINEES LIMITED
    Sixth Floor Westgate Point
    Westgate
    LS1 2AX Leeds
    Director designado corporativo
    Sixth Floor Westgate Point
    Westgate
    LS1 2AX Leeds
    900010070001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de JLA TOTAL CARE LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Vanilla Group Limited
    Meadowcroft Lane
    Ripponden
    HX6 4AJ Sowerby Bridge
    Vanilla Group Limited
    England
    06 abr 2016
    Meadowcroft Lane
    Ripponden
    HX6 4AJ Sowerby Bridge
    Vanilla Group Limited
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    Autoridad legalCompanies Act 2006 - England & Wales
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene JLA TOTAL CARE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 14 abr 2020
    Entregado el 20 abr 2020
    Pendiente
    Breve descripción
    N/A.
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Glas Trust Corporation Limited
    Transacciones
    • 20 abr 2020Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 12 nov 2018
    Entregado el 14 nov 2018
    Pendiente
    Breve descripción
    N/A.
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Glas Trust Corporation Limited
    Transacciones
    • 14 nov 2018Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 09 ene 2018
    Entregado el 16 ene 2018
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    N/A.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transacciones
    • 16 ene 2018Registro de una carga (MR01)
    • 15 ago 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 30 oct 2015
    Entregado el 05 nov 2015
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland as Security Agent
    Transacciones
    • 05 nov 2015Registro de una carga (MR01)
    • 15 ago 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 30 jul 2014
    Entregado el 01 ago 2014
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Hayfin Services LLP
    Transacciones
    • 01 ago 2014Registro de una carga (MR01)
    • 04 ago 2015Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 18 ago 2015Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 12 nov 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Security agreement
    Creado el 11 oct 2010
    Entregado el 19 oct 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Haymarket Financial LLP as Security Agent
    Transacciones
    • 19 oct 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 04 ago 2015Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 18 ago 2015Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 12 nov 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 23 dic 2008
    Entregado el 24 dic 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the security trustee,the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 24 dic 2008Registro de un cargo (395)
    • 27 oct 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 14 ago 2007
    Entregado el 17 ago 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the security trustee, the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 17 ago 2007Registro de un cargo (395)
    • 27 oct 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creado el 27 mar 2006
    Entregado el 31 mar 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 31 mar 2006Registro de un cargo (395)
    • 27 oct 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Contracts assignment
    Creado el 24 may 2002
    Entregado el 07 jun 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of assignment all its right, title and interest in, to, arising under or resulting from the contracts. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 07 jun 2002Registro de un cargo (395)
    • 27 oct 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 24 may 2002
    Entregado el 07 jun 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 07 jun 2002Registro de un cargo (395)
    • 27 oct 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Block discounting agreement
    Creado el 16 jun 1999
    Entregado el 21 jun 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this deed
    Breve descripción
    Floating charge of all right,title and interest in and to the debts and the assets as defined in the block discounting agreement relating to receivables purchased by the chargee.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transacciones
    • 21 jun 1999Registro de un cargo (395)
    • 24 dic 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 20 dic 1995
    Entregado el 03 ene 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific charge over the benefit of all leasing rental hire purchase or credit sale agreements as are now or may from time to time be entered into by the company with its customers ("the agreements") all bills of exchange or promissory notes taken as security for instalments under the agreements and all guarantees indemnities bonds or other securities taken for the performance of the agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 03 ene 1996Registro de un cargo (395)
    • 11 abr 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 30 nov 1994
    Entregado el 20 dic 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 20 dic 1994Registro de un cargo (395)
    • 11 abr 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0