VEHICLE LEASING (1) LIMITED

VEHICLE LEASING (1) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaVEHICLE LEASING (1) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02953304
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de VEHICLE LEASING (1) LIMITED?

    • Alquiler y arrendamiento de automóviles y vehículos de motor ligeros (77110) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra VEHICLE LEASING (1) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de VEHICLE LEASING (1) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    LEX VEHICLE LEASING (1) LIMITED 12 dic 199412 dic 1994
    IVORYLEDGE LIMITED27 jul 199427 jul 1994

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de VEHICLE LEASING (1) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para VEHICLE LEASING (1) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    9 páginasLIQ13

    Misceláneos

    AD03
    2 páginasMISC

    Domicilio social registrado cambiado de Charterhall House Charterhall Drive Chester Cheshire CH88 3AN a 1 More London Place London SE1 2AF el 01 jun 2017

    2 páginasAD01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN

    2 páginasAD02

    Declaración de solvencia

    6 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 28 abr 2017

    LRESSP

    Cancelación total de la carga 2

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 3

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 4

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 5

    1 páginasMR04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2016

    9 páginasAA

    Nombramiento de Mr Jonathan Stewart Roberts como director el 26 ago 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Paul Gittins como secretario el 28 jun 2016

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr David Dermot Hennessey como secretario el 28 jun 2016

    2 páginasAP03

    Déclaration annuelle établie au 21 jun 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital21 jun 2016

    Estado de capital el 21 jun 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cese del nombramiento de Scott Cargill como director el 04 mar 2016

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2015

    9 páginasAA

    Cambio de datos del director Damian Charles Stansfield el 19 ago 2015

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Damian Charles Stansfield como director el 07 ago 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Richard Gareth Charles Hanrahan como director el 06 ago 2015

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 27 jul 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital30 jul 2015

    Estado de capital el 30 jul 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2014

    16 páginasAA

    Cese del nombramiento de Carol Ann Parkes como director el 06 ene 2015

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de VEHICLE LEASING (1) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HENNESSEY, David Dermot
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower House
    United Kingdom
    Secretario
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower House
    United Kingdom
    209489310001
    ROBERTS, Jonathan Stewart
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    Director
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector127524890001
    STANSFIELD, Damian Charles
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    Director
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director158010850002
    COLES, Pamela Mary
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Secretario
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British70326980001
    GITTINS, Paul
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    Secretario
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    British45660860003
    IVES, Deborah Ann
    Chukwani The Friary
    Old Windsor
    SL4 2NS Windsor
    Berkshire
    Secretario
    Chukwani The Friary
    Old Windsor
    SL4 2NS Windsor
    Berkshire
    British61720060001
    RICHARDSON, Elaine
    The Willows Willowside
    London Colney
    AL2 1DP St Albans
    Hertfordshire
    Secretario
    The Willows Willowside
    London Colney
    AL2 1DP St Albans
    Hertfordshire
    British36633090001
    YOUNG, Mark Lees
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    Secretario
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    BritishSolicitor32782910002
    YOUNG, Mark Lees
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    Secretario
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    BritishSolicitor32782910002
    AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    Secretario corporativo
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    1278390004
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secretario designado corporativo
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    BALLINGALL, Stuart James
    39 Craigleith Drive
    EH4 3JU Edinburgh
    Midlothian
    Director
    39 Craigleith Drive
    EH4 3JU Edinburgh
    Midlothian
    BritishChartered Accountant118506820001
    CARGILL, Scott William
    Orchard Brae
    EH4 1PF Edinburgh
    Finance House
    United Kingdom
    Director
    Orchard Brae
    EH4 1PF Edinburgh
    Finance House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector193660260001
    CHESSMAN, Mark Francis
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Blake House
    United Kingdom
    Director
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Blake House
    United Kingdom
    EnglandBritishGeneral Manager196385070001
    COLES, Pamela Mary
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishCompany Secretary70326980001
    CORMICK, Charles Bruce Arthur
    Flat 2
    11 Pembridge Crescent
    W11 3DT London
    Director
    Flat 2
    11 Pembridge Crescent
    W11 3DT London
    United KingdomBritishCompany Secretary & Solicitor17946190001
    DONNELLY, William John
    Ashley Barn 8 Fifield Farms Barns
    Benson
    OX10 6EZ Wallingford
    Oxfordshire
    Director
    Ashley Barn 8 Fifield Farms Barns
    Benson
    OX10 6EZ Wallingford
    Oxfordshire
    BritishDirector23913250003
    EASTER, Philip Charles
    Arlington House
    Arlington Lane
    NR2 2DB Norwich
    Director
    Arlington House
    Arlington Lane
    NR2 2DB Norwich
    EnglandBritishInsurance Company Official105999210001
    FEWSTER, Roy Robson
    Woodend
    Rosedale Abbey
    YO18 8SE Pickering
    North Yorkshire
    Director
    Woodend
    Rosedale Abbey
    YO18 8SE Pickering
    North Yorkshire
    BritishManaging Director50065350001
    FOULDS, David Michael
    8 Upper Hollis
    HP16 9HP Great Missenden
    Buckinghamshire
    Director
    8 Upper Hollis
    HP16 9HP Great Missenden
    Buckinghamshire
    EnglandBritishFinance Director122016350001
    FRANCIS, Rick
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Blake House
    United Kingdom
    Director
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Blake House
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector180380320001
    FRANCIS, Rick
    Ravenswood House
    Coventry Road
    CV47 1BG Southam
    Warwickshire
    Director
    Ravenswood House
    Coventry Road
    CV47 1BG Southam
    Warwickshire
    EnglandBritishFinance Director180380320001
    GALLOWAY, David Allistair
    Gyldernscroft 1 Henley Road
    SL7 2BZ Marlow
    Buckinghamshire
    Director
    Gyldernscroft 1 Henley Road
    SL7 2BZ Marlow
    Buckinghamshire
    BritishDirector305790001
    GALLOWAY, David Allistair
    Gyldernscroft 1 Henley Road
    SL7 2BZ Marlow
    Buckinghamshire
    Director
    Gyldernscroft 1 Henley Road
    SL7 2BZ Marlow
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director305790001
    HANRAHAN, Richard Gareth Charles
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    Director
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector193543450001
    HARRIS, Peter Robert
    Four Winds
    Fireball Hill
    SL5 9PJ Sunningdale
    Berkshire
    Director
    Four Winds
    Fireball Hill
    SL5 9PJ Sunningdale
    Berkshire
    United KingdomBritishFinance Director50619920001
    HAY, Andrew John
    Highcroft
    Northfield Place
    KT13 0RF Weybridge
    Surrey
    Director
    Highcroft
    Northfield Place
    KT13 0RF Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritishAccountant124994940001
    IVES, Deborah Ann
    Chukwani The Friary
    Old Windsor
    SL4 2NS Windsor
    Berkshire
    Director
    Chukwani The Friary
    Old Windsor
    SL4 2NS Windsor
    Berkshire
    BritishSolicotor61720060001
    JENNISON, Gary Antony
    Walden Cottage
    Bull Lane, Chalfont St. Peter
    SL9 8RY Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    Walden Cottage
    Bull Lane, Chalfont St. Peter
    SL9 8RY Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritishMd - Business To Business68450470001
    KOSTER, Richard Peter Timothy, Dr
    71 Humbolt Road
    W6 8QQ London
    Director
    71 Humbolt Road
    W6 8QQ London
    BritishMarketing Director68975920001
    MACHELL, Simon Christopher
    Gooch's Farm
    Rushall
    IP21 4QB Diss
    Norfolk
    Director
    Gooch's Farm
    Rushall
    IP21 4QB Diss
    Norfolk
    BritishInsurance Company Official145338560001
    PARKES, Carol Ann
    Heathside Park Road
    SK3 0RB Stockport
    Heathside
    Cheshire
    United Kingdom
    Director
    Heathside Park Road
    SK3 0RB Stockport
    Heathside
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director139996590027
    SNOWBALL, Patrick Joseph Robert
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    Director
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    BritishInsurance Company Official38351740003
    SPELLINS, Gary Wade
    25 Friars Avenue
    Whetstone
    N20 0XE London
    Director
    25 Friars Avenue
    Whetstone
    N20 0XE London
    British/UsaSales & Marketing Director61788120001
    STEAD, Nigel Cleator
    Blake House
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Lex Autolease
    England
    England
    Director
    Blake House
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Lex Autolease
    England
    England
    EnglandBritishDirector47582470001

    ¿Tiene VEHICLE LEASING (1) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A fixed and floating security document
    Creado el 26 oct 2005
    Entregado el 03 nov 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the charging group companies to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Halifax PLC
    Transacciones
    • 03 nov 2005Registro de un cargo (395)
    • 06 abr 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 16 jul 2004
    Entregado el 27 jul 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and the other initial charging companies to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Halifax PLC as Security Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 27 jul 2004Registro de un cargo (395)
    • 06 abr 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    A fixed and floating security document (the "debenture")
    Creado el 07 dic 2001
    Entregado el 14 dic 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys,liabilities and obligations due or to become due from the charging group companies (as defined) to the chargee (the "hedging bank") under or pursuant to the swap documents (as defined) or otherwise
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Halifax PLC
    Transacciones
    • 14 dic 2001Registro de un cargo (395)
    • 06 abr 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture between the company and halifax PLC as agent and trustee for the finance parties (the security trustee)
    Creado el 31 dic 1998
    Entregado el 06 ene 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys liabilities and obligations due or to become due by the charging group companies (as defined) to the finance parties (as defined) under or pursuant to the financing documents (as defined)
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Halifax PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 06 ene 1999Registro de un cargo (395)
    • 06 abr 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 28 ago 1998
    Entregado el 09 sept 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lombard North Central PLC
    Transacciones
    • 09 sept 1998Registro de un cargo (395)
    • 14 ene 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene VEHICLE LEASING (1) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    28 abr 2017Inicio de la liquidación
    28 feb 2018Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Profesional
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Profesional
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0