GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED

GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02955426
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED?

    • (7011) /
    • (7020) /

    ¿Dónde se encuentra GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CROSSCO (NO.115) LIMITED03 ago 199403 ago 1994

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Nicholas Mark Fletcher Jopling como director el 28 sept 2011

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Nicholas Peter On como director el 28 sept 2011

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Peter Quentin Patrick Couch como director el 28 sept 2011

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Nicholas Peter On el 17 may 2011

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2010

    12 páginasAA

    Nombramiento de Mark Greenwood como director

    3 páginasAP01

    Nombramiento de Nicholas Mark Fletcher Jopling como director

    3 páginasAP01

    Nombramiento de Peter Quentin Patrick Couch como director

    3 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 30 sept 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 oct 2010

    Estado de capital el 12 oct 2010

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cambio de datos del director Nick On el 16 sept 2010

    3 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2009

    12 páginasAA

    Cese del nombramiento de Rupert Dickinson como director

    2 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 30 sept 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2008

    13 páginasAA

    legacy

    3 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas288c

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2007

    13 páginasAA

    legacy

    1 páginas288c

    ¿Quiénes son los directivos de GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WINDLE, Michael Patrick
    Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    High Priar
    Northumberland
    Secretario
    Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    High Priar
    Northumberland
    British135308530001
    CUNNINGHAM, Andrew Rolland
    Montagu Avenue
    NE3 4JH Newcastle Upon Tyne
    35
    Tyne And Wear
    Director
    Montagu Avenue
    NE3 4JH Newcastle Upon Tyne
    35
    Tyne And Wear
    EnglandBritish74581390003
    GREENWOOD, Mark
    Slayley
    NE47 0AA Hexham
    Winter House
    Northumberland
    Director
    Slayley
    NE47 0AA Hexham
    Winter House
    Northumberland
    United KingdomBritish154194730002
    DAVIS, Geoffrey Joseph
    9 The Copse
    Burnopfield
    NE16 6HA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Secretario
    9 The Copse
    Burnopfield
    NE16 6HA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British65421150001
    GLANVILLE, Marie Louise
    28 Bramhall Drive
    High Generals Wood Rickleton
    NE38 9DB Washington
    Tyne & Wear
    Secretario
    28 Bramhall Drive
    High Generals Wood Rickleton
    NE38 9DB Washington
    Tyne & Wear
    English86483290001
    MILBURN, Peter Michael
    Derwent Lodge
    DH8 0TG Shotley Bridge
    County Durham
    Secretario
    Derwent Lodge
    DH8 0TG Shotley Bridge
    County Durham
    British36406380001
    DICKINSON DEES
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    Secretario designado corporativo
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    900005460001
    CARE, Timothy James
    West House Whorlton Hall Farm
    Westerhope
    NE5 1NP Newcastle Upon Tyne
    Director designado
    West House Whorlton Hall Farm
    Westerhope
    NE5 1NP Newcastle Upon Tyne
    British900005450001
    COUCH, Peter Quentin Patrick
    Amberley
    GL5 5AG Gloucestershire
    Follifoot House
    Director
    Amberley
    GL5 5AG Gloucestershire
    Follifoot House
    UkBritish156117090001
    DAVIS, Geoffrey Joseph
    17 Lintzford Road
    Hamsterley Mill Rowlands Gill
    NE39 1HA Newcastle Upon Tyne
    Director
    17 Lintzford Road
    Hamsterley Mill Rowlands Gill
    NE39 1HA Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritish65421150003
    DICKINSON, Rupert Jerome
    59 Albert Bridge Road
    SW11 4AQ London
    Director
    59 Albert Bridge Road
    SW11 4AQ London
    United KingdomBritish60267600001
    DICKINSON, Stephen
    Crow Hall
    NE47 7BJ Bardon Mill
    Northumberland
    Director
    Crow Hall
    NE47 7BJ Bardon Mill
    Northumberland
    United KingdomBritish8256950001
    FIELDER, James
    10 Bishops Road
    SW8 7AB London
    Director
    10 Bishops Road
    SW8 7AB London
    United KingdomBritish72574940002
    JOPLING, Nicholas Mark Fletcher
    Chipstead Street
    SW6 3SS London
    28
    Director
    Chipstead Street
    SW6 3SS London
    28
    EnglandBritish60099210003
    ON, Nicholas Peter
    The Links
    NE26 1RS Whitley Bay
    31
    Tyne And Wear
    Director
    The Links
    NE26 1RS Whitley Bay
    31
    Tyne And Wear
    United KingdomBritish135860930002
    SLADE, Sean Anthony
    Idlewood
    Maidenhead Road
    SL6 9DF Cookham
    Berkshire
    Director
    Idlewood
    Maidenhead Road
    SL6 9DF Cookham
    Berkshire
    British94640230001

    ¿Tiene GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 23 oct 2001
    Entregado el 08 nov 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The total principle sum of £1,575,000 together with all monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the legal charge
    Breve descripción
    F/H land and buildings at 179 high street lincoln t/no: LL27733.
    Personas con derecho
    • Sun Life Assurance Company of Canada (UK) Limited
    Transacciones
    • 08 nov 2001Registro de un cargo (395)
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge
    Creado el 22 jun 2001
    Entregado el 28 jun 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £12,501,016 and all other monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the provisions of the principal deeds (including for the avoidance of doubt the termination payment) and this charge
    Breve descripción
    By way of assignment to the lender the benefit f the deposit and subject to the reassignment of the deposit (or such of it is still subsisting and vested in the lender) on repayment to the lender of the loan in full.
    Personas con derecho
    • Prudential Annuities Limited
    Transacciones
    • 28 jun 2001Registro de un cargo (395)
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental deed of charge
    Creado el 30 sept 1999
    Entregado el 06 oct 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The principal sum of £5,607,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the legal charge dated 3RD april 1987 and further advances (the "loan") and £1,300,000 due or to become due from the company to the chargee (the "further advance")
    Breve descripción
    L/H property k/a 1-4 jubilee way winsford cheshire t/no: CH380718.
    Personas con derecho
    • Prudential Annuities Limited
    Transacciones
    • 06 oct 1999Registro de un cargo (395)
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge
    Creado el 26 may 1998
    Entregado el 28 may 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The principal sum of £5,607,000 together with any further advances made by the chargee pursuant to the provisions of the 1987 deed (as defined)
    Breve descripción
    L/Hold property known as queens parade,fountain court and dingle walk,winsford,cheshire; t/nos:CH287801,CH356569,CH384588 and CH402094; the benefit of all rights and/or buildings and all insurances thereto; see form 395 for full details. Undertaking and all property and assets.
    Personas con derecho
    • Prudential Annuities Limited
    Transacciones
    • 28 may 1998Registro de un cargo (395)
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of release and substitution
    Creado el 30 ene 1998
    Entregado el 17 feb 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The principal of and interest on the £3,000,000 11 3/4 per cent. First mortgage debenture stock 2024 and on the £15,000,000 10.5 per cent. First mortgage debenture stock 2024 of grainger trust P.L.C. due or to become due from the company to the chargee and all other monies intended to be secured by the above deed and existing deeds (as defined in the above deed) to which it is supplemental
    Breve descripción
    F/H property k/a 55 station road clacton.
    Personas con derecho
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transacciones
    • 17 feb 1998Registro de un cargo (395)
    • 24 feb 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of release and substitution
    Creado el 19 dic 1997
    Entregado el 05 ene 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    In favour of the chargee the principal of and interest on the £3,000,000 11 3/4 per cent. First mortgage debenture stock 2024 and on the £15,000,000 10.5 per cent. First mortgage debenture stock 2024 of grainger trust P.L.C. and all other moneys intended to be secured by the above deed and deeds dated 24TH february 1984, 23 december 1985, 26TH june 1986, 27TH november 1987, 27TH november 1987, 31ST march 1989, 30TH june 1994, 31ST march 1995, 29TH september 1995 and 13TH june 1997 to which it is supplemental
    Breve descripción
    By way of first legal mortgage f/h property on the south east side of hinckley road coventry t/n-WK352152 together with all buildings and erections and fixtures (including tenants' and trade fixtures) and fixed plant and machinery for the time being thereon belonging to it and all improvements and additions thereto.
    Personas con derecho
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transacciones
    • 05 ene 1998Registro de un cargo (395)
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of release and substitution
    Creado el 13 jun 1997
    Entregado el 17 jun 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The principal of and interest on the £3,000,000 11 3/4 per cent. First mortgage debenture stock 2024 and on the £15,000,000 10.5 per cent. First mortgage debenture stock 2024 of grainger trust PLC and all other monies intended to be secured by the deed of release and substitution and the deeds dated 24/2/84, 23/12/85, 26/6/86, 27/11/87, 27/11/87 ,31/3/89, 30/6/94, 31/3/95 and 29/9/95 to which it is supplemental
    Breve descripción
    The f/h properties k/a 179 high street lincoln and lancaster house 36 orchard street lincoln together with all buildings and fixtures fixed plant and machinery thereon.
    Personas con derecho
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transacciones
    • 17 jun 1997Registro de un cargo (395)
    • 24 feb 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 30 sept 1996
    Entregado el 10 oct 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of legal mortgage the l/h land comprising the shopping centre winsford cheshire t/n's CH287801, CH38458 and CH356569 together with all buildings and fixtures fixed plant and machinery thereon and assigns the goodwill of the business.
    Personas con derecho
    • Newcastle Building Society
    Transacciones
    • 10 oct 1996Registro de un cargo (395)
    • 19 sept 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of assignment of rents
    Creado el 30 sept 1996
    Entregado el 10 oct 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Assignment of the benefit of all rents, licence or tenancy fees payable by any lessee, licence or tenant of any part of the shopping centre winsford cheshire (as defined in the mortgage deed of even date).
    Personas con derecho
    • Newcastle Building Society
    Transacciones
    • 10 oct 1996Registro de un cargo (395)
    • 19 sept 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fourth supplemental trust deed
    Creado el 29 sept 1995
    Entregado el 04 oct 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The principal of and interest on the £3,000,000 11 3/4 per cent. First mortage debenture stock 2024 and on the £15,000,000 10.5 per cent. First mortgage debenture stock 2024 of grainger trust P.L.C. and all other moneys intended to be secured by the above deed and the existing deeds (as defined in the above deed) to which it is supplemental
    Breve descripción
    Freehold property known as land and buildings lying to the east of derby road,huyton,merseyside title number MS291314 and a floating charge over all property assets including any uncalled capital and all monies payable under the insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Guaradian Royal Exchange Assurance PLC
    Transacciones
    • 04 oct 1995Registro de un cargo (395)
    • 27 jun 1997Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 24 feb 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Floating charge
    Creado el 29 nov 1994
    Entregado el 12 dic 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 12 dic 1994Registro de un cargo (395)
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Acquisition of property
    Creado el 12 nov 1994
    Adquirido el 25 oct 1994
    Entregado el 12 nov 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £7,850,000
    Breve descripción
    Lancaster house 36 orchard street lincoln t/no LL46183.
    Personas con derecho
    • Friends Provident Life Office
    Transacciones
    • 12 nov 1994Registro de una adquisición (400)
    • 20 jul 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Acquisition of property
    Creado el 12 nov 1994
    Adquirido el 25 oct 1994
    Entregado el 12 nov 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £7,850,000
    Breve descripción
    Winsford town centre cheshire t/no CH287801.
    Personas con derecho
    • Friends Provident Life Office
    Transacciones
    • 12 nov 1994Registro de una adquisición (400)
    • 19 sept 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    "C" loan notes charge
    Creado el 08 nov 1994
    Adquirido el 25 oct 1994
    Entregado el 08 nov 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due
    Breve descripción
    179 high street lincoln t/no LL27733. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Caroline Patricia Darley Nicola Margaret Combes Rebecca Charlotte Baronas Trustees
    Transacciones
    • 08 nov 1994Registro de una adquisición (400)
    • 20 jul 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    "C" loan notes charge
    Creado el 08 nov 1994
    Adquirido el 25 oct 1994
    Entregado el 08 nov 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due
    Breve descripción
    F/H property k/a lancaster house lincoln t/no LL46183 and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Caroline Patricia Darley Nicola Margaret Combes Rebecca Charlotte Baronas Trustees
    Transacciones
    • 08 nov 1994Registro de una adquisición (400)
    • 20 jul 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 22 sept 1988
    Adquirido el 14 jun 1995
    Entregado el 04 jul 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £6,850,000.00
    Breve descripción
    Land and buildings at queens parade fountain court and dingle walk winsford cheshire t/n-CH287801, CH384588 and CH356569.
    Personas con derecho
    • Freinds Provident Life Office
    Transacciones
    • 04 jul 1995Registro de una adquisición (400)
    • 19 sept 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0