TAIT TECHNOLOGIES UK LTD
Visión general
| Nombre de la empresa | TAIT TECHNOLOGIES UK LTD |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02962782 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de TAIT TECHNOLOGIES UK LTD?
- fabricación de otros equipos eléctricos (27900) / Industrias manufactureras
- fabricación de otras maquinarias de propósito especial n.c.o.p. (28990) / Industrias manufactureras
- Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. (74909) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra TAIT TECHNOLOGIES UK LTD?
| Dirección de la sede social | Unit 5 Langthwaite Road Langthwaite Grange Ind. Estate South Kirkby WF9 3AP Pontefract West Yorkshire England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TAIT TECHNOLOGIES UK LTD?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| STAGE TECHNOLOGIES LIMITED | 09 sept 1994 | 09 sept 1994 |
| OFFERSOLID LIMITED | 26 ago 1994 | 26 ago 1994 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de TAIT TECHNOLOGIES UK LTD?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para TAIT TECHNOLOGIES UK LTD?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 25 ago 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 08 sept 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 25 ago 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para TAIT TECHNOLOGIES UK LTD?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 25 ago 2025 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 36 páginas | AA | ||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 20 dic 2024
| 3 páginas | SH01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 36 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 25 ago 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Unit 5 Langthwaite Road Langthwaite Grange Ind. Estate South Kirkby Pontefract West Yorkshire WR9 3AP England a Unit 5 Langthwaite Road Langthwaite Grange Ind. Estate South Kirkby Pontefract West Yorkshire WF9 3AP el 15 feb 2024 | 1 páginas | AD01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 9 Falcon Park Neasden Lane London NW10 1RZ a Unit 5 Langthwaite Road Langthwaite Grange Ind. Estate South Kirkby Pontefract West Yorkshire WR9 3AP el 09 feb 2024 | 1 páginas | AD01 | ||
Nombramiento de Ramon Enrique Mercedes como director el 27 dic 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Kerri Mcclellan como director el 16 oct 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 25 ago 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 35 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Ulrike Schachner-Dadley como director el 19 jul 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Ben Hayden Brooks como director el 25 may 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Alistair James Bell como director el 03 mar 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 35 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 25 ago 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Kerri Mcclellan como director el 11 may 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Mary June Huwaldt como director el 11 may 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 34 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 25 ago 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mary June Huwaldt como director el 05 feb 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Scott Macomb Marimow como director el 05 feb 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Michael Joseph Dominguez como director el 05 feb 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 34 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Mary June Huwaldt como director el 20 nov 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de TAIT TECHNOLOGIES UK LTD?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROOKS, Ben Hayden | Director | Langthwaite Road, Langthwaite Grange Ind Estate South Kirkby WF9 3AP Pontefract Unit 5 West Yorkshire England | England | British | 309683800001 | |||||
| DAVIS, Adam Douglas | Director | Langthwaite Grange Ind. Estate South Kirkby WF9 3AP Pontefract Unit 5 Langthwaite Road West Yorkshire England | United States | American | 187090860001 | |||||
| MERCEDES, Ramon Enrique | Director | 401 W. Lincoln Ave. 17543 Lititz Tait Towers Manufacturing Llc Pa United States | United States | American | 317581530001 | |||||
| RATHSAM, Robert Carl | Director | c/o Tait W. Lincoln Avenue 17543 Lititz 401 Pennsylvania United States | United States | American | 264398060001 | |||||
| COLBERT, David John | Secretario | 9 Falcon Park Neasden Lane NW10 1RZ London | 186989510001 | |||||||
| GARRARD, Ian Malcolm | Secretario | 2 Athol Gardens HA5 3XQ Pinner Middlesex | British | 63045530001 | ||||||
| HASTIE, John Allen | Secretario | 18 Cromer Road WD2 5AD Watford | British | 37859430001 | ||||||
| SCOTT, Nicola Jane | Secretario | 6 Coopers Mews High Elms Lane WD25 0JD Watford | Uk | 62930880005 | ||||||
| TIMS, Kevin | Secretario | 9 Falcon Park Neasden Lane NW10 1RZ London | 199813330001 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| AGER, Mark Allan Nicolas | Director | 9 Falcon Park Neasden Lane NW10 1RZ London | England | British | 37859510005 | |||||
| BELL, Alistair James | Director | 9 Falcon Park Neasden Lane NW10 1RZ London | England | British | 259342290001 | |||||
| BERNSTEIN, David Charles | Director | 9 Falcon Park Neasden Lane NW10 1RZ London | United States | American | 120929410001 | |||||
| BUCKINGHAM, Lee George | Director | Homefield Road CB9 8QP Haverhill Homefield Road England | England | British | 259341920001 | |||||
| COLBERT, David John | Director | 36 Butterfield Road Wheathampstead AL4 8QH St Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | 63946830001 | |||||
| DALCO, Matthew George John | Director | 69 Cloncurry Street SW6 6DT London | Australian | 70378570002 | ||||||
| DICARLO, Benjamin Gerard | Director | 9 Falcon Park Neasden Lane NW10 1RZ London | United States | American | 238598910001 | |||||
| DICARLO, Benjamin Gerard | Director | 9 Falcon Park Neasden Lane NW10 1RZ London | United States | American | 238598910001 | |||||
| DOMINGUEZ, Michael Joseph | Director | c/o Providence Equity Partners L.L.C. Kennedy Plaza, 18th Floor 02903 Providence 50 Rhode Island United States | United States | American | 259480440001 | |||||
| GOLDING, Adam Kenneth | Director | 9 Falcon Park Neasden Lane NW10 1RZ London | England | British | 149751770002 | |||||
| GOLDING, Kenneth | Director | Street Farm The Street, Horringer IP29 5SN Bury St Edmunds Suffolk | United Kingdom | British | 123810680001 | |||||
| GUHL, Timothy Edward | Director | 9 Falcon Park Neasden Lane NW10 1RZ London | Usa | Usa | 232337590001 | |||||
| GUHL, Timothy Edward | Director | 9 Falcon Park Neasden Lane NW10 1RZ London | Usa | Usa | 232337590001 | |||||
| HARRIS, Jeremiah | Director | 80 Innisbrook Ave Las Vegas Nevada 89113 Usa | American | 42290050002 | ||||||
| HASTIE, John Allen | Director | 53 Jubilee Road WD24 5HJ Watford Hertfordshire | United Kingdom | British | 37859430002 | |||||
| HUWALDT, Mary June | Director | 401 W. Lincoln Ave. 17543 Lititz Tait Pa United States | United States | American | 279392660001 | |||||
| HUWALDT, Mary June | Director | 9 Falcon Park Neasden Lane NW10 1RZ London | United States | American | 251598400001 | |||||
| MARIMOW, Scott Macomb | Director | c/o Providence Equity Partners L.L.C. Kennedy Plaza, 18th Floor 02903 Providence 50 Rhode Island United States | United States | American | 259480460001 | |||||
| MCCALLUM, Martin Jeffrey | Director | 110 Elgin Crescent W11 2JL London | United Kingdom | British | 35929230003 | |||||
| MCCLELLAN, Kerri | Director | 401 W Lincoln Ave 17543 Lititz Tait Pa United States | United States | American | 296002820001 | |||||
| MOORE, Edward Robin | Director | 168 New Road SL5 8QH Ascot Berks | England | British | 100928580002 | |||||
| PEACOCK, William Eric, Sir | Director | Bury Rise Bovington HP3 0DN Hemel Hempstead Green Fallow Hertfordshire England | England | British | 134784200001 | |||||
| RICHARDSON, Ewart | Director | 1 Furze View WD3 5HT Chorleywood Herts | United Kingdom | British | 88064030002 | |||||
| SCHACHNER-DADLEY, Ulrike | Director | 9 Falcon Park Neasden Lane NW10 1RZ London | England | Austrian | 241505100001 | |||||
| SCOTT, Nicola Jane | Director | 9 Falcon Park Neasden Lane NW10 1RZ London | United Kingdom | Uk | 62930880005 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de TAIT TECHNOLOGIES UK LTD?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tait International Ltd. | 06 abr 2016 | Neasden Lane NW10 1RZ London 9 Falcon Park Industrial Estate | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0