FIRST RETAIL FINANCE (CHESTER) LTD
Visión general
| Nombre de la empresa | FIRST RETAIL FINANCE (CHESTER) LTD |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02964970 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de FIRST RETAIL FINANCE (CHESTER) LTD?
- Intermediación financiera no clasificada en otra parte (64999) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra FIRST RETAIL FINANCE (CHESTER) LTD?
| Dirección de la sede social | Trinity Road Halifax HX1 2RG |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de FIRST RETAIL FINANCE (CHESTER) LTD?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| RASHPAL LIMITED | 13 ene 1995 | 13 ene 1995 |
| I.M. FINANCIAL SERVICES LIMITED | 02 sept 1994 | 02 sept 1994 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de FIRST RETAIL FINANCE (CHESTER) LTD?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 jun 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 mar 2027 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para FIRST RETAIL FINANCE (CHESTER) LTD?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 04 ene 2027 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 18 ene 2027 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 04 ene 2026 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para FIRST RETAIL FINANCE (CHESTER) LTD?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2025 | 17 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 ene 2026 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Sean Davidson como director el 22 dic 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Simon John Caddick como director el 22 dic 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 16 jun 2025
| 3 páginas | SH01 | ||
Cambio de datos del secretario Alyson Elizabeth Mulholland el 12 may 2025 | 1 páginas | CH03 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2024 | 17 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 ene 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 ene 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2023 au 30 jun 2024 | 1 páginas | AA01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 18 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Dr Stephen John Price el 22 abr 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 ene 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 16 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 ene 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Dr Stephen John Price como director el 12 nov 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Miranda Clare Armstrong como director el 01 oct 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 16 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 ene 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Sara Jayne Bayley como director el 02 nov 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 16 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 ene 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Miss Miranda Armstrong como director el 07 nov 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Thomas David Benfield como director el 07 nov 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN United Kingdom a Cawley House Chester Business Park Chester CH4 9FB | 1 páginas | AD02 | ||
¿Quiénes son los directivos de FIRST RETAIL FINANCE (CHESTER) LTD?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULHOLLAND, Alison Elizabeth | Secretario | Chester Business Park CH4 9FB Chester Cawley House United Kingdom | 240726380002 | |||||||
| DAVIDSON, Sean | Director | HX1 2RG Halifax Trinity Road West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 343804850001 | |||||
| PRICE, Stephen John, Dr | Director | London Wall EC2Y 5AS London 125 United Kingdom | United Kingdom | British | 289624800002 | |||||
| GITTINS, Paul | Secretario | House Charterhall Drive CH88 3AN Chester Tower United Kingdom | 164928380001 | |||||||
| GITTINS, Paul | Secretario | 5 Hambledon Close Little Sutton L66 4YF South Wirral | British | 45660860002 | ||||||
| JOHNSON, Michelle Antoinette Angela | Secretario | Tower House Charterhall Drive CH88 3AN Chester 1st Floor East England England | 214588740001 | |||||||
| LAKIN, Helen Mary | Secretario | Gorphwysfa 6 Nant Road Bwlchgwyn LL11 5YN Wrexham Clwyd | British | 41250190001 | ||||||
| LOCKWOOD, Angela | Secretario | Lloyds Banking Group Trinity Road HX1 2RG Halifax C/O Retail Company Secretaries United Kingdom | British | 115797910001 | ||||||
| MAYER, Sally | Secretario | 48 Prospect Street Shibden Heights HX3 6LG Halifax | British | 75435950002 | ||||||
| NIXON, Raymond | Secretario | Holly House The Steadings Wicker Lane, Guilden Sutton CH3 7EL Chester Cheshire | British | 36433110016 | ||||||
| PHILLIPS, Elissa Leah | Secretario | Maydencroft, Well Lane Rawdon LS19 6DU Leeds West Yorkshire | British | 108872910001 | ||||||
| SOBO, Femi | Secretario | 5 Carr Bridge View Cookridge LS16 7BR Leeds | British | 55778050002 | ||||||
| ARMSTRONG, Miranda Clare | Director | London Wall EC2Y 5AS London 125 United Kingdom | United Kingdom | New Zealander | 160805300006 | |||||
| ASTBURY, Mark Harvey Ayrton | Director | 6 Blinco Grove CB1 7TS Cambridge Cambridgeshire | British | 101313750001 | ||||||
| BAYLEY, Sara Jayne | Director | Tresillian Terrace CF10 5BH Cardiff St William House United Kingdom | United Kingdom | British | 238307600001 | |||||
| BENFIELD, Thomas David | Director | 125 London Wall EC2Y 5AS London 12th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 237616370002 | |||||
| CADDICK, Simon John | Director | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | England | British | 200716610001 | |||||
| CAMPBELL, Ian Peter | Director | 15 Beech Walk Adel LS16 8NY Leeds West Yorkshire | England | British | 94886060001 | |||||
| DOWSON, Andrew Graham | Director | 3 Lime Tree Avenue LS23 6DP Boston Spa West Yorkshire | United Kingdom | British | 86525780001 | |||||
| FAIRBANK, Stephen | Director | 60 St Margarets Avenue HU16 5NF Cottingham North Humberside | British | 11969980001 | ||||||
| GITTINS, Paul | Director | 5 Hambledon Close Little Sutton L66 4YF South Wirral | British | 45660860002 | ||||||
| HUNTER-BROWN, John Piers | Director | 5th Floor 33 Old Broad Street EC2N 1HZ London Lloyds Banking Group England England | United Kingdom | British | 164758160001 | |||||
| HUTCHINSON, Glenn | Director | 27 Bridge Drive Christleton CH3 6AW Chester Cheshire | British | 76319640002 | ||||||
| JAMIESON, Paul Nelson | Director | Lloyds Banking Group Trinity Road HX1 2RG Halifax C/O Retail Company Secretaries United Kingdom | United Kingdom | British | 104540730001 | |||||
| JONES, David Charles, Sir | Director | Whinbrae Wheatley Lane Ben Rhydding LS29 8SF Ilkley West Yorkshire | England | British | 11515940001 | |||||
| KEENS, David Wilson | Director | Dingley House 25 Harborough Road Dingley LE16 8PQ Market Harborough Leicestershire | United Kingdom | British | 33208710003 | |||||
| LAKIN, Helen Mary | Director | Gorphwysfa 6 Nant Road Bwlchgwyn LL11 5YN Wrexham Clwyd | Britain | British | 41250190001 | |||||
| LEAMAN, Andrew Stephen | Director | 4 Willow Court Well Lane, Mollington CH1 6LD Chester | British | 48906540002 | ||||||
| LITTLER, Roy | Director | 3 The Paddock Curzon Park CH4 8AE Chester Cheshire | British | 2211250001 | ||||||
| MAYNARD, Kenneth William | Director | 18 Arundel Way CM12 0FL Billericay Essex | British | 71241260001 | ||||||
| MEE, Robert James | Director | 1 Feilden Court Mollington CH1 6LS Chester | England | British | 92913850001 | |||||
| MURRAY, Craig William | Director | Green Mantle 59 Birdston Road Milton Of Campsie G66 8BX Glasgow Lanarkshire | England | British | 153923750001 | |||||
| OAKES, Peter Roy | Director | 10 Leamington Road West Heath CW12 4PF Congleton | British | 33210520001 | ||||||
| ROWE, Steven Alan | Director | 1 Cedar Park Vicars Cross CH3 5PW Chester Cheshire | British | 42336230001 | ||||||
| ROWLEY, James Edward | Director | 6 Shotwick Park Seahill Road Saughall CH1 6GA Chester Cheshire | Uk | British | 146169390001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de FIRST RETAIL FINANCE (CHESTER) LTD?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Of Scotland Plc | 06 abr 2016 | EH1 1YZ Edinburgh The Mound United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0