CATLIN UNDERWRITING

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCATLIN UNDERWRITING
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad privada sin límite de capital
    Número de empresa 02966836
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CATLIN UNDERWRITING?

    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra CATLIN UNDERWRITING?

    Dirección de la sede social
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CATLIN UNDERWRITING?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CATLIN UNDERWRITING PLC04 jun 200704 jun 2007
    WELLINGTON UNDERWRITING PLC06 sept 199406 sept 1994

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CATLIN UNDERWRITING?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CATLIN UNDERWRITING?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    8 páginasLIQ13

    Cancelación total de la carga 7

    4 páginasMR04

    Domicilio social registrado cambiado de 20 Gracechurch Street London EC3V 0BG a 30 Finsbury Square London EC2A 1AG el 30 sept 2021

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 23 sept 2021

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020

    16 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 28 feb 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    17 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 28 feb 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Christopher John Read como director el 05 feb 2020

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Paul Richard Bradbrook como director el 05 feb 2020

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Craig Standen como director el 17 dic 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Juliet Phillips como director el 17 dic 2019

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    18 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 28 feb 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    16 páginasAA

    Cese del nombramiento de Paul Andrew Jardine como director el 26 sept 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Clynton Jacobus Luttig como director el 26 sept 2018

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Miss Juliet Phillips como director el 26 sept 2018

    2 páginasAP01

    Cessation de Xl Group Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 12 sept 2018

    1 páginasPSC07

    Notification de Axa Sa en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 12 sept 2018

    2 páginasPSC02

    Declaración de confirmación presentada el 28 feb 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    15 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de CATLIN UNDERWRITING?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    REES, Marie Louise
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Secretario
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    201064360001
    LUTTIG, Clynton Jacobus
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Director
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    EnglandBritish218565170001
    READ, Christopher John
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Director
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    United KingdomBritish267508980001
    STANDEN, Craig
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Director
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    United KingdomBritish265497100001
    BUSHER, Thomas George Story
    Manor Farm Cottage School Hill
    Soberton
    SO32 3PF Southampton
    Hampshire
    Secretario
    Manor Farm Cottage School Hill
    Soberton
    SO32 3PF Southampton
    Hampshire
    British6386010002
    GLOVER, Michael Logan
    Dunelm
    41. St. Catherines Road
    EN10 7LD Broxbourne
    Herts
    Secretario
    Dunelm
    41. St. Catherines Road
    EN10 7LD Broxbourne
    Herts
    British94249710001
    GRAHAM, Nicola Geraldine
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    Secretario
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    British122081730001
    NOONE, Lisa Marie
    8 Paget Road
    IP1 3RP Ipswich
    Suffolk
    Secretario
    8 Paget Road
    IP1 3RP Ipswich
    Suffolk
    British72182310002
    THOMAS, Heather Irene
    5 Lambert Jones Mews
    Barbican
    EC2Y 8DP London
    Secretario
    5 Lambert Jones Mews
    Barbican
    EC2Y 8DP London
    British105936240001
    NOBLE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    Secretario corporativo
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    94907480001
    AGNEW, Ian Charles
    23 Chalfont House
    19 Chesham Street
    SW1X 8NG London
    Director
    23 Chalfont House
    19 Chesham Street
    SW1X 8NG London
    British6418620003
    AVERY, Julian Ralph
    Little Boarzell
    Hurst Green
    TN19 7QU Etchingham
    East Sussex
    Director
    Little Boarzell
    Hurst Green
    TN19 7QU Etchingham
    East Sussex
    United KingdomUk37578750001
    BARTON, Robert John Orr
    33 Rutland Court
    Rutland Gardens
    SW7 1BW London
    Director
    33 Rutland Court
    Rutland Gardens
    SW7 1BW London
    British7999080003
    BRADBROOK, Paul Richard
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    Director
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United KingdomBritish148983260001
    BURKE, Martin Thomas
    Albany, 26 Leafy Way
    Hutton
    CM13 2QW Brentwood
    Essex
    Director
    Albany, 26 Leafy Way
    Hutton
    CM13 2QW Brentwood
    Essex
    United KingdomIrish240344510001
    BURROWS, Timothy William
    37 Northumberland Road
    New Barnet
    EN5 1EB Barnet
    Hertfordshire
    Director
    37 Northumberland Road
    New Barnet
    EN5 1EB Barnet
    Hertfordshire
    United KingdomBritish126815810002
    BUSHER, Thomas George Story
    Manor Farm Cottage School Hill
    Soberton
    SO32 3PF Southampton
    Hampshire
    Director
    Manor Farm Cottage School Hill
    Soberton
    SO32 3PF Southampton
    Hampshire
    British6386010002
    CALLAN, Robert
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    Director
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    United KingdomBritish130365420001
    CUSACK, Julian Michael
    3 Eastern Close
    Rushmere St. Andrew
    IP4 5BY Ipswich
    Suffolk
    Director
    3 Eastern Close
    Rushmere St. Andrew
    IP4 5BY Ipswich
    Suffolk
    British84410430001
    DUMAS, Henry Raymond
    Coldharbour Farm
    BS30 5RJ Wick
    South Gloucestershire
    Director
    Coldharbour Farm
    BS30 5RJ Wick
    South Gloucestershire
    British73016630001
    ENGESTROM, John
    Yardley Farm
    Chequers Lane
    LU7 9AG Pitstone
    Buckinghamshire
    Director
    Yardley Farm
    Chequers Lane
    LU7 9AG Pitstone
    Buckinghamshire
    Swedish67286160004
    FOREMAN, David Peter
    Ringers Farm
    Russ Hill Road Charlwood
    RH6 0EW Horley
    Surrey
    Director
    Ringers Farm
    Russ Hill Road Charlwood
    RH6 0EW Horley
    Surrey
    EnglandBritish121083690001
    FRESHWATER, Neil Andrew, Mr.
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    Director
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    EnglandBritish125646370001
    FULKERSON, Allan White
    P.O.Box 149
    Center Sandwich
    03227 New Hampshire
    Usa
    Director
    P.O.Box 149
    Center Sandwich
    03227 New Hampshire
    Usa
    Usa62315920001
    GEFERS, Robert Bruce
    34 Stokenchurch Street
    SW6 3TR London
    Director
    34 Stokenchurch Street
    SW6 3TR London
    American61931140001
    HAMILTON, Paul Richard
    Hole Farm
    Wilderness Lane
    TN22 4HB Hadlow Down
    East Sussex
    Director
    Hole Farm
    Wilderness Lane
    TN22 4HB Hadlow Down
    East Sussex
    United KingdomBritish84274310001
    HANCE, Julian Christopher
    Brackenfell South Bank
    BN6 8JP Hassocks
    West Sussex
    Director
    Brackenfell South Bank
    BN6 8JP Hassocks
    West Sussex
    United KingdomBritish40271690002
    HAYNES, Joseph Antony
    40 Edwardes Square
    W8 6HH London
    Director
    40 Edwardes Square
    W8 6HH London
    British9580170001
    HEFTI, Wilhelm Hendrik
    St Georgenstrasse 41
    Ch 8400 Winterthur
    Switzerland
    Director
    St Georgenstrasse 41
    Ch 8400 Winterthur
    Switzerland
    Swiss84654940001
    IBESON, David Christopher Ben
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    Director
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    United KingdomBritish52745170002
    JARDINE, Paul Andrew
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    Director
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    EnglandBritish62337170003
    LETSINGER, Katherine Lee
    55 Northumberland Place
    W2 5AS London
    Director
    55 Northumberland Place
    W2 5AS London
    United KingdomBritish54716770009
    MAXWELL, John Hunter
    17 Cliveden Place
    SW1W 8LA London
    Director
    17 Cliveden Place
    SW1W 8LA London
    British86357670001
    O'KANE, Charles Christopher
    107 Albert Street
    NW1 7NB London
    Director
    107 Albert Street
    NW1 7NB London
    United KingdomBritish61931210002
    PHILLIPS, Juliet
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    Director
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United KingdomBritish211555110001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CATLIN UNDERWRITING?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Axa Sa
    Avenue Matignon
    75008 Paris
    25
    France
    12 sept 2018
    Avenue Matignon
    75008 Paris
    25
    France
    No
    Forma jurídicaCorporate
    País de registroFrance
    Autoridad legalFrance
    Lugar de registroCentre De Formalites Des Entreprises
    Número de registro572093920 Rcs
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    Xl Group Ltd
    One Bermudiana Road
    HM08 Hamilton
    O'Hara House
    Bermuda
    25 jul 2016
    One Bermudiana Road
    HM08 Hamilton
    O'Hara House
    Bermuda
    Forma jurídicaCorporate
    País de registroBermuda
    Autoridad legalBermuda
    Lugar de registroBermuda
    Número de registro51235
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    Xl Group Plc
    8 St. Stephens Green
    Dublin 2
    Xl House
    Ireland
    06 abr 2016
    8 St. Stephens Green
    Dublin 2
    Xl House
    Ireland
    Forma jurídicaCorporate
    País de registroIreland
    Autoridad legalIreland
    Lugar de registroIreland
    Número de registro482042
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene CATLIN UNDERWRITING alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 19 mar 2007
    Entregado el 28 mar 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties
    Transacciones
    • 28 mar 2007Registro de un cargo (395)
    • 20 may 2011Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    • 14 may 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    A security agreement
    Creado el 11 dic 2003
    Entregado el 22 dic 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the trustee or any of the other banks under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first fixed charge all the right title and interest in to and under the charged property and all of the companys right title and interest in and to the assigned property. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 22 dic 2003Registro de un cargo (395)
    • 04 abr 2006Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 02 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 11 dic 2003
    Entregado el 22 dic 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 22 dic 2003Registro de un cargo (395)
    • 04 abr 2006Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 04 abr 2006Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 02 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security assignment
    Creado el 11 dic 2003
    Entregado el 19 dic 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the assignee (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All or its right, title and interest, present and future, in, under and to the contract including, without limitation, all present and future claims, causes of action, payments and proceeds in respect thereof.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 19 dic 2003Registro de un cargo (395)
    • 04 abr 2006Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 02 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 24 ago 1998
    Entregado el 27 ago 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents (as defined) and this debenture
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC,as Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transacciones
    • 27 ago 1998Registro de un cargo (395)
    • 28 ene 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 16 jul 1997
    Entregado el 29 jul 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 29 jul 1997Registro de un cargo (395)
    • 11 ago 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 17 abr 1997
    Entregado el 23 abr 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 23 abr 1997Registro de un cargo (395)
    • 08 jul 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene CATLIN UNDERWRITING algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    23 sept 2021Inicio de la liquidación
    05 nov 2022Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Sean Kenneth Croston
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Profesional
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0