ACCORD ASSET MANAGEMENT LIMITED

ACCORD ASSET MANAGEMENT LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaACCORD ASSET MANAGEMENT LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02967532
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ACCORD ASSET MANAGEMENT LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra ACCORD ASSET MANAGEMENT LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Chancery Exchange
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ACCORD ASSET MANAGEMENT LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    JOHN DOYLE MAINTENANCE LIMITED04 nov 199404 nov 1994
    DETAILSTOCK LIMITED14 sept 199414 sept 1994

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ACCORD ASSET MANAGEMENT LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ACCORD ASSET MANAGEMENT LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr Andrew Latham Nelson el 25 nov 2021

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020

    16 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019

    16 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Paul Birch el 16 ene 2020

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Andrew Lee Milner como director el 12 dic 2019

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    12 páginasAA

    Cambio de datos del secretario Sherard Secretariat Services Limited el 02 sept 2019

    1 páginasCH04

    Modification des détails de Accord Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 sept 2019

    2 páginasPSC05

    Domicilio social registrado cambiado de The Sherard Building Edmund Halley Road Oxford OX4 4DQ a Chancery Exchange 10 Furnival Street London EC4A 1AB el 02 sept 2019

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    11 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2017 con actualizaciones

    3 páginasCS01

    Modification des détails de Accord Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016

    2 páginasPSC05

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    11 páginasAA

    Nombramiento de Mr Paul Birch como director el 12 may 2017

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    10 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de ACCORD ASSET MANAGEMENT LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro5615519
    109588620001
    BIRCH, Paul
    142 Speke Road
    L19 2PH Liverpool
    The Matchworks
    England
    England
    Director
    142 Speke Road
    L19 2PH Liverpool
    The Matchworks
    England
    England
    United KingdomBritish76116640004
    NELSON, Andrew Latham
    Chancery Exchange
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Amey
    United Kingdom
    Director
    Chancery Exchange
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Amey
    United Kingdom
    EnglandBritish36191090004
    BIRCH, Paul
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Secretario
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    British76116640002
    HARVEY, Stephen George
    163 High Road
    EN10 7BT Broxbourne
    Hertfordshire
    Secretario
    163 High Road
    EN10 7BT Broxbourne
    Hertfordshire
    British67162750001
    KELLY, Paula Frona
    12 Chells Lane
    SG2 7AA Stevenage
    Herts
    Secretario
    12 Chells Lane
    SG2 7AA Stevenage
    Herts
    British95469920001
    PRYOR, Peter David
    Jay Cottage
    Little Hormead
    SG9 0LZ Buntingford
    Hertfordshire
    Secretario
    Jay Cottage
    Little Hormead
    SG9 0LZ Buntingford
    Hertfordshire
    British67736270003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ABBEY, Geoffrey Michael
    The Habit
    The Street
    SG11 2QR Braughing
    Hertfordshire
    Director
    The Habit
    The Street
    SG11 2QR Braughing
    Hertfordshire
    British65112520001
    ARNOLD, David Llewelyn
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritish181213200001
    ATHERTON, David
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish109058740001
    CHASTON, Stuart Paul
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritish126271790001
    CHEETHAM, James Richard
    Ashfield
    Weston Rhyn
    SY10 7SD Oswestry
    Salop
    Director
    Ashfield
    Weston Rhyn
    SY10 7SD Oswestry
    Salop
    British45753210001
    EWELL, Melvyn
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Director
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    EnglandBritish61515760002
    FARRAR, Roland Martin
    40 Chiltern Road
    SL6 1XA Maidenhead
    Berkshire
    Director
    40 Chiltern Road
    SL6 1XA Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritish29009510002
    FELLOWES PRYNNE, Philip Windover
    76 The Shearers
    St Michaels Mead
    CM23 4AZ Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Director
    76 The Shearers
    St Michaels Mead
    CM23 4AZ Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British80861440001
    FRASER, Ian Ellis
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    ScotlandUk28393850006
    JOYCE, Martin John
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish72254420003
    KIRKBY, Neil Robert Ernest
    5 Dashwood Close
    Grappenhall
    WA4 3JA Warrington
    Cheshire
    Director
    5 Dashwood Close
    Grappenhall
    WA4 3JA Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish51438040006
    MCLAUGHLIN, Owen Gerard
    Greyfriars Hall
    Walker Lane Fulwood
    PR2 7AN Preston
    Lancashire
    Director
    Greyfriars Hall
    Walker Lane Fulwood
    PR2 7AN Preston
    Lancashire
    United KingdomBritish17129800004
    MILLER, Paul Sydney
    26 Mardley Hill
    AL6 0TS Welwyn
    Hertfordshire
    Director
    26 Mardley Hill
    AL6 0TS Welwyn
    Hertfordshire
    British39022040001
    MILNER, Andrew Lee
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Director
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    EnglandBritish133714170002
    PRYOR, Peter David
    Jay Cottage
    Little Hormead
    SG9 0LZ Buntingford
    Hertfordshire
    Director
    Jay Cottage
    Little Hormead
    SG9 0LZ Buntingford
    Hertfordshire
    EnglandBritish67736270003
    SHUTKEVER, Adam Emmanuel
    11 Oakfield Road
    AL5 2NJ Harpenden
    Herts
    Director
    11 Oakfield Road
    AL5 2NJ Harpenden
    Herts
    United KingdomBritish81455510002
    STEFANOU, Stefanos
    13 Park Mews
    AL9 5EP Hatfield
    Hertfordshire
    Director
    13 Park Mews
    AL9 5EP Hatfield
    Hertfordshire
    EnglandBritish44867700001
    STEFANOU, Stelio Haralambos
    1 Tewin Water House
    Tewin Water
    AL6 0AA Welwyn
    Hertfordshire
    Director
    1 Tewin Water House
    Tewin Water
    AL6 0AA Welwyn
    Hertfordshire
    United KingdomBritish2749630007
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ACCORD ASSET MANAGEMENT LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    United Kingdom
    06 abr 2016
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro3693911
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene ACCORD ASSET MANAGEMENT LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 12 nov 2007
    Entregado el 28 nov 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become from each obligor and each grantor of security to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee, Richard Butcher as Pension Trustee, Pitman Trusteeslimited as Pension Trustee, Philip Bridge as Pension Trustee and Each of Their Assignors Transferees and Successiors from Time to Time
    Transacciones
    • 28 nov 2007Registro de un cargo (395)
    • 02 jul 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Security agreement
    Creado el 20 dic 2006
    Entregado el 22 dic 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each chargor to the finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All the security created under the deed. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 22 dic 2006Registro de un cargo (395)
    • 29 sept 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A guarantee and debenture
    Creado el 25 jun 1999
    Entregado el 05 jul 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All the present and/or future obligations and liabilities due or to become due from the company to national westminster bank PLC as agent and trustee for the secured parties (the "security trustee") and any of the secured parties (as defined) under or pursuant to any of the financing documents (as defined)(including the debenture)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 05 jul 1999Registro de un cargo (395)
    • 19 sept 2003Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 11 nov 2003Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 10 ene 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 31 mar 1995
    Entregado el 04 abr 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 04 abr 1995Registro de un cargo (395)
    • 19 sept 2003Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 11 nov 2003Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 10 ene 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0