LIGHT HOUSE MEDIA CENTRE
Visión general
| Nombre de la empresa | LIGHT HOUSE MEDIA CENTRE |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited' |
| Número de empresa | 02971032 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de LIGHT HOUSE MEDIA CENTRE?
- Restaurantes con licencia (56101) / Actividades de alojamiento y de servicios de comida
- Actividades de proyección de películas cinematográficas (59140) / Información y comunicación
- Educación cultural (85520) / Educación
- Explotación de instalaciones artísticas (90040) / Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
¿Dónde se encuentra LIGHT HOUSE MEDIA CENTRE?
| Dirección de la sede social | Cavendish House 39-41 Waterloo Street B2 5PP Birmingham |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de LIGHT HOUSE MEDIA CENTRE?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 29 sept 2020 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para LIGHT HOUSE MEDIA CENTRE?
| Última declaración de confirmación | |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 27 sept 2021 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para LIGHT HOUSE MEDIA CENTRE?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores | 17 páginas | LIQ14 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Destitución del liquidador por orden judicial | 12 páginas | LIQ10 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 22 ene 2024 | 16 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||||||||||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de The Chubb Buildings Fryer Street Wolverhampton WV1 1HT a Cavendish House 39-41 Waterloo Street Birmingham B2 5PP el 31 ene 2023 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 4 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de asuntos | 11 páginas | LIQ02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Humbley como director el 25 feb 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 27 sept 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 29 sept 2020 | 36 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 29 sept 2019 | 33 páginas | AA | ||||||||||
Exercice comptable en cours raccourci du 30 sept 2019 au 29 sept 2019 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 23 sept 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Exercice comptable en cours raccourci du 30 sept 2020 au 29 sept 2020 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mrs Kate Copestake el 18 may 2020 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Alex Jones como director el 29 ene 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Humbley como director el 06 feb 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Tara Rosalind Roseblade como director el 29 ene 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Natasha George como director el 29 ene 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Kate Copestake como director el 17 dic 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Paul Humbley como director el 17 dic 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de LIGHT HOUSE MEDIA CENTRE?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEFFS, Kelly Jayne | Secretario | 39-41 Waterloo Street B2 5PP Birmingham Cavendish House | 170144860001 | |||||||
| COPESTAKE, Catherine | Director | Wightwick Bank WV6 8DR Wolverhampton The House In The Trees England | England | British | 266639040002 | |||||
| JONES, Alex | Director | Kingsway Road WV10 0SU Wolverhampton 85 England | England | British | 266903090001 | |||||
| KELLY, Ronald William | Director | Mount Road Penn WV4 5SW Wolverhampton 46 West Midlands | England | English | 129530890001 | |||||
| CHALLENGER, Frank Cyril | Secretario | Church Walk Penn Fields WV3 7BY Wolverhampton 30 England | British | 90714680001 | ||||||
| BARKER, Susan | Director | West Farmhouse Ruckley SY5 7HR Acton Burnell Shropshire | British | 28240340001 | ||||||
| CLAYTON, Paul | Director | The Vicarage Manlove Street WV3 0HG Wolverhampton | British | 78833300001 | ||||||
| COATES, Jamie | Director | 5 The Burrow WV3 9DD Wolverhampton West Midlands | England | British | 124663710001 | |||||
| COPESTAKE, Catherine Anne | Director | 72 Wergs Road WV6 9BN Wolverhampton Silver Birches House West Midlands England | United Kingdom | English | 174911060001 | |||||
| COTTERELL, John David | Director | Old Wildicote Cottage Rushey Lane Boningale WV7 3AZ Albrighton Shropshire | British | 40376470002 | ||||||
| DE KEYSER, Kirsten | Director | 1 Somerleyton Avenue DY10 3AS Kidderminster Worcestershire | Danish | 53727360001 | ||||||
| EDWARDS, Nicolette Anne | Director | East Pathway Harborne B17 9DN Birmingham 12 England | England | British | 199957730001 | |||||
| GEORGE, Natasha | Director | Newhampton Road West WV6 0RP Wolverhampton 174 England | England | British | 263018950001 | |||||
| HARTE, David Michael | Director | 67 Beaumint Road Bournville B30 2EB Birmingham West Midlands | England | British | 101721380001 | |||||
| HAWKINS, Claire Elizabeth | Director | Park Dale Court Parkdale East WV1 4SR Wolverhampton 4 West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 174911240001 | |||||
| HUGHES, Jonathan | Director | 74 Wynn Road Penn WV4 4AN Wolverhampton West Midlands | United Kingdom | British | 127977220001 | |||||
| HUMBLEY, Paul | Director | Beauchamp Avenue DY11 7AG Kidderminster 69 Beauchamp Ave England | England | British | 265498450001 | |||||
| HUMBLEY, Paul | Director | Beauchamp Avenue DY11 7AG Kidderminster 69 England | United Kingdom | British | 266638760001 | |||||
| HURD, Geoff | Director | The Chubb Buildings Fryer Street WV1 1HT Wolverhampton | United Kingdom | British | 155296880001 | |||||
| JELIC, Pablo Ernesto | Director | York Avenue WV3 9BU Wolverhampton 22 York Avenue England | England | British | 251096030001 | |||||
| LOVELL, Alan George | Director | 74 Moor Street CV5 6EU Coventry West Midlands | British | 32825840001 | ||||||
| LYNAGH, Catherine Elizabeth | Director | 17 High Brow B17 9EW Birmingham West Midlands | British | 64388110001 | ||||||
| READING, Neil | Director | Plover Green ST16 1FT Stafford 7 England | England | English | 251095570002 | |||||
| ROSEBLADE, Tara Rosalind | Director | Trysull Road WV3 7JG Wolverhampton 69 Trysull Road England | England | British | 251096560001 | |||||
| SARGEANT, Richard Athelstan | Director | 99 North Road Harborne B17 9PE Birmingham West Midlands | British | 51993700001 | ||||||
| SCHNEIDER, Mark Paul | Director | Mill Road SY2 6AY Shrewsbury 19 Abbey Wharf United Kingdom | United Kingdom | English | 217077890001 | |||||
| SCOTT, Tatty Jane | Director | Mountserrat Road B60 2RX Bromsgrove 10 Worcestershire England | United Kingdom | British | 174911790001 | |||||
| SIMCOCK, Barbara | Director | Flat 2 28 Tettenhall Road WV1 4SL Wolverhampton | British | 61988550001 | ||||||
| TOMLINSON, Michael | Director | Burcot House 38 Stockwell Road Tettenhall WV6 9PG Wolverhampton West Midlands | United Kingdom | British | 57323040001 | |||||
| VILLA, Nerina | Director | Bull Street Harborne B17 0HH Birmingham 5 West Midlands England | England | British | 174911640001 | |||||
| WALIA, Sunandan Singh | Director | 18 Elford Road Harborne B17 0SG Birmingham West Midlands | United Kingdom | British | 59368390001 | |||||
| YOUNG, Victor Charles | Director | Donnerville Gardens Admaston TF5 0DE Telford 24 Shropshire England | United Kingdom | British | 174911430001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de LIGHT HOUSE MEDIA CENTRE?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
|---|---|---|---|
| Mr Ronald William Kelly | 16 jul 2018 | Mount Road Penn WV4 5SW Wolverhampton 46 Mount Road England | No |
Nacionalidad: English País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Ms Catherine Anne Copestake | 30 abr 2018 | Wightwick Bank WV6 8DR Wolverhampton The House In The Trees England | Sí |
Nacionalidad: English País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Jamie Coates | 06 abr 2016 | The Burrow WV3 9DD Wolverhampton 5 West Midlands England | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
¿Tiene LIGHT HOUSE MEDIA CENTRE algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de acreedores |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0