GIFFORD SERVICES LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | GIFFORD SERVICES LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02973958 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GIFFORD SERVICES LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra GIFFORD SERVICES LIMITED?
Dirección de la sede social | 60 Newman Street W1T 3DA London |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GIFFORD SERVICES LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
MARKETITEM LIMITED | 06 oct 1994 | 06 oct 1994 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GIFFORD SERVICES LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2012 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para GIFFORD SERVICES LIMITED?
Declaración anual |
|
---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GIFFORD SERVICES LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 06 oct 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Deborah Jane Montgomery el 22 ene 2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Gordon Clark como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 06 oct 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Misceláneos Section 519 | 1 páginas | MISC | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * Carlton House Ringwood Road Woodlands Southampton SO40 7HT* el 02 dic 2011 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de Andrew Thorp como secretario | 3 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Deborah Montgomery como secretario | 2 páginas | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 06 oct 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010 | 3 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 06 oct 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2008 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 06 oct 2009 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Deborah Jane Montgomery el 06 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Gordon Marshall Clark el 06 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de GIFFORD SERVICES LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THORP, Andrew | Secretario | Newman Street W1T 3DA London 60 United Kingdom | British | 165007240001 | ||||||
BEAVEN, Deborah Jane | Director | 15 Stourvale Gardens Chandlers Ford SO53 3NE Southampton Hampshire | England | British | Accountant | 253029090001 | ||||
HOLLINGHURST, Edmund | Secretario | Wildways Wood Green SP6 2AZ Fordingbridge Hampshire | British | Consulting Engineer | 34904310001 | |||||
MONTGOMERY, Deborah Jane | Secretario | 15 Stourvale Gardens Chandlers Ford SO53 3NE Southampton Hampshire | British | Director | 90746130001 | |||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
CANADINE, Stephen Charles | Director | 59 Cheriton Road SO22 5AX Winchester Hampshire | United Kingdom | British | Director | 141973110001 | ||||
CLARK, Gordon Marshall | Director | Wyldeways Tethering Drove Hale SP6 2NQ Fordingbridge Hampshire | United Kingdom | British | Consulting Engineer | 28855590002 | ||||
CLIFTON, Geoffrey Andrew | Director | Garth House Littleton CH3 7DJ Chester Cheshire | United Kingdom | British | Consultant Engineer | 28855610001 | ||||
COLLINGS, Clayton Matthew | Director | Ivy Cottage Burgate SP6 1LX Fordingbridge Hampshire | British | Consultant Engineer | 84807610002 | |||||
DIBB-FULLER, David | Director | Ashburnham Ashton Lane Bishops Waltham SO32 1FN Southampton Hampshire | British | Consultant Engineer | 28855620001 | |||||
HARTLEY, Jonathan Paul | Director | Egerton Church Road CH4 9HT Farndon Cheshire | United Kingdom | British | Consulting Engineer | 141750650001 | ||||
HOLLINGHURST, Edmund | Director | Wildways Wood Green SP6 2AZ Fordingbridge Hampshire | British | Consulting Engineer | 34904310001 | |||||
HOLMES, Timothy Philip | Director | 6 Grayling Mead Fishlake Meadows SO51 7RU Romsey Hampshire | British | Consultant Engineer | 90746360001 | |||||
HUNT, Ian | Director | But N Ben Huxley Lane Huxley CH3 9BG Chester | British | Consultant Engineer | 93592900001 | |||||
PETTIFER, Andrew Martin | Director | 2 Yeatton Farm Cottages Hordle Lane Hordle SO41 0HU Hampshire | British | Consulting Engineer | 81901420002 | |||||
RAMSEY, Martin John | Director | 15 Cranworth Road SO22 6SE Winchester Hampshire | British | Consultant Engineer | 141750690001 | |||||
SMITH, Richard | Director | 4 Pine Way CH60 6RP Heswall Wirral | British | Consultant Engineer | 93592840001 | |||||
STEVENSON, Andrew Mark | Director | Rhinegold 27 The Horseshoe YO24 1LY York | England | British | Consultant Engineer | 37410220003 | ||||
TARRANT, David Eric | Director | 16 Keepers Close Chandlers Ford SO53 4SB Eastleigh Hampshire | England | British | Director | 115932860001 | ||||
TRICKLEBANK, Alan Howard | Director | 16 Hanley Road SO15 5AN Southampton Hampshire | United Kingdom | British | Consulting Engineer | 290691480001 | ||||
TRUBY, Andrew John | Director | 2 Hilbra Avenue Haxby YO32 3HD York Yorkshire | England | British | Consultant Engineer | 90746490001 | ||||
WOOD, Gary Antony | Director | 14 Guildford Drive Chandlers Ford SO53 3PT Eastleigh Hampshire | England | British | Consulting Engineer | 58533670002 | ||||
WOOLLEY, Malcolm Victor | Director | Garden House Goose Green SO43 7DH Lyndhurst Hampshire | British | Consulting Engineer | 41003220001 | |||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Director designado corporativo | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
¿Tiene GIFFORD SERVICES LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creado el 20 may 2003 Entregado el 22 may 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0