CASTLETON INFORMATION GROUP LIMITED

CASTLETON INFORMATION GROUP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCASTLETON INFORMATION GROUP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02974039
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CASTLETON INFORMATION GROUP LIMITED?

    • Otras actividades de servicios de tecnología de la información (62090) / Información y comunicación

    ¿Dónde se encuentra CASTLETON INFORMATION GROUP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    9 King Street
    EC2V 8EA London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CASTLETON INFORMATION GROUP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MAXIMA INFORMATION GROUP LIMITED06 jun 200806 jun 2008
    AZUR HOLDINGS LIMITED10 jun 200210 jun 2002
    AZUR GROUP LIMITED02 ago 200102 ago 2001
    MAXIMA INFORMATION GROUP LIMITED09 may 199509 may 1995
    OTTERBURN SOFTWARE GROUP PLC27 feb 199527 feb 1995
    INVESTMONEY LIMITED06 oct 199406 oct 1994

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CASTLETON INFORMATION GROUP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CASTLETON INFORMATION GROUP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01
    AA153XX7

    legacy

    1 páginasSH20
    AA05LB8Z

    Estado de capital el 19 mar 2021

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19
    AA05LB8R

    legacy

    1 páginasCAP-SS
    AA05LB9F

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Cancel share prem a/c and capital redemption reserve 09/03/2021
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Declaración de confirmación presentada el 06 oct 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    X9FT5E7M

    Modification des détails de Castleton Technology Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 17 sept 2020

    2 páginasPSC05
    X9FT5540

    Exercice comptable en cours raccourci du 31 mar 2021 au 31 dic 2020

    1 páginasAA01
    X9DT0R01

    Domicilio social registrado cambiado de The Walbrook Building 25 Walbrook London EC4N 8AF United Kingdom a 9 King Street London EC2V 8EA el 17 sept 2020

    1 páginasAD01
    X9DT0QY1

    Cese del nombramiento de Haywood Trefor Chapman como director el 04 jun 2020

    1 páginasTM01
    X97C4HQ8

    Cese del nombramiento de Karenjeet Kaur Showker como secretario el 16 jun 2020

    1 páginasTM02
    X97C4HJV

    Nombramiento de Mr Patrick Joseph Ghilani como director el 04 jun 2020

    2 páginasAP01
    X97C4HM8

    Nombramiento de Mr Roman Telerman como director el 04 jun 2020

    2 páginasAP01
    X97C4HIB

    Nombramiento de Mr John Adler Ensign como director el 04 jun 2020

    2 páginasAP01
    X97C4HFV

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2019

    12 páginasAA
    A8WN5MTC

    Declaración de confirmación presentada el 06 oct 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    X8GCGVXV

    Cese del nombramiento de Helen Griffiths como secretario el 19 jul 2019

    1 páginasTM02
    X8AJ9DI0

    Nombramiento de Ms Karenjeet Kaur Showker como secretario el 19 jul 2019

    2 páginasAP03
    X8AJ9DNF

    Modification des détails de Castleton Technology Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 mar 2019

    2 páginasPSC05
    X822KM3S

    Modification des détails de Castleton Technology Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 mar 2019

    2 páginasPSC05
    X822KTLE

    Domicilio social registrado cambiado de 100 Fetter Lane London EC4A 1BN a The Walbrook Building 25 Walbrook London EC4N 8AF el 26 mar 2019

    1 páginasAD01
    X81ZW8ZE

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2018

    14 páginasAA
    L7LGLXPD

    Declaración de confirmación presentada el 06 oct 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    X7H6QBFD

    ¿Quiénes son los directivos de CASTLETON INFORMATION GROUP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ENSIGN, John Adler
    King Street
    EC2V 8EA London
    9
    United Kingdom
    Director
    King Street
    EC2V 8EA London
    9
    United Kingdom
    United StatesAmericanLawyer270872360001
    GHILANI, Patrick Joseph
    King Street
    EC2V 8EA London
    9
    United Kingdom
    Director
    King Street
    EC2V 8EA London
    9
    United Kingdom
    United StatesAmericanChief Executive Officer238655330001
    TELERMAN, Roman
    King Street
    EC2V 8EA London
    9
    United Kingdom
    Director
    King Street
    EC2V 8EA London
    9
    United Kingdom
    United StatesAmericanAccountant238407950001
    ANDREWS, Linda Margaret
    61 Ravenswood Drive
    Shawlands
    G41 3UH Glasgow
    Secretario
    61 Ravenswood Drive
    Shawlands
    G41 3UH Glasgow
    British72431750001
    BLACK, Samuel Colin
    Stoughton Cross House
    Stoughton Cross
    BS28 4QP Wedmore
    Somerset
    Secretario
    Stoughton Cross House
    Stoughton Cross
    BS28 4QP Wedmore
    Somerset
    BritishChartered Accountant2814270002
    BRETHERTON, Richard James Howard
    5 Cullabine Farm
    WR11 7TJ Dumbleton
    Worcestershire
    Secretario
    5 Cullabine Farm
    WR11 7TJ Dumbleton
    Worcestershire
    British114590300001
    BUSBY, Nicola
    Pheasant Way
    GL7 1BL Cirencester
    6
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Secretario
    Pheasant Way
    GL7 1BL Cirencester
    6
    Gloucestershire
    United Kingdom
    BritishAccountant134382880001
    GRIFFITHS, Helen
    25 Walbrook
    EC4N 8AF London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    Secretario
    25 Walbrook
    EC4N 8AF London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    246082860001
    MYHILL, Paul Harvey
    Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    100
    United Kingdom
    Secretario
    Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    100
    United Kingdom
    184973700001
    SHOWKER, Karenjeet Kaur
    25 Walbrook
    EC4N 8AF London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    Secretario
    25 Walbrook
    EC4N 8AF London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    260899900001
    YOUNG, Jenny Louise
    Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    100
    United Kingdom
    Secretario
    Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    100
    United Kingdom
    200210750001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ANDREWS, Linda Margaret
    61 Ravenswood Drive
    Shawlands
    G41 3UH Glasgow
    Director
    61 Ravenswood Drive
    Shawlands
    G41 3UH Glasgow
    United KingdomBritishFinance Director72431750001
    BLACK, Samuel Colin
    Farfield Farm
    Cricklade
    SN6 6HZ Swindon
    Wiltshire
    Director
    Farfield Farm
    Cricklade
    SN6 6HZ Swindon
    Wiltshire
    United KingdomBritishChartered Accountant2814270004
    CAINES, John Michael
    1 Charlton Park Gate
    GL53 7DJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    1 Charlton Park Gate
    GL53 7DJ Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritishCompany Director26293160002
    CHAPMAN, Haywood Trefor
    25 Walbrook
    EC4N 8AF London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    Director
    25 Walbrook
    EC4N 8AF London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector193406100001
    DREDGE, Spencer Neal
    Cambridge Business Park,
    Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    Director
    Cambridge Business Park,
    Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United KingdomBritishAccountant138270950001
    FINE, Leonard Henry
    No 4 Osbourne Place
    24 10th Ave Houghton Estate
    Johannesburgh
    Gauteng 2196
    South Africa
    Director
    No 4 Osbourne Place
    24 10th Ave Houghton Estate
    Johannesburgh
    Gauteng 2196
    South Africa
    South AfricaSouth AfricanCompany Director70425230001
    GRAHAM, George Malcolm Roger
    Gaston House
    Gaston Green Little Hallingbury
    CM22 7QS Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Director
    Gaston House
    Gaston Green Little Hallingbury
    CM22 7QS Bishops Stortford
    Hertfordshire
    United KingdomBritishAdvisor36314420001
    HALLETT, Peter John
    Cambridge Business Park,
    Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    Director
    Cambridge Business Park,
    Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCfo20621770002
    HARRISON, Kelvin Frank
    Turners Hall Farm Mackeyre End
    AL5 5DU Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    Turners Hall Farm Mackeyre End
    AL5 5DU Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Engineer152236760001
    LLES, Geoffrey
    25 Chalfield Close
    Keynsham
    BS31 1JZ Bristol
    Avon
    Director
    25 Chalfield Close
    Keynsham
    BS31 1JZ Bristol
    Avon
    BritishCompany Director73475730001
    MCCULLAGH, John Stuart
    Heatherley
    Onslow Road
    KT12 5BB Walton On Thames
    Surrey
    Director
    Heatherley
    Onslow Road
    KT12 5BB Walton On Thames
    Surrey
    BritishDirector2040670001
    MEMORY, David William
    5 Holbein Gate
    HA6 3SH Northwood
    Middlesex
    Director
    5 Holbein Gate
    HA6 3SH Northwood
    Middlesex
    EnglandEnglishAccountant20274060001
    PASSMORE, Walter William
    Gardenside
    Higher Metcombe
    EX11 1SR Ottery St Mary
    Devon
    Director
    Gardenside
    Higher Metcombe
    EX11 1SR Ottery St Mary
    Devon
    BritishCompany Director53532920001
    TAYLOR, John James
    Ben Sayers Park
    North Berwick
    EH39 5PT Edinburgh
    19
    East Lothian
    Director
    Ben Sayers Park
    North Berwick
    EH39 5PT Edinburgh
    19
    East Lothian
    ScotlandBritishChartered Accountant138774840001
    WEAVER, Anthony Charles
    Cambridge Business Park,
    Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    Director
    Cambridge Business Park,
    Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    United KingdomBritishIt Services Consultant And Company Director153397180001
    WILLIAMS, Robert Charles
    28 Grove Road
    Coombe Dingle
    BS9 2RL Bristol
    Director
    28 Grove Road
    Coombe Dingle
    BS9 2RL Bristol
    BritishCompany Director68017980001
    WITKIN, Arnold
    1 Hillside Close
    St Johns Wood
    NW8 0EF London
    Director
    1 Hillside Close
    St Johns Wood
    NW8 0EF London
    EnglandBritishManaging Director39031240001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CASTLETON INFORMATION GROUP LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Castleton Technology Holdings Limited
    King Street
    EC2V 8EA London
    9
    United Kingdom
    06 abr 2016
    King Street
    EC2V 8EA London
    9
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUnited Kingdom
    Lugar de registroRegister Of Companies, United Kingdom
    Número de registro5043538
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene CASTLETON INFORMATION GROUP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 26 feb 2015
    Entregado el 05 mar 2015
    Pendiente
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 05 mar 2015Registro de una carga (MR01)
    Accession deed to a debenture
    Creado el 09 nov 2012
    Entregado el 21 nov 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to each present and future secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 21 nov 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 05 sept 2014Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 26 feb 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creado el 02 jul 2008
    Entregado el 17 jul 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 17 jul 2008Registro de un cargo (395)
    • 08 mar 2012Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    • 05 sept 2014Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 26 feb 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of accession and charge
    Creado el 26 ene 2005
    Entregado el 03 feb 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of fixed charge all land and all other land, all plant and machinery, all rental and other income and all debts, all securities, all insurance and assurance contracts and policies, all goodwill and uncalled capital, all intellectual property, all trade debts and all other debts and the benefit of all insurances guarantees charges pledges and other rights. By way of floating charge all assets not effectively charged.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 03 feb 2005Registro de un cargo (395)
    • 08 mar 2012Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    • 05 sept 2014Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 26 feb 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 29 jun 2001
    Entregado el 10 jul 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 10 jul 2001Registro de un cargo (395)
    • 21 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 23 ene 1998
    Entregado el 27 ene 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 27 ene 1998Registro de un cargo (395)
    • 07 dic 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0