CASTLETON INFORMATION GROUP LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | CASTLETON INFORMATION GROUP LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02974039 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CASTLETON INFORMATION GROUP LIMITED?
- Otras actividades de servicios de tecnología de la información (62090) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra CASTLETON INFORMATION GROUP LIMITED?
Dirección de la sede social | 9 King Street EC2V 8EA London United Kingdom |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CASTLETON INFORMATION GROUP LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
MAXIMA INFORMATION GROUP LIMITED | 06 jun 2008 | 06 jun 2008 |
AZUR HOLDINGS LIMITED | 10 jun 2002 | 10 jun 2002 |
AZUR GROUP LIMITED | 02 ago 2001 | 02 ago 2001 |
MAXIMA INFORMATION GROUP LIMITED | 09 may 1995 | 09 may 1995 |
OTTERBURN SOFTWARE GROUP PLC | 27 feb 1995 | 27 feb 1995 |
INVESTMONEY LIMITED | 06 oct 1994 | 06 oct 1994 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CASTLETON INFORMATION GROUP LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CASTLETON INFORMATION GROUP LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
Estado de capital el 19 mar 2021
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 06 oct 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Modification des détails de Castleton Technology Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 17 sept 2020 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||||||
Exercice comptable en cours raccourci du 31 mar 2021 au 31 dic 2020 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de The Walbrook Building 25 Walbrook London EC4N 8AF United Kingdom a 9 King Street London EC2V 8EA el 17 sept 2020 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Haywood Trefor Chapman como director el 04 jun 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Karenjeet Kaur Showker como secretario el 16 jun 2020 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Patrick Joseph Ghilani como director el 04 jun 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Roman Telerman como director el 04 jun 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr John Adler Ensign como director el 04 jun 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2019 | 12 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 06 oct 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Helen Griffiths como secretario el 19 jul 2019 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Nombramiento de Ms Karenjeet Kaur Showker como secretario el 19 jul 2019 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||
Modification des détails de Castleton Technology Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 mar 2019 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||||||
Modification des détails de Castleton Technology Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 mar 2019 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 100 Fetter Lane London EC4A 1BN a The Walbrook Building 25 Walbrook London EC4N 8AF el 26 mar 2019 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2018 | 14 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 06 oct 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CASTLETON INFORMATION GROUP LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSIGN, John Adler | Director | King Street EC2V 8EA London 9 United Kingdom | United States | American | Lawyer | 270872360001 | ||||
GHILANI, Patrick Joseph | Director | King Street EC2V 8EA London 9 United Kingdom | United States | American | Chief Executive Officer | 238655330001 | ||||
TELERMAN, Roman | Director | King Street EC2V 8EA London 9 United Kingdom | United States | American | Accountant | 238407950001 | ||||
ANDREWS, Linda Margaret | Secretario | 61 Ravenswood Drive Shawlands G41 3UH Glasgow | British | 72431750001 | ||||||
BLACK, Samuel Colin | Secretario | Stoughton Cross House Stoughton Cross BS28 4QP Wedmore Somerset | British | Chartered Accountant | 2814270002 | |||||
BRETHERTON, Richard James Howard | Secretario | 5 Cullabine Farm WR11 7TJ Dumbleton Worcestershire | British | 114590300001 | ||||||
BUSBY, Nicola | Secretario | Pheasant Way GL7 1BL Cirencester 6 Gloucestershire United Kingdom | British | Accountant | 134382880001 | |||||
GRIFFITHS, Helen | Secretario | 25 Walbrook EC4N 8AF London The Walbrook Building United Kingdom | 246082860001 | |||||||
MYHILL, Paul Harvey | Secretario | Fetter Lane EC4A 1BN London 100 United Kingdom | 184973700001 | |||||||
SHOWKER, Karenjeet Kaur | Secretario | 25 Walbrook EC4N 8AF London The Walbrook Building United Kingdom | 260899900001 | |||||||
YOUNG, Jenny Louise | Secretario | Fetter Lane EC4A 1BN London 100 United Kingdom | 200210750001 | |||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
ANDREWS, Linda Margaret | Director | 61 Ravenswood Drive Shawlands G41 3UH Glasgow | United Kingdom | British | Finance Director | 72431750001 | ||||
BLACK, Samuel Colin | Director | Farfield Farm Cricklade SN6 6HZ Swindon Wiltshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 2814270004 | ||||
CAINES, John Michael | Director | 1 Charlton Park Gate GL53 7DJ Cheltenham Gloucestershire | England | British | Company Director | 26293160002 | ||||
CHAPMAN, Haywood Trefor | Director | 25 Walbrook EC4N 8AF London The Walbrook Building United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 193406100001 | ||||
DREDGE, Spencer Neal | Director | Cambridge Business Park, Cowley Road CB4 0WZ Cambridge Newton House | United Kingdom | British | Accountant | 138270950001 | ||||
FINE, Leonard Henry | Director | No 4 Osbourne Place 24 10th Ave Houghton Estate Johannesburgh Gauteng 2196 South Africa | South Africa | South African | Company Director | 70425230001 | ||||
GRAHAM, George Malcolm Roger | Director | Gaston House Gaston Green Little Hallingbury CM22 7QS Bishops Stortford Hertfordshire | United Kingdom | British | Advisor | 36314420001 | ||||
HALLETT, Peter John | Director | Cambridge Business Park, Cowley Road CB4 0WZ Cambridge Newton House United Kingdom | United Kingdom | British | Cfo | 20621770002 | ||||
HARRISON, Kelvin Frank | Director | Turners Hall Farm Mackeyre End AL5 5DU Harpenden Hertfordshire | United Kingdom | British | Chartered Engineer | 152236760001 | ||||
LLES, Geoffrey | Director | 25 Chalfield Close Keynsham BS31 1JZ Bristol Avon | British | Company Director | 73475730001 | |||||
MCCULLAGH, John Stuart | Director | Heatherley Onslow Road KT12 5BB Walton On Thames Surrey | British | Director | 2040670001 | |||||
MEMORY, David William | Director | 5 Holbein Gate HA6 3SH Northwood Middlesex | England | English | Accountant | 20274060001 | ||||
PASSMORE, Walter William | Director | Gardenside Higher Metcombe EX11 1SR Ottery St Mary Devon | British | Company Director | 53532920001 | |||||
TAYLOR, John James | Director | Ben Sayers Park North Berwick EH39 5PT Edinburgh 19 East Lothian | Scotland | British | Chartered Accountant | 138774840001 | ||||
WEAVER, Anthony Charles | Director | Cambridge Business Park, Cowley Road CB4 0WZ Cambridge Newton House United Kingdom | United Kingdom | British | It Services Consultant And Company Director | 153397180001 | ||||
WILLIAMS, Robert Charles | Director | 28 Grove Road Coombe Dingle BS9 2RL Bristol | British | Company Director | 68017980001 | |||||
WITKIN, Arnold | Director | 1 Hillside Close St Johns Wood NW8 0EF London | England | British | Managing Director | 39031240001 | ||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Director designado corporativo | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CASTLETON INFORMATION GROUP LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castleton Technology Holdings Limited | 06 abr 2016 | King Street EC2V 8EA London 9 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene CASTLETON INFORMATION GROUP LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creado el 26 feb 2015 Entregado el 05 mar 2015 | Pendiente | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Accession deed to a debenture | Creado el 09 nov 2012 Entregado el 21 nov 2012 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to each present and future secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Guarantee & debenture | Creado el 02 jul 2008 Entregado el 17 jul 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Deed of accession and charge | Creado el 26 ene 2005 Entregado el 03 feb 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción By way of fixed charge all land and all other land, all plant and machinery, all rental and other income and all debts, all securities, all insurance and assurance contracts and policies, all goodwill and uncalled capital, all intellectual property, all trade debts and all other debts and the benefit of all insurances guarantees charges pledges and other rights. By way of floating charge all assets not effectively charged. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 29 jun 2001 Entregado el 10 jul 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 23 ene 1998 Entregado el 27 ene 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0