KENNEDYS GARDEN CENTRES LIMITED

KENNEDYS GARDEN CENTRES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaKENNEDYS GARDEN CENTRES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02977269
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de KENNEDYS GARDEN CENTRES LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra KENNEDYS GARDEN CENTRES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Wyevale Garden Centres Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Middlesex
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KENNEDYS GARDEN CENTRES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SIMCO 675 LIMITED10 oct 199410 oct 1994

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de KENNEDYS GARDEN CENTRES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 dic 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para KENNEDYS GARDEN CENTRES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Declaración de confirmación presentada el 28 abr 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 dic 2018

    8 páginasAA

    Nombramiento de Mr Richard Maclachlan como director el 01 feb 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Roger Mclaughlan como director el 01 feb 2019

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    8 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 28 abr 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Laura Harradine-Greene como secretario el 01 feb 2018

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Mary Elizabeth Bourlet como secretario el 01 feb 2018

    1 páginasTM02

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 25 dic 2016

    4 páginasAA

    Cambio de datos del secretario Mary Elizabeth Murray el 12 may 2017

    1 páginasCH03

    Declaración de confirmación presentada el 28 abr 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr Anthony Gerald Jones el 03 abr 2017

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Justin Matthew King como director el 31 oct 2016

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mary Elizabeth Murray como secretario el 25 ago 2016

    2 páginasAP03

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 27 dic 2015

    9 páginasAA

    Segunda presentación para la terminación de Nils Olin Steinmeyer como director

    4 páginasRP04TM01

    Segunda presentación para la terminación de Kevin Michael Bradshaw como director

    4 páginasRP04TM01

    Nombramiento de Mr Justin Matthew King como director el 18 ago 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Stephen Thomas Murphy como director el 18 ago 2016

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Mr Anthony Gerald Jones el 22 jul 2016

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 28 abr 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 may 2016

    Estado de capital el 18 may 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Nombramiento de Mr Stephen Thomas Murphy como director el 06 abr 2016

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de KENNEDYS GARDEN CENTRES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HARRADINE-GREENE, Laura
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Secretario
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    242725080001
    JONES, Anthony Gerald
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Director
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritishCfo212265950002
    MACLACHLAN, Richard John
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Director
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritishDirector255019700001
    ADAM, Christopher Glyn
    8 Kyle Close
    RG12 7DF Bracknell
    Berkshire
    Secretario
    8 Kyle Close
    RG12 7DF Bracknell
    Berkshire
    British13475190001
    BOURLET, Mary Elizabeth
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Secretario
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    217312600002
    FARMER, Miriam Ruth
    11 Barrett Crescent
    RG40 1UR Wokingham
    Berkshire
    Secretario
    11 Barrett Crescent
    RG40 1UR Wokingham
    Berkshire
    British44083900001
    JONES, Anthony David
    14 Brownhill Crescent
    LE7 7LA Rothley
    Leicestershire
    Secretario
    14 Brownhill Crescent
    LE7 7LA Rothley
    Leicestershire
    BritishChartered Accountant73622510001
    MURFIN, Stephen
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    Secretario
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    BritishChartered Accountant8690590001
    RATCLIFFE, Sarah Elizabeth
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    Secretario
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    BritishFinance Director76162020001
    SIMCO COMPANY SERVICES LIMITED
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    West Yorkshire
    Secretario designado corporativo
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    West Yorkshire
    900004040001
    ADAM, Christopher Glyn
    8 Kyle Close
    RG12 7DF Bracknell
    Berkshire
    Director
    8 Kyle Close
    RG12 7DF Bracknell
    Berkshire
    BritishCompany Director13475190001
    BRADSHAW, Kevin Michael
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Director
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritishCompany Director124019940001
    BRIGDEN, Peter
    16 Woodstock Gardens
    Appleton
    WA4 5HN Warrington
    Cheshire
    Director
    16 Woodstock Gardens
    Appleton
    WA4 5HN Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector Of Retail Operation195802400001
    BULLIVANT, George Anthony
    Stourton House
    High Street, Stourton
    BA12 6QF Warminster
    Wiltshire
    Director
    Stourton House
    High Street, Stourton
    BA12 6QF Warminster
    Wiltshire
    EnglandBritishManaging Director65866410001
    DEAN, Barry Malcolm
    Sandpit Cottage 4 High Street
    BN6 8TA Ditchling
    Sussex
    Director
    Sandpit Cottage 4 High Street
    BN6 8TA Ditchling
    Sussex
    United KingdomBritishInvestment Banking18034130001
    FAVELL, Gary Alan
    Yates House Foldshaw Lane
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    Yorks
    Director
    Yates House Foldshaw Lane
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    Yorks
    United KingdomBritishChief Executive107699240001
    HEWITT, Robert John
    The Old Cider Mill 2 Cotts Farm
    Cotts Lane
    HR1 3ND Lugwardine
    Herefordshire
    Director
    The Old Cider Mill 2 Cotts Farm
    Cotts Lane
    HR1 3ND Lugwardine
    Herefordshire
    United KingdomBritishCompany Director15486070002
    HODKINSON, James Clifford
    29b Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    Director
    29b Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    EnglandBritishCompany Director606430001
    HUGHES, Emyr Tonlas
    Danesbury 50 Byng Drive
    EN6 1UF Potters Bar
    Hertfordshire
    Director
    Danesbury 50 Byng Drive
    EN6 1UF Potters Bar
    Hertfordshire
    BritishInvestment Banking40119990001
    JENKINSON, Antonia Scarlett
    London Road
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    Director
    London Road
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    United KingdomBritishInvestment Banker72128340003
    KING, Justin Matthew
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Director
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    United KingdomBritishDirector213157990001
    KOZLOWSKI, Richard Leon
    34 Stubbs Wood
    HP6 6EX Amersham
    Buckinghamshire
    Director
    34 Stubbs Wood
    HP6 6EX Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector124967710001
    LIVINGSTON, William Andrew
    3 Barnes Close
    St Cross
    SO23 9QX Winchester
    Hampshire
    Director
    3 Barnes Close
    St Cross
    SO23 9QX Winchester
    Hampshire
    EnglandBritishCommercial Director111439220001
    MARSHALL, Nicholas Charles Gilmour
    London Road
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    Director
    London Road
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    WalesBritishCompany Director1470180001
    MCLAUGHLAN, Roger
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Director
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritishCeo206428840001
    MURFIN, Stephen
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    Director
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    BritishChartered Accountant8690590001
    MURPHY, Stephen Thomas
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Director
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    United KingdomBritishChairman207509410001
    PIERPOINT, David Julian
    33 West Street
    RH7 6QP Dormsland
    Rockvale
    Surrey
    Director
    33 West Street
    RH7 6QP Dormsland
    Rockvale
    Surrey
    EnglandBritishDirector138653690001
    PRICE, Glyn John
    Mill End
    Ash Ingen Mews Bridstow
    HR9 6QA Ross On Wye
    Herefordshire
    Director
    Mill End
    Ash Ingen Mews Bridstow
    HR9 6QA Ross On Wye
    Herefordshire
    United KingdomBritishCompany Director73470720001
    RATCLIFFE, Sarah Elizabeth
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    Director
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director76162020001
    SMITH, Andrew Kerron
    4 Westmorland Drive
    Warfield
    RG42 3QJ Bracknell
    Berkshire
    Director
    4 Westmorland Drive
    Warfield
    RG42 3QJ Bracknell
    Berkshire
    BritishMarketing Director41345310002
    STEINMEYER, Nils Olin
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Director
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    United KingdomGermanFinancial Director126422100002
    STEVENSON, Barry John
    Cherry Trees
    Cane End
    RG4 9HG Reading
    Berkshire
    Director
    Cherry Trees
    Cane End
    RG4 9HG Reading
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director102595670001
    SIMCO DIRECTOR A LIMITED
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    West Yorkshire
    Director designado corporativo
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    West Yorkshire
    900004030001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de KENNEDYS GARDEN CENTRES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Wyevale Garden Centres Holdings Limited
    Syon Park, London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    England
    06 abr 2016
    Syon Park, London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House England And Wales
    Número de registro01972554
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene KENNEDYS GARDEN CENTRES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Security agreement
    Creado el 24 feb 2009
    Entregado el 04 mar 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All of its mortgaged property,investments,plant and machinery,credit balances see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC (The “Security Agent”)
    Transacciones
    • 04 mar 2009Registro de un cargo (395)
    • 04 may 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creado el 10 mar 1997
    Entregado el 12 mar 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £25,000.00 due or to become due from the company to the chargee supplemental to a lease dated 22 march 1995
    Breve descripción
    The monies held in a rent deposit account in the name of the chargee pursuant to a rent deposit deed dated 10 march 1997.
    Personas con derecho
    • Wrotham Park Settled Estates
    Transacciones
    • 12 mar 1997Registro de un cargo (395)
    • 05 abr 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 28 feb 1997
    Entregado el 11 mar 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The f/h property k/a land on the north west side of great north road ganwick corner barnet t/n HD333589 together with all buildings and other structures thereon any goodwill relating to the property all plant machinery and other items thereon assigns the rental sums with the benefit of all rights and remedies. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 11 mar 1997Registro de un cargo (395)
    • 05 abr 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 08 dic 1994
    Entregado el 21 dic 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to becomee due from the company (formerly known as simco 675 limited) and each relevant subsidiary (as defined) to the chargee under the facility agreement dated 7TH december 1994 and of the company to the noteholders (as defined) pursuant to the loan note deed dated 7TH december 1994 on any account whatsoever under the finance documents (as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland, as Agent and Trustee for Itself and Each Ofthe Lenders (As Defined)
    Transacciones
    • 21 dic 1994Registro de un cargo (395)
    • 05 abr 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 07 dic 1994
    Entregado el 21 dic 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company (formerly known as simco 675 limited) and each relevant subsidiary (as defined) to the chargee under the facility agreement of even date and of the company to the noteholders (as defined) pursuant to the loan note deed of even date on any account whatsoever under the finance documents (as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland, as Agent and Trustee for Itself and Each Ofthe Lenders (As Defined)
    Transacciones
    • 21 dic 1994Registro de un cargo (395)
    • 05 abr 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0