KENNEDYS GARDEN CENTRES LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | KENNEDYS GARDEN CENTRES LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02977269 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de KENNEDYS GARDEN CENTRES LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra KENNEDYS GARDEN CENTRES LIMITED?
Dirección de la sede social | Wyevale Garden Centres Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Middlesex England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KENNEDYS GARDEN CENTRES LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
SIMCO 675 LIMITED | 10 oct 1994 | 10 oct 1994 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de KENNEDYS GARDEN CENTRES LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para KENNEDYS GARDEN CENTRES LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 28 abr 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 dic 2018 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Richard Maclachlan como director el 01 feb 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Roger Mclaughlan como director el 01 feb 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 28 abr 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Laura Harradine-Greene como secretario el 01 feb 2018 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mary Elizabeth Bourlet como secretario el 01 feb 2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 25 dic 2016 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Mary Elizabeth Murray el 12 may 2017 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 28 abr 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Anthony Gerald Jones el 03 abr 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Justin Matthew King como director el 31 oct 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mary Elizabeth Murray como secretario el 25 ago 2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 27 dic 2015 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Segunda presentación para la terminación de Nils Olin Steinmeyer como director | 4 páginas | RP04TM01 | ||||||||||
Segunda presentación para la terminación de Kevin Michael Bradshaw como director | 4 páginas | RP04TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Justin Matthew King como director el 18 ago 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Thomas Murphy como director el 18 ago 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Anthony Gerald Jones el 22 jul 2016 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 28 abr 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mr Stephen Thomas Murphy como director el 06 abr 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de KENNEDYS GARDEN CENTRES LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARRADINE-GREENE, Laura | Secretario | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | 242725080001 | |||||||
JONES, Anthony Gerald | Director | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | Cfo | 212265950002 | ||||
MACLACHLAN, Richard John | Director | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | Director | 255019700001 | ||||
ADAM, Christopher Glyn | Secretario | 8 Kyle Close RG12 7DF Bracknell Berkshire | British | 13475190001 | ||||||
BOURLET, Mary Elizabeth | Secretario | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | 217312600002 | |||||||
FARMER, Miriam Ruth | Secretario | 11 Barrett Crescent RG40 1UR Wokingham Berkshire | British | 44083900001 | ||||||
JONES, Anthony David | Secretario | 14 Brownhill Crescent LE7 7LA Rothley Leicestershire | British | Chartered Accountant | 73622510001 | |||||
MURFIN, Stephen | Secretario | The Kymin Westhide HR1 3RG Hereford Herefordshire | British | Chartered Accountant | 8690590001 | |||||
RATCLIFFE, Sarah Elizabeth | Secretario | 59b Grange Road SM2 6SP Sutton Surrey | British | Finance Director | 76162020001 | |||||
SIMCO COMPANY SERVICES LIMITED | Secretario designado corporativo | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire | 900004040001 | |||||||
ADAM, Christopher Glyn | Director | 8 Kyle Close RG12 7DF Bracknell Berkshire | British | Company Director | 13475190001 | |||||
BRADSHAW, Kevin Michael | Director | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | Company Director | 124019940001 | ||||
BRIGDEN, Peter | Director | 16 Woodstock Gardens Appleton WA4 5HN Warrington Cheshire | United Kingdom | British | Director Of Retail Operation | 195802400001 | ||||
BULLIVANT, George Anthony | Director | Stourton House High Street, Stourton BA12 6QF Warminster Wiltshire | England | British | Managing Director | 65866410001 | ||||
DEAN, Barry Malcolm | Director | Sandpit Cottage 4 High Street BN6 8TA Ditchling Sussex | United Kingdom | British | Investment Banking | 18034130001 | ||||
FAVELL, Gary Alan | Director | Yates House Foldshaw Lane Braithwaite HG3 4AN Harrogate Yorks | United Kingdom | British | Chief Executive | 107699240001 | ||||
HEWITT, Robert John | Director | The Old Cider Mill 2 Cotts Farm Cotts Lane HR1 3ND Lugwardine Herefordshire | United Kingdom | British | Company Director | 15486070002 | ||||
HODKINSON, James Clifford | Director | 29b Western Avenue Branksome Park BH13 7AN Poole Dorset | England | British | Company Director | 606430001 | ||||
HUGHES, Emyr Tonlas | Director | Danesbury 50 Byng Drive EN6 1UF Potters Bar Hertfordshire | British | Investment Banking | 40119990001 | |||||
JENKINSON, Antonia Scarlett | Director | London Road Syon Park TW8 8JF Brentford The Garden Centre Group Middlesex England | United Kingdom | British | Investment Banker | 72128340003 | ||||
KING, Justin Matthew | Director | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | United Kingdom | British | Director | 213157990001 | ||||
KOZLOWSKI, Richard Leon | Director | 34 Stubbs Wood HP6 6EX Amersham Buckinghamshire | England | British | Director | 124967710001 | ||||
LIVINGSTON, William Andrew | Director | 3 Barnes Close St Cross SO23 9QX Winchester Hampshire | England | British | Commercial Director | 111439220001 | ||||
MARSHALL, Nicholas Charles Gilmour | Director | London Road Syon Park TW8 8JF Brentford The Garden Centre Group Middlesex England | Wales | British | Company Director | 1470180001 | ||||
MCLAUGHLAN, Roger | Director | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | Ceo | 206428840001 | ||||
MURFIN, Stephen | Director | The Kymin Westhide HR1 3RG Hereford Herefordshire | British | Chartered Accountant | 8690590001 | |||||
MURPHY, Stephen Thomas | Director | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | United Kingdom | British | Chairman | 207509410001 | ||||
PIERPOINT, David Julian | Director | 33 West Street RH7 6QP Dormsland Rockvale Surrey | England | British | Director | 138653690001 | ||||
PRICE, Glyn John | Director | Mill End Ash Ingen Mews Bridstow HR9 6QA Ross On Wye Herefordshire | United Kingdom | British | Company Director | 73470720001 | ||||
RATCLIFFE, Sarah Elizabeth | Director | 59b Grange Road SM2 6SP Sutton Surrey | England | British | Finance Director | 76162020001 | ||||
SMITH, Andrew Kerron | Director | 4 Westmorland Drive Warfield RG42 3QJ Bracknell Berkshire | British | Marketing Director | 41345310002 | |||||
STEINMEYER, Nils Olin | Director | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | United Kingdom | German | Financial Director | 126422100002 | ||||
STEVENSON, Barry John | Director | Cherry Trees Cane End RG4 9HG Reading Berkshire | England | British | Company Director | 102595670001 | ||||
SIMCO DIRECTOR A LIMITED | Director designado corporativo | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire | 900004030001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de KENNEDYS GARDEN CENTRES LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyevale Garden Centres Holdings Limited | 06 abr 2016 | Syon Park, London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene KENNEDYS GARDEN CENTRES LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Security agreement | Creado el 24 feb 2009 Entregado el 04 mar 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All of its mortgaged property,investments,plant and machinery,credit balances see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Rent deposit deed | Creado el 10 mar 1997 Entregado el 12 mar 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £25,000.00 due or to become due from the company to the chargee supplemental to a lease dated 22 march 1995 | |
Breve descripción The monies held in a rent deposit account in the name of the chargee pursuant to a rent deposit deed dated 10 march 1997. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 28 feb 1997 Entregado el 11 mar 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The f/h property k/a land on the north west side of great north road ganwick corner barnet t/n HD333589 together with all buildings and other structures thereon any goodwill relating to the property all plant machinery and other items thereon assigns the rental sums with the benefit of all rights and remedies. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 08 dic 1994 Entregado el 21 dic 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to becomee due from the company (formerly known as simco 675 limited) and each relevant subsidiary (as defined) to the chargee under the facility agreement dated 7TH december 1994 and of the company to the noteholders (as defined) pursuant to the loan note deed dated 7TH december 1994 on any account whatsoever under the finance documents (as defined) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 07 dic 1994 Entregado el 21 dic 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company (formerly known as simco 675 limited) and each relevant subsidiary (as defined) to the chargee under the facility agreement of even date and of the company to the noteholders (as defined) pursuant to the loan note deed of even date on any account whatsoever under the finance documents (as defined) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0