GLOTEL HOLDINGS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | GLOTEL HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02982579 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GLOTEL HOLDINGS LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra GLOTEL HOLDINGS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 10 Bishops Square E1 6EG London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GLOTEL HOLDINGS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| GLOTEL HOLDINGS PLC | 26 mar 1999 | 26 mar 1999 |
| GLOTEL PLC | 19 oct 1994 | 19 oct 1994 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GLOTEL HOLDINGS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GLOTEL HOLDINGS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 2 páginas | DS01 | ||
Cambio de datos del director Medeco Developments Limited el 30 sept 2020 | 1 páginas | CH02 | ||
Cambio de datos del secretario Medeco Developments Ltd el 30 sept 2020 | 1 páginas | CH04 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Millennium Bridge House 2 Lambeth Hill London EC4V 4BG a 10 Bishops Square London E1 6EG el 30 sept 2020 | 1 páginas | AD01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 sept 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr Yann Serge Stephane Halka el 21 ago 2019 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 sept 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 21 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Gavin Tagg como secretario el 20 feb 2019 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Ms Rashida Atinuke Akinjobi como secretario el 20 feb 2019 | 2 páginas | AP03 | ||
Nombramiento de Mr Gavin Kenneth Tagg como director el 20 feb 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Yann Serge Stephane Halka como director el 01 feb 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Robert Marcel Wolff como director el 01 feb 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de un director | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de John Logan Marshall Iii como director el 31 dic 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 sept 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Marcello Pozzoni como director el 05 jul 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 21 páginas | AA | ||
Nombramiento de Ms Alexandra Helen Bishop como director el 01 abr 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 sept 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Notification de Adecco Group Ag en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 1 páginas | PSC02 | ||
Notification de Olsten (U.K.) Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 1 páginas | PSC02 | ||
Nombramiento de Director Robert Marcel Wolff como director el 17 jul 2017 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de GLOTEL HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKINJOBI, Rashida Atinuke | Secretario | Bishops Square E1 6EG London 10 England | 255582020001 | |||||||||||
| MEDECO DEVELOPMENTS LTD | Secretario corporativo | Bishops Square E1 6EG London 10 England |
| 163884460001 | ||||||||||
| BISHOP, Alexandra Helen | Director | Bishops Square E1 6EG London 10 England | United Kingdom | British | 183293230001 | |||||||||
| HALKA, Yann Serge Stephane | Director | Bishops Square E1 6EG London 10 England | United Kingdom | French | 255064770002 | |||||||||
| TAGG, Gavin Kenneth | Director | Bishops Square E1 6EG London 10 England | England | British | 255565180001 | |||||||||
| MEDECO DEVELOPMENTS LIMITED | Director corporativo | Bishops Square E1 6EG London 10 England |
| 132749860001 | ||||||||||
| ADKINS, Christopher James | Secretario | Whinthorpe Oxford Road SL9 7DL Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 57087870002 | ||||||||||
| BRIANT, Timothy | Secretario | Chanctonbury Way Finchley N12 7AB London 116 | British | 130048920001 | ||||||||||
| BROOKS, Jonathan | Secretario | 18 Norfolk Road NW8 6HG London | British | 66911470002 | ||||||||||
| CLARK, Leslie Charles | Secretario | Silver Birches Nightingales Lane HP8 4SL Chalfont St Giles Buckinghamshire | British | 22206230002 | ||||||||||
| HORWOOD, Lindsay | Secretario | 2 Lambeth Hill EC4V 4BG London Millennium Bridge House England | 149814940001 | |||||||||||
| MCCRACKEN, Sara Benita | Secretario | 71 Elstree Way WD6 1WD Borehamwood Adecco House Hertfordshire England | 149189100001 | |||||||||||
| SAFFER, Alan | Secretario | 3 Heathfield Road WD23 2LH Bushey Hertfordshire | British | 72309130002 | ||||||||||
| TAGG, Gavin | Secretario | 2 Lambeth Hill EC4V 4BG London Millennium Bridge House | 202423640001 | |||||||||||
| TAGG, Gavin Kenneth | Secretario | Flat 16, Cheylesmore House Ebury Bridge Road SW1W 8QY London | British | 95825170001 | ||||||||||
| ASHCROFT CAMERON SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 4 Rivers House Fentiman Walk SG14 1DB Hertford Hertfordshire | 900004530001 | |||||||||||
| ADKINS, Christopher James | Director | Whinthorpe Oxford Road SL9 7DL Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 57087870002 | ||||||||||
| BAKER, Andrew Arthur Edward | Director | 1070 Fisher Lane Winnetka Il 60093 Usa | British | 22206240004 | ||||||||||
| BRIANT, Timothy | Director | 2 Lambeth Hill EC4V 4BG London Millennium Bridge House | United Kingdom | British | 130048920001 | |||||||||
| BRIANT, Timothy | Director | 2 Lambeth Hill EC4V 4BG London Millennium Bridge House England | England | British | 153642170001 | |||||||||
| CLARK, Leslie Charles | Director | Silver Birches Nightingales Lane HP8 4SL Chalfont St Giles Buckinghamshire | United Kingdom | British | 22206230002 | |||||||||
| DARRAUGH, Peter Anthony | Director | 77 Grove Road HP23 5PB Tring Hertfordshire | England | British | 82678530001 | |||||||||
| MARSHALL III, John Logan | Director | 2 Lambeth Hill EC4V 4BG London Millennium Bridge House | England | American | 202761210001 | |||||||||
| MARTIN, Neil Thomas George | Director | 2 Lambeth Hill EC4V 4BG London Millennium Bridge House England | England | British | 126681070003 | |||||||||
| POZZONI, Marcello | Director | 2 Lambeth Hill EC4V 4BG London Millennium Bridge House | United States | Italian | 235799700001 | |||||||||
| SAFFER, Alan | Director | 3 Heathfield Road WD23 2LH Bushey Hertfordshire | England | British | 72309130002 | |||||||||
| SEARLE, Peter William | Director | 2 Lambeth Hill EC4V 4BG London Millennium Bridge House England | England | British | 116102520004 | |||||||||
| WOLFF, Robert Marcel | Director | 2 Lambeth Hill EC4V 4BG London Millennium Bridge House | Netherlands | Dutch | 235798570001 | |||||||||
| ASHCROFT CAMERON NOMINEES LIMITED | Director designado corporativo | 4 Rivers House Fentiman Walk SG14 1DB Hertford Hertfordshire | 900004520001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de GLOTEL HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring Group Limited | 06 abr 2016 | 2 Lambeth Hill EC4V 4BG London Millennium Bridge House England | No | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||||
| Olsten (U.K.) Holdings Limited | 06 abr 2016 | 2 Lambeth Hill EC4V 4BG London Millennium Bridge House England | No | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||||
| Adecco Group Ag | 06 abr 2016 | Bellerivestrasse 8008 Zürich 30 Switzerland | No | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||||
¿Tiene GLOTEL HOLDINGS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 21 feb 2005 Entregado el 22 feb 2005 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage debenture | Creado el 14 feb 2000 Entregado el 22 feb 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0