P WILLIAMS CHEMISTS (WIRRAL) LIMITED

P WILLIAMS CHEMISTS (WIRRAL) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaP WILLIAMS CHEMISTS (WIRRAL) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02987401
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de P WILLIAMS CHEMISTS (WIRRAL) LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra P WILLIAMS CHEMISTS (WIRRAL) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o WELL
    Merchants Warehouse
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de P WILLIAMS CHEMISTS (WIRRAL) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    D.L. ASTBURY PHARMACY LTD15 dic 199415 dic 1994
    ARGONCASTLE LIMITED07 nov 199407 nov 1994

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de P WILLIAMS CHEMISTS (WIRRAL) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta11 ene 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para P WILLIAMS CHEMISTS (WIRRAL) LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para P WILLIAMS CHEMISTS (WIRRAL) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Domicilio social registrado cambiado de 1 Angel Square Manchester M60 0AG a C/O Well Merchants Warehouse Castle Street Manchester M3 4LZ el 14 sept 2015

    1 páginasAD01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 31 jul 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital05 ago 2015

    Estado de capital el 05 ago 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada C/O Tlt Llp One Redcliff Street Bristol BS1 6TP

    1 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a C/O Tlt Llp One Redcliff Street Bristol BS1 6TP

    1 páginasAD02

    Exercice comptable en cours prolongé du 11 ene 2015 au 30 jun 2015

    1 páginasAA01

    Cese del nombramiento de Caroline Jane Sellers como secretario el 30 sept 2014

    1 páginasTM02

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Company business 11/08/2014
    RES13

    Déclaration annuelle établie au 31 jul 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital22 ago 2014

    Estado de capital el 22 ago 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cancelación total de la carga 7

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 3

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 5

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 6

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 8

    4 páginasMR04

    Cese del nombramiento de James Murray como director

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 11 ene 2014

    3 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Anthony John Smith el 27 feb 2014

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr John Branson Nuttall el 27 feb 2014

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 25 oct 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital11 nov 2013

    Estado de capital el 11 nov 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 11 ene 2013

    3 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de * New Century House Corporation Street Manchester M60 4ES* el 03 dic 2012

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 25 oct 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 11 ene 2012

    3 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de P WILLIAMS CHEMISTS (WIRRAL) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    NUTTALL, John Branson
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Director
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishGeneral Manager44967060002
    SMITH, Anthony John
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Director
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director - Healthcare137558680001
    ASTBURY, David Leonard
    Pentice
    13 Meadway
    CH60 8PH Lower Heswall
    Wirral
    Secretario
    Pentice
    13 Meadway
    CH60 8PH Lower Heswall
    Wirral
    BritishPharmacist41191260001
    ASTBURY, Paula Joan
    Pentice
    13 Meadway
    CH60 8PH Lower Heswall
    Wirral
    Secretario
    Pentice
    13 Meadway
    CH60 8PH Lower Heswall
    Wirral
    British41191080002
    ELDRIDGE, Katherine Elizabeth
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    Secretario
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    British110230860001
    JONES, Philip Robert
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    Secretario
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    EnglishCompany Secretary43686960001
    PARKER, Heather Susan
    50 Fuller Drive
    Wistaston
    CW2 6TH Crewe
    Cheshire
    Secretario
    50 Fuller Drive
    Wistaston
    CW2 6TH Crewe
    Cheshire
    BritishAccountants99189680001
    SELLERS, Caroline Jane
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Secretario
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    150198830001
    NORTH WEST REGISTRATION SERVICES (1994) LIMITED
    9 Abbey Square
    CH1 2HU Chester
    Cheshire
    Secretario designado corporativo
    9 Abbey Square
    CH1 2HU Chester
    Cheshire
    900008700001
    ASTBURY, David Leonard
    Pentice
    13 Meadway
    CH60 8PH Lower Heswall
    Wirral
    Director
    Pentice
    13 Meadway
    CH60 8PH Lower Heswall
    Wirral
    United KingdomBritishDirector41191260001
    AVIS, Christine Susan
    9 Abbey Square
    CH1 2HU Chester
    Director designado
    9 Abbey Square
    CH1 2HU Chester
    United KingdomBritish900006150001
    BATTY, Peter David
    Church Hill
    Ingham
    LN1 2YE Lincoln
    2
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Director
    Church Hill
    Ingham
    LN1 2YE Lincoln
    2
    Lincolnshire
    United Kingdom
    EnglandBritishHead Of Logistics140380300001
    BROCKLEHURST, Jonathan David
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Director
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    BritishFinancial Controller49108820004
    FARQUHAR, Gordon Hillocks
    3 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    Director
    3 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    United KingdomBritishHead Of Commercial125645380001
    JONES, Philip Robert
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    Director
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    United KingdomEnglishCompany Secretary43686960001
    MARKS, Peter Vincent
    The Old Barn Low House Farm
    Otley Road Eldwick
    BD16 3AZ Bingley
    West Yorkshire
    Director
    The Old Barn Low House Farm
    Otley Road Eldwick
    BD16 3AZ Bingley
    West Yorkshire
    United KingdomBritishChief Executive87486470001
    MURRAY, James William Masterson
    30 Riversdale
    Woolston
    WA1 4PZ Warrington
    Cheshire
    Director
    30 Riversdale
    Woolston
    WA1 4PZ Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritishChemist106429280001
    OWEN, Christopher John
    19 Sandringham Drive
    Wistaston
    CW2 8JF Crewe
    Cheshire
    Director
    19 Sandringham Drive
    Wistaston
    CW2 8JF Crewe
    Cheshire
    BritishPharmacist101623720001
    RALPH, Paula Joan
    Pentice
    13 Meadway
    CH60 8PH Lower Heswall
    Wirral
    Director
    Pentice
    13 Meadway
    CH60 8PH Lower Heswall
    Wirral
    BritishDirector41191080001
    WATES, Martyn James
    3 Aylesby Close
    WA16 8AE Knutsford
    Cheshire
    Director
    3 Aylesby Close
    WA16 8AE Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritishChief Financial Officer60114700001
    WILLIAMS, Steven John
    Foolpenny Hall London Road
    Stapeley
    CW5 7JL Nantwich
    Cheshire
    Director
    Foolpenny Hall London Road
    Stapeley
    CW5 7JL Nantwich
    Cheshire
    EnglandBritishDirector55845370001

    ¿Tiene P WILLIAMS CHEMISTS (WIRRAL) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 25 abr 2006
    Entregado el 29 abr 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a the pharmacy village road heswall, l/h property k/a 40 market street hoylake and any assets debts rights and undertakings.
    Personas con derecho
    • Medical Finance (Bristol) Limited
    Transacciones
    • 29 abr 2006Registro de un cargo (395)
    • 02 jul 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 03 mar 2006
    Entregado el 09 mar 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Medical Finance (Bristol) Limited
    Transacciones
    • 09 mar 2006Registro de un cargo (395)
    • 02 jul 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 03 mar 2006
    Entregado el 09 mar 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H 40 market street hoylake wirral. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 09 mar 2006Registro de un cargo (395)
    • 02 jul 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 16 ene 2006
    Entregado el 18 ene 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 18 ene 2006Registro de un cargo (395)
    • 02 jul 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 06 ago 2004
    Entregado el 12 ago 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 12 ago 2004Registro de un cargo (395)
    • 06 abr 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 12 oct 2000
    Entregado el 24 oct 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Property k/a 309 pensby road pensby wirral and 40 market street hoylake merseyside. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Aah Pharmaceuticals Limited
    Transacciones
    • 24 oct 2000Registro de un cargo (395)
    • 02 jul 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 02 ago 1999
    Entregado el 06 ago 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a 40 market street hoylake wirral merseyside. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 06 ago 1999Registro de un cargo (395)
    • 09 mar 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 30 dic 1994
    Entregado el 05 ene 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 05 ene 1995Registro de un cargo (395)
    • 24 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0