P WILLIAMS CHEMISTS (WIRRAL) LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | P WILLIAMS CHEMISTS (WIRRAL) LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02987401 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de P WILLIAMS CHEMISTS (WIRRAL) LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra P WILLIAMS CHEMISTS (WIRRAL) LIMITED?
Dirección de la sede social | c/o WELL Merchants Warehouse Castle Street M3 4LZ Manchester England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de P WILLIAMS CHEMISTS (WIRRAL) LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
D.L. ASTBURY PHARMACY LTD | 15 dic 1994 | 15 dic 1994 |
ARGONCASTLE LIMITED | 07 nov 1994 | 07 nov 1994 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de P WILLIAMS CHEMISTS (WIRRAL) LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 11 ene 2014 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para P WILLIAMS CHEMISTS (WIRRAL) LIMITED?
Declaración anual |
|
---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para P WILLIAMS CHEMISTS (WIRRAL) LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 1 Angel Square Manchester M60 0AG a C/O Well Merchants Warehouse Castle Street Manchester M3 4LZ el 14 sept 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 jul 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada C/O Tlt Llp One Redcliff Street Bristol BS1 6TP | 1 páginas | AD03 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a C/O Tlt Llp One Redcliff Street Bristol BS1 6TP | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 11 ene 2015 au 30 jun 2015 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Caroline Jane Sellers como secretario el 30 sept 2014 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 jul 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cancelación total de la carga 7 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 3 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 5 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 6 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 8 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cese del nombramiento de James Murray como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 11 ene 2014 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Anthony John Smith el 27 feb 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr John Branson Nuttall el 27 feb 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 25 oct 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 11 ene 2013 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * New Century House Corporation Street Manchester M60 4ES* el 03 dic 2012 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 25 oct 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 11 ene 2012 | 3 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de P WILLIAMS CHEMISTS (WIRRAL) LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUTTALL, John Branson | Director | Angel Square M60 0AG Manchester 1 United Kingdom | United Kingdom | British | General Manager | 44967060002 | ||||
SMITH, Anthony John | Director | Angel Square M60 0AG Manchester 1 United Kingdom | England | British | Finance Director - Healthcare | 137558680001 | ||||
ASTBURY, David Leonard | Secretario | Pentice 13 Meadway CH60 8PH Lower Heswall Wirral | British | Pharmacist | 41191260001 | |||||
ASTBURY, Paula Joan | Secretario | Pentice 13 Meadway CH60 8PH Lower Heswall Wirral | British | 41191080002 | ||||||
ELDRIDGE, Katherine Elizabeth | Secretario | 5 Stanley Avenue Hazel Grove SK7 4ED Stockport | British | 110230860001 | ||||||
JONES, Philip Robert | Secretario | 10 Crowhurst Drive Whitley WN1 2QH Wigan Lancashire | English | Company Secretary | 43686960001 | |||||
PARKER, Heather Susan | Secretario | 50 Fuller Drive Wistaston CW2 6TH Crewe Cheshire | British | Accountants | 99189680001 | |||||
SELLERS, Caroline Jane | Secretario | Angel Square M60 0AG Manchester 1 United Kingdom | 150198830001 | |||||||
NORTH WEST REGISTRATION SERVICES (1994) LIMITED | Secretario designado corporativo | 9 Abbey Square CH1 2HU Chester Cheshire | 900008700001 | |||||||
ASTBURY, David Leonard | Director | Pentice 13 Meadway CH60 8PH Lower Heswall Wirral | United Kingdom | British | Director | 41191260001 | ||||
AVIS, Christine Susan | Director designado | 9 Abbey Square CH1 2HU Chester | United Kingdom | British | 900006150001 | |||||
BATTY, Peter David | Director | Church Hill Ingham LN1 2YE Lincoln 2 Lincolnshire United Kingdom | England | British | Head Of Logistics | 140380300001 | ||||
BROCKLEHURST, Jonathan David | Director | Larch House 29 Keele Road ST5 2JT Newcastle Under Lyme Staffordshire | British | Financial Controller | 49108820004 | |||||
FARQUHAR, Gordon Hillocks | Director | 3 Apsley Grove Dorridge B93 8QP Solihull | United Kingdom | British | Head Of Commercial | 125645380001 | ||||
JONES, Philip Robert | Director | 10 Crowhurst Drive Whitley WN1 2QH Wigan Lancashire | United Kingdom | English | Company Secretary | 43686960001 | ||||
MARKS, Peter Vincent | Director | The Old Barn Low House Farm Otley Road Eldwick BD16 3AZ Bingley West Yorkshire | United Kingdom | British | Chief Executive | 87486470001 | ||||
MURRAY, James William Masterson | Director | 30 Riversdale Woolston WA1 4PZ Warrington Cheshire | United Kingdom | British | Chemist | 106429280001 | ||||
OWEN, Christopher John | Director | 19 Sandringham Drive Wistaston CW2 8JF Crewe Cheshire | British | Pharmacist | 101623720001 | |||||
RALPH, Paula Joan | Director | Pentice 13 Meadway CH60 8PH Lower Heswall Wirral | British | Director | 41191080001 | |||||
WATES, Martyn James | Director | 3 Aylesby Close WA16 8AE Knutsford Cheshire | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 60114700001 | ||||
WILLIAMS, Steven John | Director | Foolpenny Hall London Road Stapeley CW5 7JL Nantwich Cheshire | England | British | Director | 55845370001 |
¿Tiene P WILLIAMS CHEMISTS (WIRRAL) LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Creado el 25 abr 2006 Entregado el 29 abr 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción L/H property k/a the pharmacy village road heswall, l/h property k/a 40 market street hoylake and any assets debts rights and undertakings. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 03 mar 2006 Entregado el 09 mar 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal mortgage | Creado el 03 mar 2006 Entregado el 09 mar 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción L/H 40 market street hoylake wirral. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 16 ene 2006 Entregado el 18 ene 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 06 ago 2004 Entregado el 12 ago 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 12 oct 2000 Entregado el 24 oct 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Property k/a 309 pensby road pensby wirral and 40 market street hoylake merseyside. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal mortgage | Creado el 02 ago 1999 Entregado el 06 ago 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción L/H property k/a 40 market street hoylake wirral merseyside. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage debenture | Creado el 30 dic 1994 Entregado el 05 ene 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0