GUARDIAN HOMECARE KENT LIMITED

GUARDIAN HOMECARE KENT LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGUARDIAN HOMECARE KENT LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02988710
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GUARDIAN HOMECARE KENT LIMITED?

    • Otras actividades de asistencia sanitaria (86900) / Actividades sanitarias y de asistencia social

    ¿Dónde se encuentra GUARDIAN HOMECARE KENT LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Staple Court
    11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GUARDIAN HOMECARE KENT LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BETACARE LIMITED10 nov 199410 nov 1994

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GUARDIAN HOMECARE KENT LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2012

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GUARDIAN HOMECARE KENT LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Company business 12/11/2012
    RES13

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2012

    15 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 10 nov 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 nov 2012

    Estado de capital el 12 nov 2012

    • Capital: GBP 3
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2011

    15 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 10 nov 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del secretario Mark Andrew John Harrison el 09 nov 2011

    2 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mr Mark Andrew John Harrison el 09 nov 2011

    2 páginasCH01

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Approval of transaction documents 02/11/2011
    RES13

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Docs approved 31/03/2011
    RES13

    Déclaration annuelle établie au 10 nov 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Fraser Gregory como director

    1 páginasTM01

    Misceláneos

    519
    2 páginasMISC

    Resoluciones

    Resolutions
    20 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Restatement agreement approved/ company directors authorised 24/09/2010
    RES13
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Nombramiento de Mark Andrew John Harrison como secretario

    3 páginasAP03

    legacy

    11 páginasMG01

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2010 au 31 mar 2011

    4 páginasAA01

    Domicilio social registrado cambiado de Bupa House Limited 15-19 Bloomsbury Way London el 01 oct 2010

    2 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Bupa Secretaries Limited como secretario

    2 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Stephen Flanagan como director

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Nicholas Beazley como director

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Mahboob Merchant como director

    2 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de GUARDIAN HOMECARE KENT LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HARRISON, Mark Andrew John
    Floor
    Olympic House 3 Olympic Way
    HA9 0NP Wembley
    2nd
    United Kingdom
    Secretario
    Floor
    Olympic House 3 Olympic Way
    HA9 0NP Wembley
    2nd
    United Kingdom
    British154574090001
    HARRISON, Mark Andrew John, Mr.
    Olympic House
    3 Olympic Way
    HA9 0NP Wembley
    2nd Floor
    United Kingdom
    Director
    Olympic House
    3 Olympic Way
    HA9 0NP Wembley
    2nd Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish112670960001
    RUSHTON, Craig
    11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    Staple Court
    Director
    11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    Staple Court
    United KingdomBritish149583960001
    CUNNINGHAM, Thomas Bennie
    Trumpeters Lodge
    School Lane, Borden
    ME9 8JS Sittingbourne
    Kent
    England
    Secretario
    Trumpeters Lodge
    School Lane, Borden
    ME9 8JS Sittingbourne
    Kent
    England
    British41165870002
    LYON, David Oliver
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    Secretario
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    British51084280003
    BUPA SECRETARIES LIMITED
    Bupa House Limited
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Secretario corporativo
    Bupa House Limited
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    117754090001
    PARAMOUNT COMPANY SEARCHES LIMITED
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    Secretario designado corporativo
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    900001530001
    BEAZLEY, Nicholas Tetley
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Director
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritish105797560001
    BURNS, Gary Victor
    Thatchers
    Swanton Street, Bredgar
    ME9 8AP Sittingbourne
    Kent
    Director
    Thatchers
    Swanton Street, Bredgar
    ME9 8AP Sittingbourne
    Kent
    British80009890002
    BURNS, Robert Ian
    6 Netherfield Road
    AL5 2AG Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    6 Netherfield Road
    AL5 2AG Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish36584260002
    CUNNINGHAM, Annie Hastie
    Trumpeters Lodge
    School Lane, Borden
    ME9 8JS Sittingbourne
    Kent
    England
    Director
    Trumpeters Lodge
    School Lane, Borden
    ME9 8JS Sittingbourne
    Kent
    England
    EnglandBritish11335690002
    DAVIES, Julian Peter
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    Director
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish29367700001
    FLANAGAN, Stephen David
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Director
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritish117787010001
    GREGORY, Fraser David
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Director
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritish107664270003
    KEE, Fergus Alexander
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Director
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomIrish26911740008
    KENT, Benjamin David Jemphrey
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Director
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish93897360003
    LOS, Steven Michael
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Director
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritish116895800001
    LYON, David Oliver
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish51084280003
    MERCHANT, Mahboob Ali
    28 Denham Road
    KT17 3AA Epsom
    Surrey
    Director
    28 Denham Road
    KT17 3AA Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish56732410001
    SHEEHY, Stuart David
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Director
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    EnglandBritish123217250001
    SPOORS, Mark
    27 Newfield Way
    Highfield Park
    AL4 0GB St Albans
    Hertfordshire
    Director
    27 Newfield Way
    Highfield Park
    AL4 0GB St Albans
    Hertfordshire
    British72289290002
    PARAMOUNT PROPERTIES (UK) LIMITED
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    Director designado corporativo
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    900001520001

    ¿Tiene GUARDIAN HOMECARE KENT LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Security accession deed
    Creado el 24 sept 2010
    Entregado el 02 oct 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 02 oct 2010Registro de un cargo (MG01)
    Debenture
    Creado el 24 sept 2010
    Entregado el 30 sept 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee and/or the noteholders (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Sovereign Capital Partners LLP as Security Trustee for Itself and the Noteholders
    Transacciones
    • 30 sept 2010Registro de un cargo (MG01)
    Debenture
    Creado el 30 jun 2006
    Entregado el 11 jul 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the chargor to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC in Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 11 jul 2006Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 22 jun 2004
    Entregado el 24 jun 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 24 jun 2004Registro de un cargo (395)
    • 03 may 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 07 sept 1995
    Entregado el 14 sept 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 14 sept 1995Registro de un cargo (395)
    • 03 may 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0