CAFE SPICE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCAFE SPICE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02989499
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CAFE SPICE LIMITED?

    • Restaurantes con licencia (56101) / Actividades de alojamiento y de servicios de comida

    ¿Dónde se encuentra CAFE SPICE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    47-49 Green Lane
    HA6 3AE Northwood
    Middlesex
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CAFE SPICE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CAFE SPICE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    9 páginasLIQ14

    Domicilio social registrado cambiado de 29 Welbeck Street London W1G 8DA United Kingdom a 47-49 Green Lane Northwood Middlesex HA6 3AE el 23 nov 2022

    2 páginasAD01

    Declaración de asuntos

    8 páginasLIQ02

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación el 16 nov 2022

    LRESEX

    Cese del nombramiento de Suganthini Prabhakaran como secretario el 23 sept 2022

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 27 nov 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Segunda presentación de la Declaración de confirmación fechada el 27 nov 2020

    3 páginasRP04CS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2020

    11 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 27 nov 2020 con actualizaciones

    6 páginasCS01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    26 ene 2022Clarification A second filed CS01(amending statement of capital and shareholders information) was registered on 26/01/2022.

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    11 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 27 nov 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    11 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de Ward Divecha Ltd 29 Welbeck Street London W1G 8DA a 29 Welbeck Street London W1G 8DA el 29 may 2019

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 27 nov 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    10 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 27 nov 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    10 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 27 nov 2016 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2015

    8 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 nov 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital07 dic 2015

    Estado de capital el 07 dic 2015

    • Capital: GBP 23,175
    SH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2014

    8 páginasAA

    Nombramiento de Mrs Pervin Cyrus Todiwala como director el 10 jul 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Pervin Cyrus Todiwala como director el 02 dic 2014

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de CAFE SPICE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    TODIWALA, Cyrus Rustom
    23 Vicars Close
    E9 7HT London
    Director
    23 Vicars Close
    E9 7HT London
    United KingdomBritishRestaurateur35714480003
    TODIWALA, Pervin Cyrus
    Vicars Close
    E9 7HT London
    23
    England
    Director
    Vicars Close
    E9 7HT London
    23
    England
    United KingdomBritishCompany Director35714470005
    CLARKE, Christopher Michael
    136 Kensington Church Street
    W8 4BN London
    Uk
    Secretario
    136 Kensington Church Street
    W8 4BN London
    Uk
    BritishAccountant65230250001
    JACQUES, Guy Martin Launder
    The Manor
    Mill Lane, Chalgrove
    OX44 7SL Oxford
    Oxfordshire
    Secretario
    The Manor
    Mill Lane, Chalgrove
    OX44 7SL Oxford
    Oxfordshire
    BritishRestaurateur Hotel Barge Opetr13070290007
    PRABHAKARAN, Suganthini, Mrs.
    3 Chatsworth Road
    SM3 8PJ Cheam
    Surrey
    Secretario
    3 Chatsworth Road
    SM3 8PJ Cheam
    Surrey
    British81189870002
    TODIWALA, Pervin Cyrus
    23 Vicars Close
    E9 7HT London
    Secretario
    23 Vicars Close
    E9 7HT London
    British35714470005
    CITY GATE SECRETARIES LIMITED
    1 Park Place
    Canary Wharf
    E14 4HJ London
    Secretario corporativo
    1 Park Place
    Canary Wharf
    E14 4HJ London
    49750420001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secretario designado corporativo
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    GOTTLIEB, Michael
    268 Trinity Road
    SW18 3RQ London
    Director
    268 Trinity Road
    SW18 3RQ London
    BritishRestaurateur14150010001
    JACQUES, Guy Martin Launder
    Melia Park
    47 Sunnyside Road Coatesville Rd3
    Auckland 1311
    New Zealand
    Director
    Melia Park
    47 Sunnyside Road Coatesville Rd3
    Auckland 1311
    New Zealand
    BritishRestaurateur Hotel Barge Opetr13070290009
    KENDRICK, Roger John
    Braye House
    Egypt Lane
    SL2 3LF Farnham Common
    Buckinghamshire
    Director
    Braye House
    Egypt Lane
    SL2 3LF Farnham Common
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director764720002
    MCCARTHY, Ursula
    Flat 4
    75 Redcliffe Gardens
    SW10 9JJ London
    Director
    Flat 4
    75 Redcliffe Gardens
    SW10 9JJ London
    IrishCompany Director43316300001
    TODIWALA, Pervin Cyrus
    Ward Divecha Ltd
    29 Welbeck Street
    W1G 8DA London
    Director
    Ward Divecha Ltd
    29 Welbeck Street
    W1G 8DA London
    United KingdomBritishCompany Director35714470005
    WHITE, Patrick Frank Alain
    Dunster Lodge
    Bristol Gardens
    SW15 3TG London
    Director
    Dunster Lodge
    Bristol Gardens
    SW15 3TG London
    BritishCompany Director22341300001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Director designado corporativo
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CAFE SPICE LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Mr Cyrus Rustom Todiwala
    Vicars Close
    E9 7HT London
    23
    England
    27 nov 2016
    Vicars Close
    E9 7HT London
    23
    England
    No
    Nacionalidad: British
    País de residencia: United Kingdom
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    Mrs Pervin Cyrus Todiwala
    Vicars Close
    E9 7HT London
    23
    England
    27 nov 2016
    Vicars Close
    E9 7HT London
    23
    England
    No
    Nacionalidad: British
    País de residencia: United Kingdom
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene CAFE SPICE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 16 abr 1999
    Entregado el 27 abr 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £24,742.30 due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Patrick White Re: Msjd Trust
    Transacciones
    • 27 abr 1999Registro de un cargo (395)
    • 17 abr 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 16 abr 1999
    Entregado el 27 abr 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £24,742.30 due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Britania Limited
    Transacciones
    • 27 abr 1999Registro de un cargo (395)
    • 17 abr 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 16 abr 1999
    Entregado el 27 abr 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £92,790.40 due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Gosh! That's Big Limited
    Transacciones
    • 27 abr 1999Registro de un cargo (395)
    • 17 abr 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge of licenced premises
    Creado el 19 dic 1997
    Entregado el 30 dic 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Freehold property k/a 129 leman street london t/n EGL263644 the present and future goodwill and the proceeds of any insurance. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 30 dic 1997Registro de un cargo (395)
    • 17 abr 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge of licensed premises
    Creado el 19 dic 1997
    Entregado el 24 dic 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H premises being the ground floor and basement of the building k/a 247-249 lavender hill london SW11 including (so far as the landlord could grant the same) the forecourt in front of the building the benefit of all justices excise or other licences or registration certificates held in connection with the business, the present and future goodwill of any business and the proceeds of any insurance. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 24 dic 1997Registro de un cargo (395)
    • 28 sept 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 11 oct 1997
    Entregado el 25 sept 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a loan of up to £16,058 plus interest and expenses
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Michael Gottlieb
    Transacciones
    • 25 sept 1998Registro de un cargo (395)
    • 17 abr 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 11 oct 1997
    Entregado el 25 sept 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a loan of up to £204,635 plus interest and expenses
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Gosh! That's Big Limited
    Transacciones
    • 25 sept 1998Registro de un cargo (395)
    • 17 abr 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 11 oct 1997
    Entregado el 25 sept 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a loan of up to £54,564 and interest and expenses
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Britania Limited
    Transacciones
    • 25 sept 1998Registro de un cargo (395)
    • 17 abr 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 12 may 1997
    Entregado el 24 may 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture
    Breve descripción
    Fixed charge on all f/h and l/h property fixtures and fittings, goodwill,all debts and monetary claims stocks shares debentures and loans intellectual property rights all plant and machinery inc. Rights under hire hire purchase and credit sale agreements together with floating charge on other assets not charged or ceasing to become charged by way of fixed charge above. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Namaste of London Limited(As Trustee for the Lenders)
    Transacciones
    • 24 may 1997Registro de un cargo (395)
    • 29 dic 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 17 nov 1995
    Entregado el 28 nov 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 28 nov 1995Registro de un cargo (395)
    • 07 ene 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 27 abr 1995
    Entregado el 11 may 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £34,970 and all other monies due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Smollensky's Balloon Limited
    Transacciones
    • 11 may 1995Registro de un cargo (395)
    • 11 nov 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 27 abr 1995
    Entregado el 11 may 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £201,750 and all other monies due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Gosh! That's Big Limited
    Transacciones
    • 11 may 1995Registro de un cargo (395)
    • 29 dic 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 27 abr 1995
    Entregado el 11 may 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £53,800 and all other monies due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Patrick White
    Transacciones
    • 11 may 1995Registro de un cargo (395)
    • 29 dic 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 27 abr 1995
    Entregado el 11 may 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £53,800 and all other monies due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Britania Limited
    Transacciones
    • 11 may 1995Registro de un cargo (395)
    • 29 dic 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 27 abr 1995
    Entregado el 11 may 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £59,180 and all other monies due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Michael Gottlieb
    Transacciones
    • 11 may 1995Registro de un cargo (395)
    • 29 dic 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    ¿Tiene CAFE SPICE LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    29 feb 2024Fecha prevista de disolución
    16 nov 2022Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Ashok K Bhardwaj
    47-49 Green Lane
    HA6 3AE Northwood
    Middlesex
    Profesional
    47-49 Green Lane
    HA6 3AE Northwood
    Middlesex

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0