UNIDEBT COLLECTIONS LIMITED

UNIDEBT COLLECTIONS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaUNIDEBT COLLECTIONS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02996863
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de UNIDEBT COLLECTIONS LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra UNIDEBT COLLECTIONS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 Princes Street
    EC2R 8PB London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de UNIDEBT COLLECTIONS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PERICORK LIMITED01 dic 199401 dic 1994

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de UNIDEBT COLLECTIONS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para UNIDEBT COLLECTIONS LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para UNIDEBT COLLECTIONS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2013

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 oct 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital17 oct 2013

    Estado de capital el 17 oct 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2012

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 oct 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Christine Anne Russell como secretario el 27 jul 2012

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Rbs Secretarial Services Limited como secretario el 27 jul 2012

    2 páginasAP04

    Nombramiento de Ms Sally Jane Sutherland como director el 17 abr 2012

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de James Anthony Jackson como director el 17 abr 2012

    1 páginasTM01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2011

    7 páginasAA

    Cambio de datos del director Andrew James Nicholson el 07 nov 2011

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 01 oct 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Andrew James Nicholson el 27 oct 2011

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Andrew James Nicholson como director el 13 sept 2011

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Barbara Charlotte Wallace como director el 13 sept 2011

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Miss Christine Anne Russell como secretario el 13 sept 2011

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Barbara Charlotte Wallace como secretario el 13 sept 2011

    1 páginasTM02

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2010

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 oct 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Nombramiento de Barbara Charlotte Wallace como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Gary Stewart como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Neil Macarthur como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de James Anthony Anthony Jackson como director

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de UNIDEBT COLLECTIONS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    St Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24/25
    Scotland
    Secretario corporativo
    St Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24/25
    Scotland
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registroSC269847
    169073830001
    NICHOLSON, Andrew James
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Director
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    ScotlandBritish163664680002
    SUTHERLAND, Sally Jane
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Director
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    ScotlandBritish166757310001
    BERESFORD, Robyn Fay
    West Bryson Road
    EH11 1BN Edinburgh
    21/5
    Secretario
    West Bryson Road
    EH11 1BN Edinburgh
    21/5
    Other132316300001
    CASTRO, Marcos
    2b St Johns Road
    RH1 6HF Redhill
    Surrey
    Secretario
    2b St Johns Road
    RH1 6HF Redhill
    Surrey
    Other109248350003
    GONSALVES, Patrick Anthony
    8 Stanbrook Way
    Yielden
    MK44 1AX Bedford
    Bedfordshire
    Secretario
    8 Stanbrook Way
    Yielden
    MK44 1AX Bedford
    Bedfordshire
    British70360200001
    HOFMANN, David John
    16 Sheredes Drive
    EN11 8LJ Hoddesdon
    Hertfordshire
    Secretario
    16 Sheredes Drive
    EN11 8LJ Hoddesdon
    Hertfordshire
    British49331410001
    LEA, John Albert
    2 Heathgate
    CM8 3NZ Wickham Bishops
    Essex
    Secretario
    2 Heathgate
    CM8 3NZ Wickham Bishops
    Essex
    British1369400003
    RUSSELL, Christine Anne
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Secretario
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    163989600001
    SMITH, Carolyn
    9 Bedford Court
    Mowbray Road Upper Norwood
    SE19 2RW London
    Secretario
    9 Bedford Court
    Mowbray Road Upper Norwood
    SE19 2RW London
    British68031820001
    WALLACE, Barbara Charlotte
    Rbs Gogarburn
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Secretario
    Rbs Gogarburn
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    149204110001
    WHITTAKER, Carolyn Jean
    6 Whitewood Cottages
    Whitewood Lane
    RH9 8JR South Godstone
    Surrey
    Secretario
    6 Whitewood Cottages
    Whitewood Lane
    RH9 8JR South Godstone
    Surrey
    Other67499700003
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secretario designado corporativo
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    BOLTON, Stuart Dennis
    16 Cornwallis Drive
    CM3 5YE South Woodham Ferrers
    Essex
    Director
    16 Cornwallis Drive
    CM3 5YE South Woodham Ferrers
    Essex
    British53198440001
    BROWN, Laurence David
    55 Well Lane
    Galleywood
    CM2 8QZ Chelmsford
    Essex
    Director
    55 Well Lane
    Galleywood
    CM2 8QZ Chelmsford
    Essex
    British51697520001
    CONSTANCE, Philip Harold
    5 Normanhurst Close
    Three Bridges
    RH10 1YL Crawley
    West Sussex
    Director
    5 Normanhurst Close
    Three Bridges
    RH10 1YL Crawley
    West Sussex
    British43034710001
    CUNNINGHAM, Angela Mary
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    Director
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    British62801910001
    EARL, Jane
    8 Parsonage Farm
    Townfield
    WD3 7FN Rickmanworth
    Hertfordshire
    Director
    8 Parsonage Farm
    Townfield
    WD3 7FN Rickmanworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish82548680001
    ENDERBY, William Kenneth
    Thomas Wood Bank Lane
    Hildenborough
    TN11 8NR Kent
    Director
    Thomas Wood Bank Lane
    Hildenborough
    TN11 8NR Kent
    United KingdomBritish142990400001
    GONSALVES, Patrick Anthony
    8 Stanbrook Way
    Yielden
    MK44 1AX Bedford
    Bedfordshire
    Director
    8 Stanbrook Way
    Yielden
    MK44 1AX Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritish70360200001
    HOPKINS, Richard James
    Flat 4 Kings View Court
    115 Ridgway Wimbledon
    SW19 4RW London
    Director
    Flat 4 Kings View Court
    115 Ridgway Wimbledon
    SW19 4RW London
    EnglandBritish92378040002
    JACKSON, James Anthony
    Bishopsgate
    EC2M 4RB London,
    280
    England
    Director
    Bishopsgate
    EC2M 4RB London,
    280
    England
    EnglandBritish154943750001
    LEA, John Albert
    2 Heathgate
    CM8 3NZ Wickham Bishops
    Essex
    Director
    2 Heathgate
    CM8 3NZ Wickham Bishops
    Essex
    British1369400003
    MACARTHUR, Neil Clark
    Rbs Gogarburn
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Director
    Rbs Gogarburn
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    United KingdomBritish81529340002
    MCKENNA, Michael John
    49 Penrith Road
    Hainault
    IG6 3DA Ilford
    Essex
    Director
    49 Penrith Road
    Hainault
    IG6 3DA Ilford
    Essex
    United KingdomBritish167926430001
    MORIARTY, Antoinette Una
    555 Rayners Lane
    HA5 5HP Pinner
    Middlesex
    Director
    555 Rayners Lane
    HA5 5HP Pinner
    Middlesex
    British54206370002
    ROLES, Brian
    Corner Cottage
    Marton Baschurch
    SY4 2BY Shropshire
    Director
    Corner Cottage
    Marton Baschurch
    SY4 2BY Shropshire
    British51450950001
    STAPLES, Graham
    Winterfold Tangley Road
    SP11 0HS Hatherden
    Hampshire
    Director
    Winterfold Tangley Road
    SP11 0HS Hatherden
    Hampshire
    United KingdomBritish36931070002
    STEWART, Gary Robert Mcneilly
    Burnbrae Avenue
    EH12 8AU Edinburgh
    10
    Scotland
    Director
    Burnbrae Avenue
    EH12 8AU Edinburgh
    10
    Scotland
    ScotlandBritish128173150002
    WALLACE, Barbara Charlotte
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Director
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    ScotlandBritish150055310001
    WELSH, Robert Marcus
    23 Copper Beech Wynd
    KY12 8UP Dunfermline
    Fife
    Director
    23 Copper Beech Wynd
    KY12 8UP Dunfermline
    Fife
    British56222120001
    WHITE, Harvey Frederick
    40 Bramleys
    SS17 8AE Stanford Le Hope
    Essex
    Director
    40 Bramleys
    SS17 8AE Stanford Le Hope
    Essex
    British17679000001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Director designado corporativo
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0