THE WEEK LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | THE WEEK LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02998743 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de THE WEEK LIMITED?
- Edición de revistas y publicaciones periódicas de consumo y negocios (58142) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra THE WEEK LIMITED?
| Dirección de la sede social | Quay House The Ambury BA1 1UA Bath England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de THE WEEK LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| TYROLESE (298) LIMITED | 06 dic 1994 | 06 dic 1994 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de THE WEEK LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2022 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE WEEK LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 2 páginas | DS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 06 dic 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Oliver James Foster como director el 30 may 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2022 | 7 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr David John Bateson como secretario el 31 mar 2023 | 2 páginas | AP03 | ||
Nombramiento de Mr David John Bateson como director el 31 mar 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Zillah Ellen Byng-Thorne como director el 31 mar 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Robert William Tompkins como director el 18 dic 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Exercice comptable précédent raccourci du 31 dic 2022 au 30 sept 2022 | 1 páginas | AA01 | ||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2021 | 11 páginas | AA | ||
legacy | 60 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
Declaración de confirmación presentada el 06 dic 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
Cambio de datos del director Mrs Penelope Anne Ladkin-Brand el 20 abr 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 31 - 32 Alfred Place London WC1E 7DP England a Quay House the Ambury Bath BA1 1UA el 29 mar 2022 | 1 páginas | AD01 | ||
Modification des détails de Dennis Publishing Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 24 feb 2022 | 2 páginas | PSC05 | ||
Modification des détails de Dennis Publishing Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 feb 2022 | 2 páginas | PSC05 | ||
Cambio de datos del director Mrs Zillah Ellen Byng-Thorne el 17 feb 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
¿Quiénes son los directivos de THE WEEK LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATESON, David John | Secretario | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | 307919740001 | |||||||
| BATESON, David John | Director | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | England | British | 259939150001 | |||||
| FOSTER, Oliver James | Director | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | England | British | 280151610001 | |||||
| LADKIN-BRAND, Penelope Anne | Director | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | England | British | 288978380002 | |||||
| TOMPKINS, Robert William | Director | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | England | British | 303888570001 | |||||
| CONNELL, Jolyon Christopher Neil | Secretario | Spye Arch House Spye Park Lacock SN15 2PR Chippenham Wiltshire | British | 46830420002 | ||||||
| LEGGETT, Ian Geoffrey Harvey | Secretario | Fountain Ridge Montreal Road Riverhead TN13 2EP Sevenoaks Kent | British,New Zealander | 7421560001 | ||||||
| REYNOLDS, Brett Wilson | Secretario | Alfred Place WC1E 7DP London 31 - 32 England | 210702440001 | |||||||
| TYROLESE (SECRETARIAL) LIMITED | Secretario designado corporativo | 66 Lincoln's Inn Fields WC2A 3LH London | 900002460001 | |||||||
| ADDISON, Rachel Bernadette | Director | Alfred Place WC1E 7DP London 31 - 32 England | United Kingdom | British | 250816460001 | |||||
| BYNG-THORNE, Zillah Ellen | Director | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | England | British | 182681640004 | |||||
| CONNELL, Alexandra Victoria Caroline Anne, Lady | Director | Spye Arch House Spye Park Lacock SN15 2PR Chippenham Wiltshire | British | 46830400001 | ||||||
| CONNELL, Jolyon Christopher Neil | Director | Spye Arch House Spye Park Lacock SN15 2PR Chippenham Wiltshire | United Kingdom | British | 46830420002 | |||||
| DAVIS, Jonathan Grainger Dusser | Director | 113 Cumnor Hill OX2 9JA Oxford Oxfordshire | British | 56226220001 | ||||||
| DENNIS, Felix | Director | The Old Manor Dorsington CV37 8AR Stratford-Upon-Avon Warwickshire | United Kingdom | British | 18597710001 | |||||
| KERR, Richard James | Director | Alfred Place WC1E 7DP London 31 - 32 England | England | British | 118897360002 | |||||
| LEGGETT, Ian Geoffrey Harvey | Director | Fountain Ridge Montreal Road Riverhead TN13 2EP Sevenoaks Kent | England | British,New Zealander | 7421560001 | |||||
| O'CONNOR, Kerin James | Director | Cleveland Square W2 6DG London 17f London United Kingdom | United Kingdom | British | 128740150001 | |||||
| O'GRADY, Jeremy Robert | Director | 32 Addison Avenue W11 4QR London | United Kingdom | British | 46830440001 | |||||
| RAMSAY, Alistair John | Director | Rowan House 21 Fairmile Lane KT11 2DL Cobham Surrey | Uk | British | 83921230001 | |||||
| REYNOLDS, Brett Wilson | Director | 12 Woodside Avenue KT12 5LG Hersham Surrey | England | British,New Zealander | 108483730001 | |||||
| TYE, James Alexander | Director | 15 Warren Park Road SG14 3JD Hertford Warren Hoe Hertfordshire | England | British | 110121090002 | |||||
| TYROLESE (DIRECTORS) LIMITED | Director designado corporativo | 66 Lincoln's Inn Fields WC2A 3LH London | 900002470001 | |||||||
| TYROLESE (SECRETARIAL) LIMITED | Director designado corporativo | 66 Lincoln's Inn Fields WC2A 3LH London | 900002460001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de THE WEEK LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Publishing Limited | 06 abr 2016 | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene THE WEEK LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 02 nov 2018 Entregado el 08 nov 2018 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción None. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 07 may 2014 Entregado el 13 may 2014 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Rent deposit deed | Creado el 07 may 2003 Entregado el 12 may 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción £38,500 and all other sums deposited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 21 may 2002 Entregado el 29 may 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 01 dic 1995 Entregado el 06 dic 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £235,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking property and assets including goodwill copyright patents book debts uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0