PARADISE FOODS LIMITED

PARADISE FOODS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPARADISE FOODS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03002592
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PARADISE FOODS LIMITED?

    • Otros procesamiento y conservación de frutas y hortalizas (10390) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra PARADISE FOODS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PARADISE FOODS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PARADISE FOODS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    13 páginas4.71

    Domicilio social registrado cambiado de 3000 Hillswood Business Park Hillswood Drive Chertsey England KT16 0RS a Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR el 30 jun 2016

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 14 jun 2016

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Déclaration annuelle établie au 16 dic 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital17 dic 2015

    Estado de capital el 17 dic 2015

    • Capital: GBP 1,596,630.94
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    8 páginasAA

    Cambio de datos del director Mark John Lane el 05 mar 2015

    3 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 16 dic 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital28 ene 2015

    Estado de capital el 28 ene 2015

    • Capital: GBP 1,596,630.94
    SH01

    Cancelación total de la carga 10

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 9

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 12

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 11

    2 páginasMR04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    8 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 16 dic 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital13 ene 2014

    Estado de capital el 13 ene 2014

    • Capital: GBP 1,596,630.94
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    9 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 16 dic 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    9 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 16 dic 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cambio de datos del director Gerard Vincent Magee el 28 oct 2011

    2 páginasCH01

    Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado

    1 páginasAD04

    Cambio de datos del secretario Mark John Lane el 21 oct 2011

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mark John Lane el 21 oct 2011

    2 páginasCH01

    Domicilio social registrado cambiado de * Suite 201 the Chambers Chelsea Harbour London SW10 0XF* el 21 oct 2011

    1 páginasAD01

    ¿Quiénes son los directivos de PARADISE FOODS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    LANE, Mark John
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Secretario
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    British151305980001
    LANE, Mark John
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Director
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    EnglandBritishFinance Director132183700002
    MAGEE, Gerard Vincent
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Director
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    IrelandIrishCompany Director151272980001
    HATHER, Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Secretario
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    BritishCo Secretary68848420004
    HUTCHINS, Paul William
    40 Holmside Avenue
    Dunston
    NE11 9TJ Gateshead
    Tyne & Wear
    Secretario
    40 Holmside Avenue
    Dunston
    NE11 9TJ Gateshead
    Tyne & Wear
    British73218420001
    JONES, Kathryn Louise
    29 St Woollos Road
    NP9 4GN Newport
    Gwent
    Secretario designado
    29 St Woollos Road
    NP9 4GN Newport
    Gwent
    British900009530001
    MILLS, Katherine Jane
    49 Highbury
    Jesmond
    NE2 3EA Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    Secretario
    49 Highbury
    Jesmond
    NE2 3EA Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    British45408320001
    O'CONNOR, Philip Stephen
    7 The Poplars
    SL5 9HZ South Ascot
    Berkshire
    Secretario
    7 The Poplars
    SL5 9HZ South Ascot
    Berkshire
    IrishCompany Ceo107745290001
    PHILLIPS, Robert Meirion
    7 Hawthorn Terrace
    Eighton Banks
    NE9 7XY Gateshead
    Tyne & Wear
    Secretario
    7 Hawthorn Terrace
    Eighton Banks
    NE9 7XY Gateshead
    Tyne & Wear
    BritishCompany Secretary66087080001
    SCOTT, Anthony John
    45 Station Road
    Smallford
    AL4 0HB St Albans
    Hertfordshire
    Secretario
    45 Station Road
    Smallford
    AL4 0HB St Albans
    Hertfordshire
    BritishSales And Marketing Manager39208840001
    BLAND, Joanne
    59 Kirkwood Drive
    Sheraton Park Nevilles Cross
    DH1 4FF Durham
    Director
    59 Kirkwood Drive
    Sheraton Park Nevilles Cross
    DH1 4FF Durham
    United KingdomBritishDirector73218330002
    BONE, Peter John
    Mount Huly Farm
    Ovingham
    NE42 6HQ Prudhoe
    Northumberland
    Director
    Mount Huly Farm
    Ovingham
    NE42 6HQ Prudhoe
    Northumberland
    BritishCompany Director7030800001
    CARR, Howard Radley
    8 Market Place
    NG34 0SF Folkingham
    Lincolnshire
    Director
    8 Market Place
    NG34 0SF Folkingham
    Lincolnshire
    BritishDirector68268990003
    CHARLES, Gavin
    Westfield
    Gipsy Lane
    RG40 2HP Wokingham
    Berkshire
    Director
    Westfield
    Gipsy Lane
    RG40 2HP Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritishFinance Director120029860002
    CHUNG, Barry William
    3 Riverside Gardens
    Thorpe Meadows
    PE3 6GE Peterborough
    Cambridgeshire
    Director
    3 Riverside Gardens
    Thorpe Meadows
    PE3 6GE Peterborough
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishCompany Director102601980001
    COCKRAM, John Phillip
    35 Melrose Road
    Southfields
    SW18 1LX London
    Director
    35 Melrose Road
    Southfields
    SW18 1LX London
    BritishManaging Director37572680001
    DAVENPORT, Christopher Martin
    Jubilee Cottage
    NE42 6DH Ovington
    Northumberland
    Director
    Jubilee Cottage
    NE42 6DH Ovington
    Northumberland
    BritishDirector73218280002
    DAVENPORT, Michael Christopher
    Court Farm House
    Letcombe Bassett
    OX12 9LR Wantage
    Oxfordshire
    Director
    Court Farm House
    Letcombe Bassett
    OX12 9LR Wantage
    Oxfordshire
    British393470002
    GORDON, Peter
    8 Chestnut Walk
    SG1 4DD Old Stevenage
    Hertfordshire
    Director
    8 Chestnut Walk
    SG1 4DD Old Stevenage
    Hertfordshire
    BritishDirector41529970001
    GOURMAND, Paul Rene
    Gatehouse Cottage
    Kiln Down
    TN17 1HL Goudhurst
    Kent
    Director
    Gatehouse Cottage
    Kiln Down
    TN17 1HL Goudhurst
    Kent
    BritishNon-Executive Director31605060001
    HESLOP, Patricia Veronica June
    Beechwood The Slade
    Bucklebury
    RG7 6TE Reading
    Berkshire
    Director
    Beechwood The Slade
    Bucklebury
    RG7 6TE Reading
    Berkshire
    EnglandBritishDirector51263040001
    HUNTER, Alison Louise
    25 Twickenham Court
    Seghill
    NE23 7TB Northumberland
    Director
    25 Twickenham Court
    Seghill
    NE23 7TB Northumberland
    BritishDirector73218370002
    HUTCHINS, Paul William
    40 Holmside Avenue
    Dunston
    NE11 9TJ Gateshead
    Tyne & Wear
    Director
    40 Holmside Avenue
    Dunston
    NE11 9TJ Gateshead
    Tyne & Wear
    EnglandBritishDirector73218420001
    JENNINGS, David Robert
    South Croft House
    Great Whittington
    NE19 2HP Newcastle Upon Tyne
    Director
    South Croft House
    Great Whittington
    NE19 2HP Newcastle Upon Tyne
    BritishSales + Marketing Manager41484670002
    LEES, Charles Nigel
    20 Heathdale Road
    M6 C1M6 Toronto
    Ontario
    Canada
    Director
    20 Heathdale Road
    M6 C1M6 Toronto
    Ontario
    Canada
    Canadian/BritishManaging Director51357550001
    LONG, David James
    Orchard House West End
    Scaldwell
    NN6 9JX Northampton
    Northamptonshire
    Director
    Orchard House West End
    Scaldwell
    NN6 9JX Northampton
    Northamptonshire
    BritishDirector14862400001
    NEALE, Stephen John
    32 Cherrytree Drive
    Langley Park
    DH7 9FX Durham
    Director
    32 Cherrytree Drive
    Langley Park
    DH7 9FX Durham
    BritishDirector73218460001
    O'CONNOR, Philip Stephen
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Director
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    EnglandIrishCompany Ceo107745290001
    PEACOCK, Robert Doswell
    Eversley
    Poplars Lane
    NN6 9SW Holcot
    Northamptonshire
    Director
    Eversley
    Poplars Lane
    NN6 9SW Holcot
    Northamptonshire
    EnglandBritishDirector47931150001
    ROBERTS, Henry William
    The Anchorage
    6 Cliff Road
    HU13 0HB Hessle
    East Yorkshire
    Director
    The Anchorage
    6 Cliff Road
    HU13 0HB Hessle
    East Yorkshire
    BritishCompany Director35775050001
    SANDERSON, Donald Mark
    Larksridge House
    19 Chartridge Lane
    HP5 2JL Chesham
    Buckinghamshire
    Director
    Larksridge House
    19 Chartridge Lane
    HP5 2JL Chesham
    Buckinghamshire
    BritishConsultant514400002
    SCOTT, Anthony John
    45 Station Road
    Smallford
    AL4 0HB St Albans
    Hertfordshire
    Director
    45 Station Road
    Smallford
    AL4 0HB St Albans
    Hertfordshire
    BritishSales And Marketing Manager39208840001
    STEPHENS, Graham Robertson
    21 Brinkworthy Road
    BS16 1DP Bristol
    Director designado
    21 Brinkworthy Road
    BS16 1DP Bristol
    United KingdomBritish900009520001
    TOOMEY, John Francis
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Director
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    EnglandIrishOperating Officer164624980001
    WILGAR, Stephen Allan
    37 Gormley Avenue
    M4V 1Y9 Toronto
    Ontario
    Canada
    Director
    37 Gormley Avenue
    M4V 1Y9 Toronto
    Ontario
    Canada
    CanadianBusiness Executive51624560001

    ¿Tiene PARADISE FOODS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A supplemental deed
    Creado el 13 ene 2010
    Entregado el 14 ene 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transacciones
    • 14 ene 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 20 oct 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Composite debenture
    Creado el 24 dic 2009
    Entregado el 08 ene 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All obligations and liabilities due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed charge over any right title or interest in any land and all shareas related rights and all distribution rights thereon; all investments and related rights all book debts benefits and security thereon; all non trading debts and all benefits rights and security thereunder; fixed charge over all amounts standing to the credit of each account and any other amount; all property rights all fees royalties and other rights thereon; the goodwill and uncalled capital and benefit of all authorisations held in relation to any security interest; all insurances and floating charge over all undertaking and assets see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transacciones
    • 08 ene 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 20 oct 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Supplemental deed
    Creado el 14 mar 2008
    Entregado el 31 mar 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (As Trustee for the Finance Parties) (the Security Trustee)
    Transacciones
    • 31 mar 2008Registro de un cargo (395)
    • 20 oct 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 07 sept 2006
    Entregado el 20 sept 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (As Trustee for the Finance Parties)
    Transacciones
    • 20 sept 2006Registro de un cargo (395)
    • 20 oct 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 24 oct 2001
    Entregado el 29 oct 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 29 oct 2001Registro de un cargo (395)
    • 30 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 11 may 2000
    Entregado el 19 may 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 19 may 2000Registro de un cargo (395)
    • 17 abr 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 16 dic 1998
    Entregado el 24 dic 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under an agreement for the purchase of debts or otherwise
    Breve descripción
    By way of fixed charge all debts and their related rights purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason ("specified debts") by way of floating charge the undertaking and all property rights and assets including stock in trade and uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Royal Bank Invoice Finance Limited
    Transacciones
    • 24 dic 1998Registro de un cargo (395)
    • 20 oct 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    General debenture
    Creado el 16 sept 1998
    Entregado el 06 oct 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the hire agreement (as defined in the debenture)
    Breve descripción
    All the right,title,benefit and interest in and to:(i) all rental payments and other amounts.(ii) all guarantees,indemnities and other securities.(iii) all insurance policies.(iv) all other rights arising in respect of the equipment.all other present and future undertaking and assets,whatever and wherever.
    Personas con derecho
    • Newcourt Financial Limited
    Transacciones
    • 06 oct 1998Registro de un cargo (395)
    • 12 ene 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creado el 26 nov 1996
    Entregado el 28 nov 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The equipment described in the schedule attached the benefit of any guarantee warranty or other obligation the benefit of all agreements all copyrights patents trademarks servicemarks brand names inventions design rights know-how and other intellectual property rights the full benefit of the companys rights and interest (if any) in and to all interests in and to all insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Kavli Limited
    Transacciones
    • 28 nov 1996Registro de un cargo (395)
    • 26 jun 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 21 mar 1996
    Entregado el 28 mar 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • 3I Group PLC
    Transacciones
    • 28 mar 1996Registro de un cargo (395)
    • 26 jun 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creado el 28 nov 1995
    Entregado el 02 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Various items of equipment as detailed on form 395 including combined metal detector & checkweigher; compressor/dryer with receiver; labelling system; syrup kettle; etc. the benefit of any guarantee warranty or other obligation in relation thereto........ See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Kavli Limited
    Transacciones
    • 02 dic 1995Registro de un cargo (395)
    • 26 jun 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Single debenture
    Creado el 06 nov 1995
    Entregado el 13 nov 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 13 nov 1995Registro de un cargo (395)
    • 20 oct 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene PARADISE FOODS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    14 jun 2016Inicio de la liquidación
    05 mar 2017Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Profesional
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Profesional
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0