SOMERFIELD 24-7 LONDON LTD

SOMERFIELD 24-7 LONDON LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSOMERFIELD 24-7 LONDON LTD
    Estado de la empresaConvertida/Cerrada
    Forma jurídicaConvertida o cerrada
    Número de empresa 03008436
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SOMERFIELD 24-7 LONDON LTD?

    • (9305) /

    ¿Dónde se encuentra SOMERFIELD 24-7 LONDON LTD?

    Dirección de la sede social
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SOMERFIELD 24-7 LONDON LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SUPERMARKET DIRECT LIMITED11 ene 199511 ene 1995

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SOMERFIELD 24-7 LONDON LTD?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el04 ene 2011
    Próximas cuentas vencen el04 oct 2011
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta02 ene 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SOMERFIELD 24-7 LONDON LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Certificado de registro de una Sociedad de Socorros Mutuos

    páginasCERTIPS

    Misceláneos

    Forms b and z to convert to I & ps
    páginasMISC

    Resoluciones

    Resolutions
    páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Convert to I & ps 10/11/2010
    RES13

    Déclaration annuelle établie au 01 sept 2010 avec liste complète des actionnaires

    páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital14 sept 2010

    Estado de capital el 14 sept 2010

    • Capital: GBP 500,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 02 ene 2010

    páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Timothy Hurrell el 01 ago 2010

    páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Stephen Humes el 01 ago 2010

    páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 02 may 2009

    páginasAA

    Exercice comptable en cours raccourci du 02 may 2010 au 04 ene 2010

    páginasAA01

    Renuncia del auditor

    páginasAUD

    Domicilio social registrado cambiado de Somerfield House Whitchurch Lane Bristol BS14 0TJ el 20 nov 2009

    páginasAD01

    Cese del nombramiento de William Robson como director

    páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Caroline Jane Sellers como secretario

    páginasAP03

    Cese del nombramiento de Emily Martin como secretario

    páginasTM02

    legacy

    páginas363a

    legacy

    páginas288b

    legacy

    páginas225

    legacy

    páginas288a

    legacy

    páginas288a

    legacy

    páginas288b

    legacy

    páginas288a

    Cuentas completas preparadas hasta el 21 jun 2008

    páginasAA

    legacy

    páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 23 jun 2007

    páginasAA

    legacy

    páginas363a

    ¿Quiénes son los directivos de SOMERFIELD 24-7 LONDON LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SELLERS, Caroline Jane
    c/o Governance Dept
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Secretario
    c/o Governance Dept
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    146968990001
    HUMES, Stephen
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    Director
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    United KingdomBritish84087790001
    HURRELL, Timothy
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    Director
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United KingdomBritish99724260001
    DOOREY, Michelle Teresa
    7 Barnard House
    Ellsworth Street
    E2 0AT London
    Secretario
    7 Barnard House
    Ellsworth Street
    E2 0AT London
    British71281030001
    GRANT, Stephen Martin
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Secretario
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    British20888800002
    GRANT, Stephen Martin
    2 Beechwood Close
    Battledown
    GL52 6QQ Cheltenham
    Gloucestershire
    Secretario
    2 Beechwood Close
    Battledown
    GL52 6QQ Cheltenham
    Gloucestershire
    British20888800001
    HENSHAW, Stephen Anthony
    Eastleigh Stables
    Bishopstrow
    BA12 9HW Warminster
    Wiltshire
    Secretario
    Eastleigh Stables
    Bishopstrow
    BA12 9HW Warminster
    Wiltshire
    British91828160006
    MARTIN, Emily Louise
    49 Henley Park
    Yatton
    BS49 4JJ Bristol
    Secretario
    49 Henley Park
    Yatton
    BS49 4JJ Bristol
    British115285710001
    TELFER, Mark Ross
    Days House
    Westcot
    OX12 9QB Wantage
    Oxfordshire
    Secretario
    Days House
    Westcot
    OX12 9QB Wantage
    Oxfordshire
    British36581770001
    CORNHILL SECRETARIES LIMITED
    St Paul's House
    Warwick Lane
    EC4M 7BP London
    Secretario designado corporativo
    St Paul's House
    Warwick Lane
    EC4M 7BP London
    900023430001
    BACK, Steven John
    Fennels 119 Bicester Road
    Lower End
    HP18 9EF Long Crendon
    Director
    Fennels 119 Bicester Road
    Lower End
    HP18 9EF Long Crendon
    United KingdomBritish85825120001
    BELL, Ian Charles
    6 Treetops Avenue
    GU15 3UT Camberley
    Surrey
    Director
    6 Treetops Avenue
    GU15 3UT Camberley
    Surrey
    British42790790001
    BELL, Norman
    49 Uplands Road
    Saltford
    BS31 3JQ Bristol
    Avon
    Director
    49 Uplands Road
    Saltford
    BS31 3JQ Bristol
    Avon
    British63493610001
    CHEYNE, David George Thomson
    The Covert 98 Woodlands Road
    Ashurst
    SO40 7AH Southampton
    Hampshire
    Director
    The Covert 98 Woodlands Road
    Ashurst
    SO40 7AH Southampton
    Hampshire
    BritainBritish74956170001
    CHIDLEY, Christopher James Ozanne
    Cotterstone
    Mount Pleasant, Hartley Wintney
    RG27 8PW Hook
    Hampshire
    Director
    Cotterstone
    Mount Pleasant, Hartley Wintney
    RG27 8PW Hook
    Hampshire
    EnglandBritish68649520001
    CLARKE, Philippa Ann
    Sister Cottage
    Haslemere Road, Brook
    GU8 5UJ Haslemere
    Surrey
    Director
    Sister Cottage
    Haslemere Road, Brook
    GU8 5UJ Haslemere
    Surrey
    United KingdomBritish105895610001
    CLELAND, Jonathan Bradley
    70 Andes Close
    Ocean Village
    SO14 3HS Southampton
    Director
    70 Andes Close
    Ocean Village
    SO14 3HS Southampton
    British111624590001
    FLANAGAN, Adrian Charles Edwin
    Flat 2 30 Onslow Gardens
    SW7 3AH London
    Director
    Flat 2 30 Onslow Gardens
    SW7 3AH London
    British10403730002
    GATTO, Salvatore Martin
    11 Cavendish Lodge
    Cavendish Road
    BA1 2UD Bath
    Avon
    Director
    11 Cavendish Lodge
    Cavendish Road
    BA1 2UD Bath
    Avon
    United KingdomBritish37327260002
    GRANT, Stephen Martin
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    British20888800002
    HENSHAW, Stephen Anthony
    2 Ashton Coombe Lower Road
    Bratton
    BA13 4JQ Westbury
    Wiltshire
    Director
    2 Ashton Coombe Lower Road
    Bratton
    BA13 4JQ Westbury
    Wiltshire
    British91828160003
    HUGHES, Simon Donnell
    Rosebank 36 Chelmsford Road
    Shenfield
    CM15 8RJ Brentwood
    Essex
    Director
    Rosebank 36 Chelmsford Road
    Shenfield
    CM15 8RJ Brentwood
    Essex
    United KingdomBritish258735520001
    MCHUGH, Shaun
    21 Glena Mount
    SM1 4HW Sutton
    Surrey
    Director
    21 Glena Mount
    SM1 4HW Sutton
    Surrey
    United KingdomBritish67057450001
    MISKIN, Warren David
    2 Forest Close
    Snaresbrook
    E11 1PY London
    Director
    2 Forest Close
    Snaresbrook
    E11 1PY London
    British9269420001
    NINIAN, Stuart Alastair
    8 Westbury Lodge Close
    HA5 3FG Pinner
    Middlesex
    Director
    8 Westbury Lodge Close
    HA5 3FG Pinner
    Middlesex
    British57102510001
    NOBLE, David George
    Rue Michel Chauvet 12
    1208 Geneve
    Switzerland
    Director
    Rue Michel Chauvet 12
    1208 Geneve
    Switzerland
    SwitzerlandBritish113183280001
    RILEY, Lisa
    122 Hampton Road
    Redland
    BS6 6JD Bristol
    Avon
    Director
    122 Hampton Road
    Redland
    BS6 6JD Bristol
    Avon
    British63271170002
    ROBSON, William Henry Mark
    12 Kimble Close
    Knightcote
    CV47 2SJ Southam
    Warwickshire
    Director
    12 Kimble Close
    Knightcote
    CV47 2SJ Southam
    Warwickshire
    EnglandBritish57803420002
    SCOTT-FLANAGAN, Dominick James Trevlyn
    40 Muncaster Road
    SW11 6NU London
    Director
    40 Muncaster Road
    SW11 6NU London
    British74108110003
    SMITH, Ian Michael Somerfield
    26a Trentham Street
    SW18 5AT London
    Director
    26a Trentham Street
    SW18 5AT London
    British64449510001
    TELFER, Mark Ross
    Days House
    Westcot
    OX12 9QB Wantage
    Oxfordshire
    Director
    Days House
    Westcot
    OX12 9QB Wantage
    Oxfordshire
    British36581770001
    WRIGHT, Edward Bruce Beverley
    24 Valiant House
    Vicarage Crescent
    SW11 3LU London
    Director
    24 Valiant House
    Vicarage Crescent
    SW11 3LU London
    British42790810002

    ¿Tiene SOMERFIELD 24-7 LONDON LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 01 may 1995
    Entregado el 18 may 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Betterware PLC
    Transacciones
    • 18 may 1995Registro de un cargo (395)
    • 04 abr 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0