D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED

D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaD K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03008724
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED?

    • Otras actividades especializadas de construcción n.c.p. (43999) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    6th Floor 33 Holborn
    EC1N 2HT London
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BERIA LIMITED11 ene 199511 ene 1995

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cambio de datos del director Mr Mark Woodall el 30 jul 2018

    2 páginasCH01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2017

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 11 ene 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2016

    2 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 11 ene 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2015

    2 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de 5 Godalming Business Centre Woolsack Way Godalming Surrey GU7 1XW a 6th Floor 33 Holborn London EC1N 2HT el 31 may 2016

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 11 ene 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 ene 2016

    Estado de capital el 18 ene 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2014

    2 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 11 ene 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 ene 2015

    Estado de capital el 12 ene 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2013

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 11 ene 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital13 ene 2014

    Estado de capital el 13 ene 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    2 páginasAA

    Exercice comptable en cours raccourci du 31 dic 2013 au 30 sept 2013

    1 páginasAA01

    Déclaration annuelle établie au 11 ene 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Asset Management Solutions Limited como secretario

    2 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Beif Ii Corporate Services Limited como director

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Robert Mcclatchey como director

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Ernest Battey como director

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Andrew Livingston como director

    2 páginasTM01

    Nombramiento de International Administration Group (Guernsey) Limited como secretario

    3 páginasAP04

    Nombramiento de Iag Limited como director

    3 páginasAP02

    ¿Quiénes son los directivos de D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    INTERNATIONAL ADMINISTRATION GROUP (GUERNSEY) LIMITED
    Glategny Esplanade
    GY1 1WW St Peter Port
    Regency Court
    Guernsey
    Guernsey
    Secretario corporativo
    Glategny Esplanade
    GY1 1WW St Peter Port
    Regency Court
    Guernsey
    Guernsey
    Forma jurídicaLIMITED COMPANY
    Tipo de identificaciónNo EEE
    Autoridad legalGUERNSEY
    Número de registro36305
    123212890003
    WOODALL, Mark Andrew
    Glategny Esplanade
    GY1 1WW St Peter Port
    Regency Court
    Guernsey
    Guernsey
    Director
    Glategny Esplanade
    GY1 1WW St Peter Port
    Regency Court
    Guernsey
    Guernsey
    GuernseyBritish179218860001
    IAG LIMITED
    Glategny Esplanade
    GY1 1WW St Peter Port
    Regency Court
    Guernsey
    Guernsey
    Director corporativo
    Glategny Esplanade
    GY1 1WW St Peter Port
    Regency Court
    Guernsey
    Guernsey
    Forma jurídicaLIMITED COMPANY
    Tipo de identificaciónNo EEE
    Autoridad legalGUERNSEY
    Número de registro45079
    171273930001
    FAY, Martin Lawrence
    Crofton Cliff Crofton Avenue
    PO13 9NJ Lee On The Solent
    Hampshire
    Secretario
    Crofton Cliff Crofton Avenue
    PO13 9NJ Lee On The Solent
    Hampshire
    British8066790001
    JOHNSTON, William Raymond
    9 Beverley Court
    59 Fairfax Road
    NW6 4EG London
    Secretario
    9 Beverley Court
    59 Fairfax Road
    NW6 4EG London
    British37227240001
    NETTLESHIP, Isobel Mary
    Kent House
    14 - 17 Market Place
    W1W 8AJ London
    Secretario
    Kent House
    14 - 17 Market Place
    W1W 8AJ London
    British147086990001
    SHERIDAN, Clare
    Kent House
    14 - 17 Market Place
    W1W 8AJ London
    Secretario
    Kent House
    14 - 17 Market Place
    W1W 8AJ London
    British74216410002
    ASSET MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED
    Charles Street
    CF10 2GE Cardiff
    46
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Charles Street
    CF10 2GE Cardiff
    46
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro03008724
    166036180001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Secretario designado corporativo
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    BATTEY, Ernest Stephen
    Furnival Street
    EC4A 1AB London
    10
    United Kingdom
    Director
    Furnival Street
    EC4A 1AB London
    10
    United Kingdom
    British28614660001
    BENNETT, Nigel Anthony
    7 Courtneidge Close
    LU7 0EL Stewkley
    Bedfordshire
    Director
    7 Courtneidge Close
    LU7 0EL Stewkley
    Bedfordshire
    EnglandBritish74375610001
    BISHOP, John Michael
    Orchard View
    Tintells Lane
    KT24 6JD West Horsley
    Surrey
    Director
    Orchard View
    Tintells Lane
    KT24 6JD West Horsley
    Surrey
    EnglandBritish116243840001
    BURGESS, Richard John
    54 Manor Road
    SM2 7AG Cheam
    Surrey
    Director
    54 Manor Road
    SM2 7AG Cheam
    Surrey
    United Kingdom ( England ) (Gb-Eng)British35427700001
    DIXON, Richard John
    Furnival Street
    EC4A 1AB London
    10
    Director
    Furnival Street
    EC4A 1AB London
    10
    United KingdomBritish130277830002
    EMINSON, Clive Franklin
    Garden Cottage Stratton Hall Lane
    Levington
    IP10 0LH Ipswich
    Suffolk
    Director
    Garden Cottage Stratton Hall Lane
    Levington
    IP10 0LH Ipswich
    Suffolk
    EnglandBritish39767370001
    FAY, Linda Diane Isabel
    Crofton Cliff
    Crofton Avenue
    PO13 9NJ Lee On The Solent
    Hampshire
    Director
    Crofton Cliff
    Crofton Avenue
    PO13 9NJ Lee On The Solent
    Hampshire
    British38454870001
    FAY, Martin Lawrence
    Crofton Cliff Crofton Avenue
    PO13 9NJ Lee On The Solent
    Hampshire
    Director
    Crofton Cliff Crofton Avenue
    PO13 9NJ Lee On The Solent
    Hampshire
    British8066790001
    HARTSHORN, Timothy
    5 Freston Road
    N3 1UP London
    Director
    5 Freston Road
    N3 1UP London
    British103668910001
    KEITH, Alistair
    Wildacre
    South Munstead Lane
    GU8 4AG Godalming
    Surrey
    Director
    Wildacre
    South Munstead Lane
    GU8 4AG Godalming
    Surrey
    British69099040002
    LIVINGSTON, Andrew James
    Furnival Street
    EC4A 1AB London
    10
    United Kingdom
    Director
    Furnival Street
    EC4A 1AB London
    10
    United Kingdom
    EnglandBritish132011640001
    MCCLATCHEY, Robert Sean
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc
    Director
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc
    United KingdomBritish140441450001
    STYLES, Robert James
    7 Churchill Place
    E14 5HP London
    Director
    7 Churchill Place
    E14 5HP London
    United KingdomBritish102666050001
    TASKER, Ian James
    26 Ravensbourne Avenue
    BR2 0BP Bromley
    Kent
    Director
    26 Ravensbourne Avenue
    BR2 0BP Bromley
    Kent
    EnglandBritish84496470004
    BEIF II CORPORATE SERVICES LIMITED
    100 Wood Street
    EC2V 7EX London
    Fifth Floor
    United Kingdom
    Director corporativo
    100 Wood Street
    EC2V 7EX London
    Fifth Floor
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro07002591
    151210770001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Director designado corporativo
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Director designado corporativo
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Medicx Fund Limited
    Glategny Esplanade
    St. Peter Port
    GY1 1WW Guernsey
    Regency Court
    Channel Islands
    06 abr 2016
    Glategny Esplanade
    St. Peter Port
    GY1 1WW Guernsey
    Regency Court
    Channel Islands
    No
    Forma jurídicaCompany Limited By Shares
    País de registro45397
    Autoridad legalThe Companies (Guernsey) Law, 2008
    Lugar de registroGuernsey
    Número de registro45397
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed of legal charge
    Creado el 25 ene 2000
    Entregado el 27 ene 2000
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from primary medical property limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of primary medical property limited and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to the chargee as trustee for itself and the other lenders ("trustee") or the trustee, norwich union PLC any company which is or becomes a holding company of any such company of subsidiary or associate of any such company or holding company which lends or has lent to, or is at any time owed monies by, any group member ("lenders") or for or in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lenders on any account whatsoever
    Breve descripción
    49 portsmouth rd woolston southampton, land and buildings on the south east side of beaulieu rd dibden purlieu southampton and briar cottage beaulieu rd dibden together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenant's fixtures) and fitting thereon and all improvements and additions thereto and all easements rights and licences appurtenant thereto, all monies deposited with the trustee on the terms set out in schedule 6 to the deed, floating charge the whole of the property, assets, rights and revenues including the uncalled share capital (if any). See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transacciones
    • 27 ene 2000Registro de un cargo (395)
    Assignment by way of charge
    Creado el 20 dic 1999
    Entregado el 30 dic 1999
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from primary medical properties investments limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of primary medical properties investments limited on any account whatsoever and in any manner whatsoever to the general practice finance corporation limited under the provisions of the deed of legal charge dated 20TH december 1999
    Breve descripción
    All rights titles and interests and whether present or future of the compny the occupational leases in respect of the property at 49 portsmouth road woolston southampton and at beaulieu road dibden purlieu southampton. All sums due by way of insurance rent. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transacciones
    • 30 dic 1999Registro de un cargo (395)
    Deed of legal charge
    Creado el 20 dic 1999
    Entregado el 30 dic 1999
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    £2,304,457.00 owed by primary medical investments limited together with interest thereon pursuant to the provisions of the legal charge and all monies laid out by the general practice finance corporation limited under any of the provisions of the legal charge
    Breve descripción
    F/H property k/a 49 portsmouth road woolston southampton together with fixtures and fittings and equipment and all f/h property at beaulieu road dibden purlieu southampton. Floating charge all undertakings property assets and rights present and future.
    Personas con derecho
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transacciones
    • 30 dic 1999Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 24 sept 1998
    Entregado el 05 oct 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    49 portsmouth road woolston southampton hampshire t/no;-HP469177.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 05 oct 1998Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0