PARTNERSHIP INCORPORATIONS LIMITED

PARTNERSHIP INCORPORATIONS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPARTNERSHIP INCORPORATIONS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03011126
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PARTNERSHIP INCORPORATIONS LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra PARTNERSHIP INCORPORATIONS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PARTNERSHIP INCORPORATIONS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2010

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para PARTNERSHIP INCORPORATIONS LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PARTNERSHIP INCORPORATIONS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Presentación de insolvencia

    Insolvency:s/s cert. Release of liquidator
    1 páginasLIQ MISC

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    18 páginas4.71

    Aviso de cese de funciones como liquidador voluntario

    1 páginas4.40

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Domicilio social registrado cambiado de 1St Floor Unit 16 Manor Court Business Park Scarborough YO11 3TU United Kingdom a The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG el 28 jul 2014

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 10 jul 2014

    LRESSP

    Notificación de finalización del acuerdo voluntario

    9 páginas1.4

    Cese del nombramiento de Sally King como secretario

    1 páginasTM02

    Cambio de datos del director Mr James Alistair Sullivan el 01 jul 2013

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Mrs Sally Frances King el 01 jul 2013

    2 páginasCH03

    Domicilio social registrado cambiado de * Europa House 20 Esplanade Scarborough North Yorkshire YO11 2AQ England* el 04 jul 2013

    1 páginasAD01

    Resumen de ingresos y gastos del supervisor del acuerdo voluntario hasta 10 abr 2013

    8 páginas1.3

    Notificación al Registro Mercantil del acuerdo voluntario de empresas que entra en vigor

    4 páginas1.1

    Déclaration annuelle établie au 09 ene 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital10 ene 2012

    Estado de capital el 10 ene 2012

    • Capital: GBP 5,750
    SH01

    Cambio de datos del secretario Mrs Sally Frances King el 09 ene 2012

    1 páginasCH03

    Domicilio social registrado cambiado de * 64 North Row London W1K 7DA* el 13 oct 2011

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Valad Secretarial Services Limited como secretario

    2 páginasAP04

    Cese del nombramiento de Amir Zaidi como director

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2010

    30 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 09 ene 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr James Alistair Sullivan el 12 ene 2011

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr James Alistair Sullivan el 30 jul 2010

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de PARTNERSHIP INCORPORATIONS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    Exchange Place 3
    Scotland
    Secretario corporativo
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    Exchange Place 3
    Scotland
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registroSC219311
    133355520001
    SULLIVAN, James Alistair
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Director
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor126441710003
    WEBBER, Simon Timothy Christopher
    Hurdsfield Road
    SK10 2QX Macclesfield
    169
    Cheshire
    Director
    Hurdsfield Road
    SK10 2QX Macclesfield
    169
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector91415340001
    CRIGHTON, Kevin William
    10 Cleveland Drive
    TW18 2SW Laleham
    Middlesex
    Secretario
    10 Cleveland Drive
    TW18 2SW Laleham
    Middlesex
    BritishDirector36597270003
    DEVINE, David John
    105 Nelson Road
    South Wimbledon
    SW19 1HU London
    Secretario
    105 Nelson Road
    South Wimbledon
    SW19 1HU London
    BritishCompany Secretary117499680002
    EDELSTEIN, Tony Warren
    74 Longland Drive
    Totteridge
    N20 8HL London
    Secretario
    74 Longland Drive
    Totteridge
    N20 8HL London
    BritishLegacy Officer46507060001
    KING, Sally Frances
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Secretario
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    149983360001
    MAGNUS, Alan Melvyn
    Autumn Leaves
    Latimer Road Monken
    EN5 5NU Hadley Barnet
    Hertfordshire
    Secretario
    Autumn Leaves
    Latimer Road Monken
    EN5 5NU Hadley Barnet
    Hertfordshire
    BritishRetired88944620002
    SULLIVAN, Anthony Nicholas John
    10 Dukes Orchard
    DA5 2DU Bexley
    Kent
    Secretario
    10 Dukes Orchard
    DA5 2DU Bexley
    Kent
    British1823720001
    WILLIAMSON, Edward Leigh
    North Row
    W1K 7DA London
    64
    Secretario
    North Row
    W1K 7DA London
    64
    British137886520001
    FETTER SECRETARIES LIMITED
    C/O Kendall Freeman
    43 Fetter Lane
    EC4A 1JU London
    Secretario corporativo
    C/O Kendall Freeman
    43 Fetter Lane
    EC4A 1JU London
    71203580001
    CORLETT, Robert John
    102 Deacon Road
    KT2 6LU Kingston Upon Thames
    Surrey
    Director
    102 Deacon Road
    KT2 6LU Kingston Upon Thames
    Surrey
    EnglandBritishChartered Surveyor72399980002
    CRIGHTON, Kevin William
    10 Cleveland Drive
    TW18 2SW Laleham
    Middlesex
    Director
    10 Cleveland Drive
    TW18 2SW Laleham
    Middlesex
    United KingdomBritishDirector36597270003
    DIGBY-ROGERS, Jonathan
    26 Gipsy Hill
    SE19 1NL London
    Director
    26 Gipsy Hill
    SE19 1NL London
    EnglandBritishAccountant29552920009
    DISMORR, Robert James
    3 Wykeham Lodge
    16 Chaddesley Glen
    BH13 7NZ Poole
    Dorset
    Director
    3 Wykeham Lodge
    16 Chaddesley Glen
    BH13 7NZ Poole
    Dorset
    BritishChartered Surveyor98176410001
    DOOLEY, Peter Anthony
    Kivulini
    Windmill Road
    TN13 1TN Sevenoaks
    Kent
    Director
    Kivulini
    Windmill Road
    TN13 1TN Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritishDirector125020990001
    EDELSTEIN, Tony Warren
    74 Longland Drive
    Totteridge
    N20 8HL London
    Director
    74 Longland Drive
    Totteridge
    N20 8HL London
    BritishRetired46507060001
    KING-CLINE, Anthony Laurence
    16 Folkington Corner
    N12 7BH London
    Director
    16 Folkington Corner
    N12 7BH London
    United KingdomBritishChartered Surveyor34461460001
    MAGNUS, Alan Melvyn
    Autumn Leaves
    Latimer Road Monken
    EN5 5NU Hadley Barnet
    Hertfordshire
    Director
    Autumn Leaves
    Latimer Road Monken
    EN5 5NU Hadley Barnet
    Hertfordshire
    BritishRetired88944620002
    NORRIS, Anthony Carmelo
    Little Hollow
    Seal Hollow Road
    TN13 3SF Sevenoaks
    Kent
    Director
    Little Hollow
    Seal Hollow Road
    TN13 3SF Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritishChartered Accountant70951730005
    NORRIS, David Paul
    Brook Cottage
    Coles Lane
    TN16 1NR Brasted
    Kent
    Director
    Brook Cottage
    Coles Lane
    TN16 1NR Brasted
    Kent
    EnglandBritishCompany Director185808850001
    OLIVER, Paul Francis
    6 Burnaby Crescent
    Chiswick
    W4 3LH London
    Director
    6 Burnaby Crescent
    Chiswick
    W4 3LH London
    BritishCompany Director14735150001
    PRICE, Nicholas John
    The Beeches
    40 Norwich Road Strumpshaw
    NR13 4AG Norwich
    Norfolk
    Director
    The Beeches
    40 Norwich Road Strumpshaw
    NR13 4AG Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritishChartered Surveyor33272810001
    TRUSTRAM EVE, John Richard
    Astra Court
    Hythe
    SO45 6DZ Southampton
    2
    Hampshire
    Director
    Astra Court
    Hythe
    SO45 6DZ Southampton
    2
    Hampshire
    EnglandBritishChartered Surveyor2751740003
    ZAIDI, Amir Hassan
    Windemere Avenue
    HA9 8SF Wembley
    48
    Middlesex
    United Kingdom
    Director
    Windemere Avenue
    HA9 8SF Wembley
    48
    Middlesex
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant148106780001
    FETTER INCORPORATIONS LIMITED
    C/O Kendall Freeman
    43 Fetter Lane
    EC4A 1JU London
    Director corporativo
    C/O Kendall Freeman
    43 Fetter Lane
    EC4A 1JU London
    71203570001

    ¿Tiene PARTNERSHIP INCORPORATIONS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Assignment of contract by way of security
    Creado el 19 dic 2006
    Entregado el 22 dic 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from european added value fund,L.P. To the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The following rights title and interest in and to the partnership deed and the application forms all monetary debts and claims the benefit of all related rights and remedies. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland International Limited Acting as Agent and Trustee Under Theagreement for and on Behalf of Itself and the Finance Parties
    Transacciones
    • 22 dic 2006Registro de un cargo (395)
    • 11 mar 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 02 feb 2004
    Entregado el 03 feb 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 03 feb 2004Registro de un cargo (395)
    • 17 jun 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Rental deposit deed
    Creado el 29 abr 2003
    Entregado el 02 may 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Rent deposit of £17,500 with all interest thereon held in a deposit account.
    Personas con derecho
    • Abdul Bhanji
    Transacciones
    • 02 may 2003Registro de un cargo (395)
    • 18 feb 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    ¿Tiene PARTNERSHIP INCORPORATIONS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    11 abr 2012Fecha de la reunión para aprobar el CVA
    02 jun 2014Fecha de finalización o terminación del CVA
    Acuerdo voluntario de reestructuración empresarial (CVA)
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Patrick Joseph Brazzill
    Ernst & Young Llp 1 More London Place
    SE1 2AF London
    Profesional
    Ernst & Young Llp 1 More London Place
    SE1 2AF London
    2
    FechaTipo
    10 jul 2014Inicio de la liquidación
    21 jul 2015Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Geoffrey Wayne Bouchier
    The Shard,32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Profesional
    The Shard,32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Paul John Clark
    The Shard 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Profesional
    The Shard 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Paul David Williams
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Profesional
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0