PRIMECARE ORAL HEALTH SERVICES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PRIMECARE ORAL HEALTH SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03012467 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PRIMECARE ORAL HEALTH SERVICES LIMITED?
- Actividades de los odontólogos (86230) / Actividades sanitarias y de asistencia social
¿Dónde se encuentra PRIMECARE ORAL HEALTH SERVICES LIMITED?
| Dirección de la sede social | 2 College Court Morley LS27 7WF Leeds England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PRIMECARE ORAL HEALTH SERVICES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| HEALTHCALL LANARKSHIRE LIMITED | 21 ago 1996 | 21 ago 1996 |
| EMERGENCY MEDICAL SERVICES (LANARKSHIRE) LIMITED | 06 mar 1995 | 06 mar 1995 |
| LAW 624 LIMITED | 20 ene 1995 | 20 ene 1995 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PRIMECARE ORAL HEALTH SERVICES LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para PRIMECARE ORAL HEALTH SERVICES LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 20 ene 2027 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 03 feb 2027 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 20 ene 2026 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PRIMECARE ORAL HEALTH SERVICES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 20 ene 2026 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Dr Nadim Majid como director el 01 ene 2026 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Graeme Michael Rowden como director el 01 ene 2026 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas no auditadas abreviadas presentadas hasta el 31 mar 2025 | 7 páginas | AA | ||
Registro de la carga 030124670007, creada el 03 nov 2025 | 12 páginas | MR01 | ||
Registro de la carga 030124670006, creada el 03 nov 2025 | 37 páginas | MR01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 20 ene 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas no auditadas abreviadas presentadas hasta el 31 mar 2024 | 7 páginas | AA | ||
Domicilio social registrado cambiado de Unit 4 Carlton Court Brown Lane West Leeds LS12 6LT England a 2 College Court Morley Leeds LS27 7WF el 31 ene 2024 | 1 páginas | AD01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 20 ene 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas no auditadas abreviadas presentadas hasta el 31 mar 2023 | 9 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 20 ene 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas no auditadas abreviadas presentadas hasta el 31 mar 2022 | 9 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Hassnain Hamid como director el 01 mar 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Graeme Rowden como director el 01 mar 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 20 ene 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2021 | 8 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Mohammed Shoeb Syed como director el 01 jul 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Mustafa Tariq Mohammed como director el 01 jul 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cancelación total de la carga 030124670005 | 1 páginas | MR04 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 mar 2020 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 20 ene 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 164-166 High Road Ilford IG1 1LL England a Unit 4 Carlton Court Brown Lane West Leeds LS12 6LT el 24 feb 2021 | 1 páginas | AD01 | ||
Cancelación total de la carga 030124670004 | 1 páginas | MR04 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Queens Specialist Building Queen Street Farnworth Bolton BL4 7AH England a 164-166 High Road Ilford IG1 1LL el 01 dic 2020 | 1 páginas | AD01 | ||
¿Quiénes son los directivos de PRIMECARE ORAL HEALTH SERVICES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZAM, Wajid Mahmood, Dr | Director | College Court Morley LS27 7WF Leeds 2 England | England | British | 150079800001 | |||||
| MAJID, Nadim, Dr | Director | College Court Morley LS27 7WF Leeds 2 England | England | British | 259070480001 | |||||
| SYED, Mohammed Shoeb | Director | College Court Morley LS27 7WF Leeds 2 England | England | British | 265584240001 | |||||
| COLLISON, David | Secretario | Queen Street Farnworth BL4 7AH Bolton Queens Specialist Building England | 204254250001 | |||||||
| COLLISON, David | Secretario | 44 Lowther Road SW13 9NU London England | British | 34835160001 | ||||||
| DAVIES, John | Secretario | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | 158562240001 | |||||||
| HAYNES, Victoria | Secretario | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | British | 182412280001 | ||||||
| HAYNES, Victoria | Secretario | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | British | 182412280001 | ||||||
| LYNAS, Brian | Secretario | 3 Woodlands Gardens ML3 7JE Hamilton Lanarkshire | British | 830460004 | ||||||
| ROBERTS THOMAS, Caroline Emma | Secretario | 5 Broomsleigh Street NW6 1QQ London | British | 76032450005 | ||||||
| SPINK, David | Secretario | 2 Monkswood West End Silverstone NN12 8TG Towcester Northamptonshire | British | 34518140003 | ||||||
| STRINGER, Andrew Paul | Secretario | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | 171552350001 | |||||||
| HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED | Secretario designado corporativo | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 900008160001 | |||||||
| BAGNALL, Winifred | Director | 6 Birchwood Avenue North Gosforth NE13 6PZ Newcastle-Upon-Tyne | British | 42349620001 | ||||||
| BANCEWICZ, Desmond, Doctor | Director | 140 Brownside Mews Brownside Road Cambuslang G72 8AH Glasgow | British | 42144280001 | ||||||
| BOOTY, Stephen Martin | Director | South Lodge Guildford Road KT24 5QE Effingham Surrey | England | British | 147928010001 | |||||
| BOYLE, Stephen John, Dr | Director | Beaconsfield Road AL10 8HU Hatfield Beaconsfield Court Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 116498170003 | |||||
| BRADLEY, Myles Bernard Sean | Director | Coney Garth 3 Kirkby Road HG4 2EY Ripon North Yorkshire | England | British | 116484150002 | |||||
| BURNS, Robert Ian | Director | 6 Netherfield Road AL5 2AG Harpenden Hertfordshire | England | British | 36584260002 | |||||
| COOK, William Ronald | Director | 44 Orchard Street ML1 3JD Motherwell Lanarkshire | British | 368570002 | ||||||
| DUNNE, Stephen Michael | Director | Queen Street Farnworth BL4 7AH Bolton Queens Specialist Building England | England | British | 197023800001 | |||||
| ELLIS, Martyn Anthony | Director | Beaconsfield Road AL10 8HU Hatfield Beaconsfield Court Hertfordshire | England | British | 95749550002 | |||||
| GIBSON, Darryn Stanley | Director | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | United Kingdom | New Zealander | 177930490001 | |||||
| HAMID, Hassnain | Director | Carlton Court Brown Lane West LS12 6LT Leeds Unit 4 England | England | British | 149613690001 | |||||
| HENCHEY, Maurice David | Director | Hamels Mead Braughing SG9 9ND Buntingford Hertfordshire | United Kingdom | British | 17815290002 | |||||
| HOWARD, Nigel Peter | Director | 86 Rewley Road OX1 2RQ Oxford | British | 124147420001 | ||||||
| IVERS, John Joseph | Director | Sandon Brook Manor Maldon Road CM2 7RZ Chelmsford Brook Lodge Essex | United Kingdom | British | 77692980002 | |||||
| JEWITT, Justin Allan Spaven, Professor | Director | The Stables 89 Aston End Road Aston SG2 7EY Stevenage Hertfordshire | England | British | 39701670001 | |||||
| LUNIYA, Hemraj, Dr | Director | Beaconsfield Road AL10 8HU Hatfield Beaconsfield House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | Indian | 150145970001 | |||||
| LYNAS, Brian | Director | 3 Woodlands Gardens ML3 7JE Hamilton Lanarkshire | British | 830460004 | ||||||
| LYON, David Oliver | Director | 41 Park Avenue North AL5 2EE Harpenden Hertfordshire | England | British | 51084280003 | |||||
| MOHAMMED, Mustafa Tariq | Director | Carlton Court Brown Lane West LS12 6LT Leeds Unit 4 England | England | British | 106868800001 | |||||
| PAGE, Stephen Robert | Director | Oak Tree House Berry Lane WD3 5EY Chorleywood Hertfordshire | England | British | 257896700001 | |||||
| ROBERTS THOMAS, Caroline Emma | Director | 5 Broomsleigh Street NW6 1QQ London | British | 76032450005 | ||||||
| ROWDEN, Graeme Michael | Director | College Court Morley LS27 7WF Leeds 2 England | England | British | 293142630001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de PRIMECARE ORAL HEALTH SERVICES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr Mustafa Tariq Mohammed | 04 abr 2017 | College Court Morley LS27 7WF Leeds 2 England | No | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Nestor Primecare Services Limited | 06 abr 2016 | Lakhpur Court Staffordshire Technology Park ST18 0FX Stafford Cavendish House England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0