STONEWEG INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | STONEWEG INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03014116 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de STONEWEG INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LIMITED?
- Administración de bienes inmobiliarios por cuenta ajena (68320) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra STONEWEG INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LIMITED?
| Dirección de la sede social | 5th Floor Minerva House 29 East Parade LS1 5PS Leeds England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de STONEWEG INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CROMWELL INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 24 feb 2017 | 24 feb 2017 |
| VALAD INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 25 feb 2010 | 25 feb 2010 |
| IO DEVELOPMENTS LIMITED | 15 may 1995 | 15 may 1995 |
| VIDACHOICE LIMITED | 25 ene 1995 | 25 ene 1995 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de STONEWEG INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para STONEWEG INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 18 dic 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 01 ene 2027 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 18 dic 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para STONEWEG INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombramiento de Mr Robert James Cotterell como director el 31 dic 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 dic 2025 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Timothy William Sewell como director el 31 dic 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Timothy William Sewell el 20 dic 2024 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Cromwell Corporate Secretarial Limited el 04 feb 2025 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 30 jun 2025 au 31 dic 2025 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew John Creighton como director el 30 ene 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Cromwell Director Limited el 14 ene 2025 | 1 páginas | CH02 | ||||||||||
Modification des détails de Cromwell Holdings Europe Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 14 ene 2025 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 30 jun 2024 | 21 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 2 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed cromwell investment management services LIMITED\certificate issued on 14/01/25 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 dic 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
legacy | 49 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Susan Kathleen White como director el 07 jun 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 30 jun 2023 | 20 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 50 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 dic 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Timothy William Sewell el 10 may 2023 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Cromwell Director Limited el 10 may 2023 | 1 páginas | CH02 | ||||||||||
Modification des détails de Cromwell Holdings Europe Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 may 2023 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Nombramiento de Susan Kathleen White como director el 17 may 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de STONEWEG INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STONEWEG CORPORATE SECRETARIAL LIMITED | Secretario corporativo | Lochrin Square 92-98 Fountainbridge EH3 9QA Edinburgh 1 United Kingdom |
| 133355520023 | ||||||||||
| COTTERELL, Robert James | Director | Minerva House 29 East Parade LS1 5PS Leeds 5th Floor England | England | British | 323785750001 | |||||||||
| STONEWEG UK DIRECTOR LIMITED | Director corporativo | Minerva House 29 East Parade LS1 5PS Leeds 5th Floor England |
| 102622300010 | ||||||||||
| SHEPHERD, Marcus Owen | Secretario | 64 Clarence Road TW11 0BW Teddington Middx | British | 41925000003 | ||||||||||
| WHELAN, Jeff | Secretario designado | 182 Hermitage Road N4 1NN London | British | 900010240001 | ||||||||||
| BATTERS, Nigel Ian | Director | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom | Netherlands | Australian | 269678150014 | |||||||||
| BEARMAN, Christian James Alexander | Director | Floor Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st United Kingdom | United Kingdom | British | 227996930001 | |||||||||
| BIRD, Matthew Jonathan | Director | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom | England | British | 255026040001 | |||||||||
| COTTERELL, Robert James | Director | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 172401090002 | |||||||||
| CREIGHTON, Andrew John | Director | Minerva House 29 East Parade LS1 5PS Leeds 5th Floor England | England | British | 157788960001 | |||||||||
| JAMES, Peter Richard | Director | 19 Amity Grove SW20 0LQ London | British | 62613380002 | ||||||||||
| MARRIOTT, Simon Crosbie | Director | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom | England | British | 116100370001 | |||||||||
| MCCARTHY, Martyn James | Director | Floor Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st United Kingdom | United Kingdom | Australian | 126149680033 | |||||||||
| OKUNOLA, Abayomi Abiodun | Director | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire | England | British | 135717740001 | |||||||||
| RUTLAND, Alan | Director designado | 82 Stanley Road CO15 2BL Clacton On Sea Essex | British | 900010230001 | ||||||||||
| SEWELL, Timothy William | Director | Minerva House 29 East Parade LS1 5PS Leeds 5th Floor England | England | British | 154627410017 | |||||||||
| SHEPHERD, Marcus Owen | Director | 64 Clarence Road TW11 0BW Teddington Middx | United Kingdom | British | 41925000003 | |||||||||
| SIMS, John Robert | Director | The Old Rectory Creeting St Peter IP6 8QJ Ipswich Suffolk | United Kingdom | British | 1925990001 | |||||||||
| SLIPPER, Andrew Martin | Director | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire | England | British | 8512670001 | |||||||||
| TREACY, Claire | Director | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | Irish | 189529610001 | |||||||||
| WHITE, Susan Kathleen | Director | Minerva House 29 East Parade LS1 5PS Leeds 5th Floor United Kingdom | United Kingdom | American | 309167210001 | |||||||||
| WILLIAMS, Daniel Edmund Nicholas | Director | 70 Perrers Road W6 0EZ London | British | 62613430001 | ||||||||||
| YATES, Andrew Desmond | Director | Hautbois Loudwater Heights Loudwater WD3 4AX Rickmansworth Hertfordshire | United Kingdom | British | 4984260002 | |||||||||
| VALSEC DIRECTOR LIMITED | Director corporativo | Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House 20 North Yorkshire |
| 102622300002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de STONEWEG INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoneweg Holdings Europe Limited | 06 abr 2016 | Minerva House 29 East Parade LS1 5PS Leeds 5th Floor England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0