PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED

PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03024878
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Devon Lodge
    Iddesleigh
    EX19 8BE Winkleigh
    Devon
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MERCANTILE LEASING COMPANY (NO.162) LIMITED22 feb 199522 feb 1995

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    4 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 22 feb 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital23 feb 2015

    Estado de capital el 23 feb 2015

    • Capital: GBP 102
    SH01

    Domicilio social registrado cambiado de Beechfield House Winterton Way Lyme Green Business Park Macclesfield Cheshire SK11 0LP a Devon Lodge Iddesleigh Winkleigh Devon EX19 8BE el 09 feb 2015

    1 páginasAD01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 mar 2014

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 22 feb 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 mar 2014

    Estado de capital el 04 mar 2014

    • Capital: GBP 102
    SH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 mar 2013

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 22 feb 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cambio de datos del secretario Miss Jane Elizabeth Ruston el 01 ene 2013

    1 páginasCH03

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 mar 2012

    4 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de * Suite 14 Beechfield House Winterton Way Lyme Green Business Pk, Macclesfield, Cheshire SK11 0LP* el 04 dic 2012

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 22 feb 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 mar 2011

    4 páginasAA

    Cese del nombramiento de Peter Beale como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Peter Anthony Martin Dillon como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 22 feb 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 mar 2010

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 22 feb 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2008

    5 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 mar 2007

    5 páginasAA

    legacy

    2 páginas363a

    legacy

    1 páginas190

    ¿Quiénes son los directivos de PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    RUSTON, Jane Elizabeth
    Iddesleigh
    EX19 8BE Winkleigh
    Devon Lodge
    Devon
    England
    Secretario
    Iddesleigh
    EX19 8BE Winkleigh
    Devon Lodge
    Devon
    England
    British70986180008
    DILLON, Peter Anthony Martin
    Iddesleigh
    EX19 8BE Winkleigh
    Devon Lodge
    Devon
    England
    Director
    Iddesleigh
    EX19 8BE Winkleigh
    Devon Lodge
    Devon
    England
    United KingdomBritish129983290001
    LEATHER, Jonathan Terence
    57 The Crofts
    Hatch Warren
    RG22 4RE Basingstoke
    Hampshire
    Secretario
    57 The Crofts
    Hatch Warren
    RG22 4RE Basingstoke
    Hampshire
    British69140360001
    SCOTT, Elizabeth Mary
    8 Belvidere Road
    WS1 3AU Walsall
    Secretario
    8 Belvidere Road
    WS1 3AU Walsall
    British76715280003
    SHOOLBRED, Charles Frederick
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    Secretario
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    British540290002
    BARCOSEC LIMITED
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Secretario corporativo
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    49004930001
    EVER 1993 LIMITED
    International Headquarters
    Longbridge
    B31 2TB Birmingham
    West Midlands
    Secretario corporativo
    International Headquarters
    Longbridge
    B31 2TB Birmingham
    West Midlands
    88822950001
    BEALE, Peter Robert
    Dunhampstead House
    Dunhampstead
    WR9 7JX Droitwich Spa
    West Midlands
    Director
    Dunhampstead House
    Dunhampstead
    WR9 7JX Droitwich Spa
    West Midlands
    United KingdomBritish25365060002
    BOOBYER, Christopher Leslie Richard
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Director
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    British92233050001
    BOX, Sarah
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    Director
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    British47381630004
    CALLENDER, John Dalrymple
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    Director
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    United KingdomBritish2444200001
    DOWDING, Eric Robert
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    Director
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    British46728970001
    LEATHER, Jonathan Terence
    47 Firecrest Road
    Kempshott
    RG22 5UL Basingstoke
    Hampshire
    Director
    47 Firecrest Road
    Kempshott
    RG22 5UL Basingstoke
    Hampshire
    British69140360002
    MCCORMICK, Kevin
    7 Laidlaw Close
    Talbot Village Wallisdown
    BH12 5EW Poole
    Dorset
    Director
    7 Laidlaw Close
    Talbot Village Wallisdown
    BH12 5EW Poole
    Dorset
    British14860030001
    MCMILLAN, Richard John
    17 Hawthorn Close
    Colden Common
    SO21 1UX Winchester
    Hampshire
    Director
    17 Hawthorn Close
    Colden Common
    SO21 1UX Winchester
    Hampshire
    British68601920001
    PATTERSON, Mark Allan
    6 Vespasian Gardens
    RG24 9SH Basingstoke
    Hampshire
    Director
    6 Vespasian Gardens
    RG24 9SH Basingstoke
    Hampshire
    British71785630001
    ROWAN, Charles Paul
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    Director
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    British49237910001
    ROWBERRY, Duncan John
    2 Morris Rise
    Chineham
    RG24 8LD Basingstoke
    Hampshire
    Director
    2 Morris Rise
    Chineham
    RG24 8LD Basingstoke
    Hampshire
    British49237880002
    RUSTON, Jane Elizabeth
    4 Mainwaring Road
    Over Peover
    WA16 8TR Knutsford
    Cheshire
    Director
    4 Mainwaring Road
    Over Peover
    WA16 8TR Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish70986180008
    SHAW, Robert Michael
    11 Westminster Road
    Branksome Park
    BH13 6JQ Poole
    Dorset
    Director
    11 Westminster Road
    Branksome Park
    BH13 6JQ Poole
    Dorset
    EnglandBritish6887610001
    VAUGHAN, Phil
    Lexington
    Wyche Lane
    CW6 9PD Bunbury
    Cheshire
    Director
    Lexington
    Wyche Lane
    CW6 9PD Bunbury
    Cheshire
    British35020290001
    WATSON, Hazel Anne Marie
    6 Abbotsmead Place
    Caversham
    RG4 8BB Reading
    Reading
    Director
    6 Abbotsmead Place
    Caversham
    RG4 8BB Reading
    Reading
    British71785600001
    WEAL, Barry
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    Director
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    British40203100001
    WEAVING, John Martin
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    Director
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    British58523120001
    BARCOSEC LIMITED
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Director corporativo
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    49004930001
    BAROMETERS LIMITED
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Director corporativo
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    57357300002

    ¿Tiene PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Aircraft mortgage
    Creado el 01 abr 2003
    Entregado el 15 may 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    With full title guarantee all its interest, present and future, in and to: the aircraft and all technical records, together the mortgaged property;. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transacciones
    • 15 may 2003Registro de un cargo (395)
    • 14 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment of payments due under the group relief deed and certain payments of corporation tax
    Creado el 01 abr 2003
    Entregado el 11 abr 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The assigned barclays property. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (Acting for Itself and as Agent for Members of the Barclays Group) Andthomson Travel International Ag and Tui Northern Europe Limited
    Transacciones
    • 11 abr 2003Registro de un cargo (395)
    Fee account charge
    Creado el 01 abr 2003
    Entregado el 11 abr 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies liabilities and obligations due or to become due from the company (formerly known as mercantile leasing company (no.162) limited to the chargee (as security trustee for the secured parties) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All its right title and interest in and to the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 11 abr 2003Registro de un cargo (395)
    Assignment of insurances
    Creado el 01 abr 2003
    Entregado el 09 abr 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The assigned property absolutely by way of security. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transacciones
    • 09 abr 2003Registro de un cargo (395)
    • 14 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security assignment
    Creado el 01 abr 2003
    Entregado el 09 abr 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All its rights, title and interest, present and future, in and to, or arising under or in respect of the assigned documents and all moneys whatsoever payable to the owner thereunder, including all claims for damages and compensation in respect of any breach thereof.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transacciones
    • 09 abr 2003Registro de un cargo (395)
    Account charge
    Creado el 01 abr 2003
    Entregado el 09 abr 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All its right title and interest in and to the deposit and all and any rights and benefits accruing to or arising in connection therewith.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 09 abr 2003Registro de un cargo (395)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0