LGL 1996 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaLGL 1996 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03034136
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de LGL 1996 LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra LGL 1996 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Lumns Lane
    M27 8LN Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LGL 1996 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    LUXFER GROUP 1996 LIMITED03 jul 200003 jul 2000
    LUXFER GROUP LIMITED03 oct 199703 oct 1997
    BRITISH ALUMINIUM HOLDINGS LIMITED04 dic 199504 dic 1995
    DMWSL 159 LIMITED16 mar 199516 mar 1995

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de LGL 1996 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para LGL 1996 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Memorándum y Estatutos

    25 páginasMA

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Domicilio social registrado cambiado de Anchorage Gateway 5 Anchorage Quay Salford M50 3XE a Lumns Lane Manchester M27 8LN el 19 mar 2018

    2 páginasAD01

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 22 feb 2018

    • Capital: GBP 0.01
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Nombramiento de Mr Jamie Mark Savage como secretario el 01 ene 2018

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de David Nicholas Fletcher como secretario el 01 ene 2018

    1 páginasTM02

    Cambio de datos del secretario David Nicholas Fletcher el 15 dic 2017

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mr Brian Gordon Purves el 15 dic 2017

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 30 sept 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    4 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 30 sept 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    5 páginasAA

    Nombramiento de David Nicholas Fletcher como secretario el 04 mar 2016

    3 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Linda Frances Seddon como secretario el 04 mar 2016

    2 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 30 sept 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital26 oct 2015

    Estado de capital el 26 oct 2015

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 30 sept 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital17 oct 2014

    Estado de capital el 17 oct 2014

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    4 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de LGL 1996 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SAVAGE, Jamie Mark
    Lumns Lane
    M27 8LN Manchester
    Secretario
    Lumns Lane
    M27 8LN Manchester
    241848520001
    PURVES, Brian Gordon
    Lumns Lane
    M27 8LN Manchester
    Director
    Lumns Lane
    M27 8LN Manchester
    EnglandBritish47456240002
    BURNS, Richard
    Scalebor House
    Moor Lane
    LS29 7AF Burley In Wharfedale
    Secretario
    Scalebor House
    Moor Lane
    LS29 7AF Burley In Wharfedale
    British60673970003
    DEMBLOWSKI, Denis Anthony
    15 Chemin De La Rochette
    FOREIGN Geneva
    1202
    Switzerland
    Secretario
    15 Chemin De La Rochette
    FOREIGN Geneva
    1202
    Switzerland
    American82569240001
    FLETCHER, David Nicholas
    5 Anchorage Quay
    M50 3XE Salford
    Anchorage Gateway
    Secretario
    5 Anchorage Quay
    M50 3XE Salford
    Anchorage Gateway
    206178230001
    SEDDON, Linda Frances
    Le Petit Bois 12 Park Drive
    Hale
    WA15 9DH Altrincham
    Cheshire
    Secretario
    Le Petit Bois 12 Park Drive
    Hale
    WA15 9DH Altrincham
    Cheshire
    British14578300002
    SEDDON, Linda Frances
    Le Petit Bois 12 Park Drive
    Hale
    WA15 9DH Altrincham
    Cheshire
    Secretario
    Le Petit Bois 12 Park Drive
    Hale
    WA15 9DH Altrincham
    Cheshire
    British14578300002
    DM COMPANY SERVICES LIMITED
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    Secretario designado corporativo
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    900000320001
    HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED
    15th Floor
    Moor House 119 London Wall
    EC2Y 5ET London
    Secretario corporativo
    15th Floor
    Moor House 119 London Wall
    EC2Y 5ET London
    67382580001
    BOYLE, Tobias Humphrey James
    67 Carlton Hill
    NW8 0EN London
    Director
    67 Carlton Hill
    NW8 0EN London
    EnglandBritish141831310001
    COMFORT, William Twyman
    Flat 1
    38 Pont Street
    SW1 London
    Director
    Flat 1
    38 Pont Street
    SW1 London
    British53760460001
    DEMBLOWSKI, Denis Anthony
    15 Chemin De La Rochette
    FOREIGN Geneva
    1202
    Switzerland
    Director
    15 Chemin De La Rochette
    FOREIGN Geneva
    1202
    Switzerland
    American82569240001
    FARGAS MAS, Lluis Maria
    Rue De Lausanne 62
    Morges
    Vaud 1110
    Switzerland
    Director
    Rue De Lausanne 62
    Morges
    Vaud 1110
    Switzerland
    SwitzerlandSpanish72852990001
    FAULL, Ian Trevor
    West Chalet Groves Avenue
    Langland
    SA3 4QF Swansea
    West Glamorgan
    Director
    West Chalet Groves Avenue
    Langland
    SA3 4QF Swansea
    West Glamorgan
    United KingdomBritish12734690001
    JACOB, Frances Carol
    11 Augustus Court
    Augustus Road Southfields
    SW19 6NA London
    Director
    11 Augustus Court
    Augustus Road Southfields
    SW19 6NA London
    British38154840001
    MACKENZIE, Alexander Donald
    Shalden Lodge
    Shalden Lane Shalden
    GU34 4DU Alton
    Hampshire
    Director
    Shalden Lodge
    Shalden Lane Shalden
    GU34 4DU Alton
    Hampshire
    United KingdomBritish105120270001
    MCKAY, Francis John
    Lodge Way House
    Lodge Way
    NN5 7UG Harlestone Road
    Northampton
    Director
    Lodge Way House
    Lodge Way
    NN5 7UG Harlestone Road
    Northampton
    British78787530001
    MCKINNON, Ian Bannochie
    219 Inner Promenade
    FY8 1EA Lytham St Annes
    Lancashire
    Director
    219 Inner Promenade
    FY8 1EA Lytham St Annes
    Lancashire
    EnglandBritish980160001
    MCKINNON, Ian Bannochie
    219 Inner Promenade
    FY8 1EA Lytham St Annes
    Lancashire
    Director
    219 Inner Promenade
    FY8 1EA Lytham St Annes
    Lancashire
    EnglandBritish980160001
    MITCHELL, Raymond Barnes
    Av De Florimont
    20 Bis 1006
    FOREIGN Lausanne
    Switzerland
    Director
    Av De Florimont
    20 Bis 1006
    FOREIGN Lausanne
    Switzerland
    American72854970001
    MURRAY, Norman Loch
    8 Pentland Avenue
    EH13 0HZ Edinburgh
    Director
    8 Pentland Avenue
    EH13 0HZ Edinburgh
    ScotlandBritish22920002
    MURRAY, Norman Loch
    8 Pentland Avenue
    EH13 0HZ Edinburgh
    Director
    8 Pentland Avenue
    EH13 0HZ Edinburgh
    ScotlandBritish22920002
    PURVES, Brian Gordon
    72a Macclesfield Road
    SK10 4BH Prestbury
    Cheshire
    Director
    72a Macclesfield Road
    SK10 4BH Prestbury
    Cheshire
    EnglandBritish47456240002
    WHALLEY, Jeffrey
    Broncroft Castle
    Broncroft
    SY7 9HL Craven Arms
    Shropshire
    Director
    Broncroft Castle
    Broncroft
    SY7 9HL Craven Arms
    Shropshire
    United KingdomBritish1955430002
    25 NOMINEES LIMITED
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    Director corporativo
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    42409900001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de LGL 1996 LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    5, Anchorage Quay
    M50 3XE Salford
    Anchorage Gateway
    England
    06 abr 2016
    5, Anchorage Quay
    M50 3XE Salford
    Anchorage Gateway
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroEngland & Wales
    Autoridad legalUk Companies Act
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro3944037
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene LGL 1996 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Mortgage of shares
    Creado el 09 abr 1999
    Entregado el 28 abr 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All indebtedness and liabilities of any nature of each charging company (as defined) to the chargee (as security agent and trustee for itself and the other senior finance parties) and/or any of the senior finance parties (as defined) and/or any receiver under or in connection with the senior finance documents (as defined) including without limitation,under any amendments,supplements,or restatements of any of the senior finance documents including any containing provision for new or further advances)
    Breve descripción
    Ordinary shares of 1 irish pound each in luxfer overseas holding limited and luxfer group limited all other securities rights and monies including without limitation dividends please refer to form 395 for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 28 abr 1999Registro de un cargo (395)
    • 23 dic 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 09 abr 1999
    Entregado el 27 abr 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All indebtedness and other liabilities of any nature of each charging company (as defined) to the chargee in it's capacity as security agent for itself and the other senior finance parties (as defined) and/or any of the senior finance parties and/or any receiver under or in connection with the senior finance documents (as defined) (including without limitation, under any amendments, supplements or restatements of any of the senior finance documents including any containing provision for new or further advances)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 27 abr 1999Registro de un cargo (395)
    • 09 ago 2000Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 23 dic 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture subject to and with the benefit of the intercreditor agreement
    Creado el 09 feb 1996
    Entregado el 14 feb 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors (or any of them) to the chargee under the finance documents (or any of them)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Agent and Trustee for Itself and the Other Beneficiaries
    Transacciones
    • 14 feb 1996Registro de un cargo (395)
    • 01 ago 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0