DILLONS UK LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaDILLONS UK LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03040465
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de DILLONS UK LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra DILLONS UK LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Windsor House
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de DILLONS UK LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta28 abr 2012

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para DILLONS UK LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para DILLONS UK LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Finalización de la liquidación

    1 páginasL64.07

    Orden del tribunal para liquidar

    2 páginasCOCOMP

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cese del nombramiento de Ian Kenyon como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Trevor Moore como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Elaine Marriner como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Elaine Marriner como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Ian Peter Kenyon como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Trevor Philip Moore como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Simon Fox como director

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 abr 2012

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 mar 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 abr 2012

    Estado de capital el 02 abr 2012

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Domicilio social registrado cambiado de * Shelley House 2-4 York Road Maidenhead Berkshire SL6 1SR* el 13 mar 2012

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2011

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 mar 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 24 abr 2010

    3 páginasAA

    Cambio de datos del director Elaine Marriner el 21 abr 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Simon Richard Fox el 21 abr 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Elaine Marriner el 21 abr 2010

    1 páginasCH03

    Déclaration annuelle établie au 31 mar 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Gerald Johnson como director

    1 páginasTM01

    Resoluciones

    Resolutions
    13 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum de Asociación

    RES01

    Declaración de los objetos de la sociedad

    2 páginasCC04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 25 abr 2009

    3 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de DILLONS UK LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BRIGHT, Neil Irvine
    Pound End
    Cedar Drive, Cookham
    SL6 9DZ Maidenhead
    Berkshire
    Secretario
    Pound End
    Cedar Drive, Cookham
    SL6 9DZ Maidenhead
    Berkshire
    British180993450001
    CAMPBELL, Laurence James
    Mellbreak Dell Grove
    Frimley
    GU16 5PZ Camberley
    Surrey
    Secretario
    Mellbreak Dell Grove
    Frimley
    GU16 5PZ Camberley
    Surrey
    British27960300001
    HOWELL, Peter Graham
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    Secretario
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    British62634010001
    LYMATH, Michael Gerald
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    Secretario
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    British76768320001
    MARRINER, Elaine
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secretario
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British40470020001
    SMITH, George Marsden
    18 Bevin Square
    SW17 7BB London
    Secretario
    18 Bevin Square
    SW17 7BB London
    British15729150003
    TOMBLIN, Denise Lynne
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Secretario
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    British63502600001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    Secretario corporativo
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    39182980001
    BELL, Duncan Charles
    Longwood
    Queen Annes Road
    SL4 2BJ Windsor
    Berkshire
    Director
    Longwood
    Queen Annes Road
    SL4 2BJ Windsor
    Berkshire
    British9950440002
    CALDWELL, Findlay Martin
    Heronswood Ford Lane
    Langley
    CV37 0HN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Director
    Heronswood Ford Lane
    Langley
    CV37 0HN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    GbBritish50777030001
    FADIL, Susan Carol
    Shemer Ash Road
    Hawley
    DA2 7SB Dartford
    Kent
    Director designado
    Shemer Ash Road
    Hawley
    DA2 7SB Dartford
    Kent
    British900006600001
    FOX, Simon Richard
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish58101280002
    GILES, Alan James
    Tanglewood
    Crowsley Road
    RG9 3LE Shiplake
    Oxfordshire
    Director
    Tanglewood
    Crowsley Road
    RG9 3LE Shiplake
    Oxfordshire
    EnglandBritish156046020001
    GUMMERS, Eric Michael
    9 Vincent Square Mansions
    Walcott Street
    SW1P 2NT London
    Director designado
    9 Vincent Square Mansions
    Walcott Street
    SW1P 2NT London
    British900006590001
    HARRIS, Maxine
    Falcon House
    Hellidon Road
    CV47 7RN Priors Marston
    Warwickshire
    Director
    Falcon House
    Hellidon Road
    CV47 7RN Priors Marston
    Warwickshire
    British86121990001
    HOOD, John
    Briarwood
    15 Twatling Road Barnt Green
    B45 8HX Birmingham
    West Midlands
    Director
    Briarwood
    15 Twatling Road Barnt Green
    B45 8HX Birmingham
    West Midlands
    British39644740001
    HOWELL, Peter Graham
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    Director
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    UkBritish62634010001
    JOHNSON, Gerald Thomas
    Manor Farm House
    Oddington
    OX5 2RA Kidlington
    Oxfordshire
    Director
    Manor Farm House
    Oddington
    OX5 2RA Kidlington
    Oxfordshire
    EnglandBritish145115810001
    KENYON, Ian Peter
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish107735600001
    LANDERS, Brian James
    Briarbank House
    12a Childs Hill Road
    KT23 3QG Bookham Leatherhead
    Surrey
    Director
    Briarbank House
    12a Childs Hill Road
    KT23 3QG Bookham Leatherhead
    Surrey
    United KingdomBritish90246320001
    LYMATH, Michael Gerald
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    Director
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    EnglandBritish76768320001
    MARRINER, Elaine
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish40470020001
    MCALLISTER, Stuart
    The Granary 38 Wellington Street
    OX9 3BN Thame
    Oxfordshire
    Director
    The Granary 38 Wellington Street
    OX9 3BN Thame
    Oxfordshire
    British9406880001
    MCGLOIN, Brian Joseph Patrick
    72 Northumberland Road
    EN5 1EE Barnet
    Hertfordshire
    Director
    72 Northumberland Road
    EN5 1EE Barnet
    Hertfordshire
    British51112090001
    MCLAUGHLIN, Brian Finbar
    Pangbourne Lodge
    Tidmarsh Road
    RG8 7AZ Pangbourne
    Berkshire
    Director
    Pangbourne Lodge
    Tidmarsh Road
    RG8 7AZ Pangbourne
    Berkshire
    United KingdomBritish9950470002
    MOORE, Trevor Philip
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish113047410001
    ROGULSKA, Franca, Ms.
    Arcadia 5 Cornwall Close
    Warfield
    RG42 3UH Bracknell
    Berkshire
    Director
    Arcadia 5 Cornwall Close
    Warfield
    RG42 3UH Bracknell
    Berkshire
    EnglandBritish113630630002
    SINYOR, Joe
    5 Cotman Close
    NW11 6QD London
    Director
    5 Cotman Close
    NW11 6QD London
    British61172920002
    TOMBLIN, Denise Lynne
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Director
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish63502600001
    WARNOCK, Shaw William
    3rd Floor
    58 Kensington Gardens Square
    W2 4BA London
    Director
    3rd Floor
    58 Kensington Gardens Square
    W2 4BA London
    EnglandBritish143882000001
    WOOD, Fiona Anne Murray
    27 Roehampton Lane
    SW15 5LS London
    Director
    27 Roehampton Lane
    SW15 5LS London
    EnglandBritish47935020001
    WORRALL, Brian George
    Apple House
    11a Sedgewell Road
    RG4 9TA Sonning Common
    Berkshire
    Director
    Apple House
    11a Sedgewell Road
    RG4 9TA Sonning Common
    Berkshire
    United KingdomBritish107708510001

    ¿Tiene DILLONS UK LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 22 may 1998
    Entregado el 04 jun 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the high yield documents (as defined) and this debenture
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Chase Manhattan Bank,as Security Trustee
    Transacciones
    • 04 jun 1998Registro de un cargo (395)
    • 11 may 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Amendment deed (to a debenture dated 28TH march 1998 as amended and restated on 14TH may 1998 the "amended and restated debenture")
    Creado el 22 may 1998
    Entregado el 03 jun 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee (the security agent) (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the finance documents (including the amended and restated debenture)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over all undertaking property and assets including all buildings fixtures book debts plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Emi Group PLC (As Security Agent for Itself and Emi Group Finance PLC)
    Transacciones
    • 03 jun 1998Registro de un cargo (395)
    • 11 may 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Amendment and restatement deed (to a debenture incorporating fixed and floating charges dated 28TH march 1998)
    Creado el 14 may 1998
    Entregado el 15 may 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as security agent for itself and emi group finance PLC) under or pursuant to the finance documents (including the amended and restated debenture)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over all undertaking property and assets present and future including all buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Emi Group PLC (As Security Agent for Itself and Emi Group Finance PLC)
    Transacciones
    • 15 may 1998Registro de un cargo (395)
    • 11 may 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 28 mar 1998
    Entregado el 09 abr 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents and this charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Emi Group PLC (As Security Agent for Itself and Emi Group Finance PLC)
    Transacciones
    • 09 abr 1998Registro de un cargo (395)
    • 11 may 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 28 mar 1998
    Entregado el 09 abr 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    In favour of swiss bank corporation as "security agent", which expression shall include any person for the time being appointed as security trustee or as an additional trustee for the purpose of, and in accordance with, the senior facility agreement, the company shall discharge each and every liability which the company may now or hereafter have to the security agent (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the senior facility agreement (including the debenture) including any liability in respect of any further advances made thereunder and pay to the security agent when due and payable every sum (of principal, intererst or otherwise) now or hereafter owing, due or incurred by the company to the security agent (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries in respect of any such liabilities
    Breve descripción
    By way of fixed charge (I) principal property owned by it at the date of this debenture other than (a) any heritable or leasehold property in scotland and all buildings trade and other fixtures fixed plant machinery installations and apparatus from time to time on any such property in scotland and (b) any principal property in northern ireland.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Swiss Bank Corporation as "Security Agent"Which Expression Shall Include Any Person for the Time Being Appointed as Security Trustee or as an Additional Trustee for the Purpose of, and in Accordance with, the Senior Facility Agreement
    Transacciones
    • 09 abr 1998Registro de un cargo (395)
    • 11 may 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene DILLONS UK LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    19 jul 2013Fecha de la petición
    02 sept 2013Inicio de la liquidación
    30 abr 2014Conclusión de la liquidación
    13 ago 2014Fecha de disolución
    Liquidación forzosa
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    The Official Receiver Or St Albans
    1st Floor
    Trident House
    AL1 3HR 42-48 Victoria Street
    St Albans
    Profesional
    1st Floor
    Trident House
    AL1 3HR 42-48 Victoria Street
    St Albans

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0