GRIPPERRODS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | GRIPPERRODS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03041925 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GRIPPERRODS LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra GRIPPERRODS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Pearl Assurance House 319 Ballards Lane N12 8LY London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GRIPPERRODS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ARLESHAW LIMITED | 04 abr 1995 | 04 abr 1995 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GRIPPERRODS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2011 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para GRIPPERRODS LIMITED?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GRIPPERRODS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 8 páginas | 4.71 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 15 ago 2015 | 8 páginas | 4.68 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 15 ago 2014 | 8 páginas | 4.68 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * Pinnacle House First Floor 17-25 Hartfield Road Wimbledon London SW19 3SE United Kingdom* el 30 ago 2013 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 3 páginas | 4.70 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 dic 2012 avec liste complète des actionnaires | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de los objetos de la sociedad | 21 páginas | CC04 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 23 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 dic 2011 avec liste complète des actionnaires | 9 páginas | AR01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Hopster como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Elizabeth Honor Lewzey como secretario | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael John Hopster como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cambio de datos del director Elizabeth Honor Lewzey el 04 jul 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Nicolas Paul Wilkinson como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Thomas C. Reeve como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Elizabeth Honor Lewzey como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Flanagan como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * East Putney House 84 Upper Richmond Road London SW15 2ST* el 07 jul 2011 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Denise Burton como director | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Michael John Hopster como secretario | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de GRIPPERRODS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEWZEY, Elizabeth Honor | Secretario | First Floor 17-25 Hartfield Road SW19 3SE Wimbledon Pinnacle House London United Kingdom | 165833030001 | |||||||
| LEWZEY, Elizabeth Honor | Director | First Floor 17-25 Hartfield Road SW19 3SE Wimbledon Pinnacle House London United Kingdom | England | British | 59381700003 | |||||
| REEVE, Thomas C. | Director | Wewatta Street 80202 Denver 1551 Colorado Usa | United States | American | 161822390001 | |||||
| WILKINSON, Nicolas Paul | Director | First Floor 17-25 Hartfield Road SW19 3SE Wimbledon Pinnacle House London United Kingdom | England | British | 48808690001 | |||||
| BURTON, Denise Patricia | Secretario | Warren Close Coombe Hill Road KT2 7DY Kingston Upon Thames Surrey | British | 47432570004 | ||||||
| HOPSTER, Michael John | Secretario | 40 Brooksbys Walk E9 6DF London Flat B United Kingdom | 157103010001 | |||||||
| LAU, Cheong Koon | Secretario | 40 Strongbow Road Eltham SE9 1DT London | Malaysian | 16337610001 | ||||||
| PAUL, Simon George | Secretario | Spinney Cottage Station Road CV13 0NP Market Bosworth Warwickshire | British | 154423590001 | ||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario designado corporativo | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||
| BURTON, Denise Patricia | Director | Warren Close Coombe Hill Road KT2 7DY Kingston Upon Thames Surrey | United Kingdom | British | 47432570004 | |||||
| DUNCAN, Ian Alexander | Director | Durham House Durham Place SW3 4ET London | United Kingdom | British | 27300002 | |||||
| FARRELL, William Michael | Director | 7 Craigvale Court DG1 4QH Dumfries | British | 62063670001 | ||||||
| FLANAGAN, Paul Edward | Director | Flat 9 19 Holland Park W11 3TD London | United Kingdom | British | 69281780002 | |||||
| HAZARD, George Anthony | Director | 46 Broad Oaks Road B91 1JB Solihull West Midlands | British | 6369950001 | ||||||
| HOPSTER, Michael John | Director | Flat B 40 Brooksbys Walk E9 6DF London | United Kingdom | British | 77921850004 | |||||
| HOUGHTON, Paul David | Director | 2 Mayfield Court Formby L37 7JL Liverpool Merseyside | British | 95097460001 | ||||||
| JACKSON, Pearse | Director | 3 Woodside Parkgate DG1 3LY Dumfries | Irish | 61362400001 | ||||||
| LEES, Peter Bryce | Director | 6 Jerviswood ML1 4AJ Motherwell Lanarkshire | British | 26615220001 | ||||||
| MARCHANT, Richard Norman | Director | 60 The Mount Curdworth B76 9HR Sutton Coldfield West Midlands | British | 26880001 | ||||||
| MOULDS, Peter John | Director | 2 Millside Slitting Mill WS15 2FG Rugeley Staffordshire | British | 31029500002 | ||||||
| OWEN, David Evan Penrhyn | Director | The Old Barn Church Lane S81 9EH Carlton In Lindrick Nottinghamshire | British | 73849580001 | ||||||
| PAUL, Simon George | Director | Spinney Cottage Station Road CV13 0NP Market Bosworth Warwickshire | England | British | 154423590001 | |||||
| PERSSON, Jan Allan | Director | 3 Wayside SW14 7LN London | Swedish | 6650000001 | ||||||
| PORTER, Norman Charles | Director | Farnham House 2 Beedingwood Drive Forest Road Colgate RH12 4TE Horsham West Sussex | England | British | 445360034 | |||||
| ROBB, Kenneth | Director | 2 Glentruim View KA2 0LL Kilmarnock Ayrshire | British | 61362350001 | ||||||
| SACK, Adam David | Director | 115 Broadhurst Gardens NW6 3BJ London | British | 32459700002 | ||||||
| STANSFIELD, Neil Andrew | Director | The Laurels, Poets Way Newnham NN11 3HQ Daventry Northamptonshire | British | 79347560001 | ||||||
| WIEGMAN, Albert Edward Bernard | Director | 17 Hills Avenue CB1 7UY Cambridge | British | 7466220002 | ||||||
| COMBINED NOMINEES LIMITED | Director designado corporativo | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NA London | 900000090001 | |||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Director designado corporativo | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 |
¿Tiene GRIPPERRODS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Charge over credit balances | Creado el 24 abr 1998 Entregado el 07 may 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The sum of £33,000 together with interest accrued now or to be held by national westmister bank PLC on an account numbered 94897077 and earmarked or designated by reference to the company. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage debenture | Creado el 13 ene 1998 Entregado el 21 ene 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under this mortgage debenture or in connection with a counter indemnity of even date | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge over credit balances | Creado el 10 nov 1997 Entregado el 24 nov 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The sum of £41,300 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 94897077 and earmarked or designated by reference to the company. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Fixed charge on discounted debts and a floating charge on the receipts of other debts | Creado el 23 oct 1997 Entregado el 30 oct 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under an invoice discounting agreement (as therein defined) or otherwise | |
Breve descripción Fixed equitable charge (I) all debts the subject of an invoice discounting agreement between the company and the chargee that fail to vest in the chargee and all rights in favour of the company related to such debts and (ii) all other amounts owing and all rights relating to such amounts, floating charge such of the moneys received in respect of amounts referred to in (ii) above as shall stand released from the fixed equitable charge. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Chattels mortgage | Creado el 05 jun 1995 Entregado el 17 jun 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company (formerly known as arleshaw limited) to the chargee under the terms of a credit sale agreement dated 12TH september 1991 and a novation agreement dated 5TH june 1995 | |
Breve descripción The sponge rubber underlay production line situated at the company's premises at walkmill lane, cannock, staffordshire. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 05 jun 1995 Entregado el 15 jun 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company (formerly known as arleshaw limited) to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Factory warehouse and office premises forming part of the industrial estate at walkmill lane cannock staffordshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene GRIPPERRODS LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0