INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03045060 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED?
- Otras industrias manufactureras n.c.p. (32990) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED?
| Dirección de la sede social | 1 Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood Lancashire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP PLC | 06 abr 1995 | 06 abr 1995 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 abr 2015 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Steve Quinlan como director el 26 ago 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 28 sept 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de James Lamar Herbert como director el 26 ago 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Gareth Smith como director el 26 ago 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Gareth Smith como director el 26 ago 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ian Leslie Morris como director el 26 ago 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Colin Goodwille como director el 26 ago 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Maclaren Cassells como director el 26 ago 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Gareth Smith como secretario el 26 ago 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Stephen Jeffrey Irwin Holmes como director el 26 ago 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 5 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2015 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2014 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 28 sept 2014 avec liste complète des actionnaires | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Colin Goodwille el 23 oct 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Ian Leslie Morris como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Paul Gareth Smith como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 abr 2013 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Paul Gareth Smith como secretario | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Sullivan como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 28 sept 2013 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 abr 2012 | 4 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERBERT, James Lamar | Director | Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood 1 Lancashire | United States | American | 200649010001 | |||||
| HOLMES, Stephen Jeffrey Irwin, Dr | Director | Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood 1 Lancashire | United Kingdom | British | 200627160001 | |||||
| QUINLAN, Steve | Director | Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood 1 Lancashire | Usa | American | 203115340001 | |||||
| BAKER, Edward Matthew Scott | Secretario | 2 Homelands Close Sale M33 4EB Manchester | British | 4668730002 | ||||||
| BROWN, Michael Stewart | Secretario | Flat 6 Derwent Park House New Road DE22 1DR Derby | British | 86327240001 | ||||||
| COTTON, Angela | Secretario | 3 Ravens Holme BL1 5TN Bolton Greater Mancheseter | British | 62018140001 | ||||||
| DUNBAR, Stephen John | Secretario | 43 Cotswold Drive Horwich BL6 7DE Bolton Lancashire | British | 46237640003 | ||||||
| JAMES, Richard David | Secretario | 19 Mill Close WA2 0ST Warrington Cheshire | British | 80458850001 | ||||||
| RAPSON, Bernard David | Secretario | Bank Cottage Old Forge Lane Preston Capes NN11 3TD Daventry Northamptonshire | British | 3213310001 | ||||||
| SMITH, Paul Gareth | Secretario | Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood 1 Lancashire England | 184029570001 | |||||||
| SULLIVAN, Mark James | Secretario | 2 Grange Barn Malt Kiln Lane Bispham L40 3SH Ormskirk Lancashire | British | 101060960001 | ||||||
| A B & C SECRETARIAL LIMITED | Secretario designado corporativo | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 900006570001 | |||||||
| BONDSWELL, Andrew | Director | 19 Brier Hill View HD2 1JQ Huddersfield West Yorkshire | British | 62729310001 | ||||||
| BOWHILL, Keith Nicholas | Director | Woodside Sandy Lane Rushmoor GU10 2ET Farnham Surrey | British | 61679460002 | ||||||
| CASSELLS, John Maclaren, Dr | Director | Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood 1 Lancashire England | England | British | 63881080001 | |||||
| DAWE, Peter John | Director | The Manor House 71 High Street Oakington CB4 5AG Cambridge | British | 48967260001 | ||||||
| EDGE, Christopher Thomas | Director | Fife House 30a Fife Road East Sheen SW14 7EL London | England | British | 11465390002 | |||||
| EDWARDS, Stephen Peter | Director | The Grange Lamberhurst Quarter TN3 8AN Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | 147275950001 | |||||
| GOODWILLE, Colin | Director | Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood 1 Lancashire England | England | British | 3856830002 | |||||
| GOODWILLE, Fiona Ford | Director | The Old Rectory Church Lane CB3 8QN Papworth Everard Cambridge | British | 20914960001 | ||||||
| GUNLACK, Robert Henry | Director | Treviades Barton High Cross Constantine TR11 5RG Falmouth Cornwall | England | British | 27971040006 | |||||
| HILLARY, Alan | Director | 1 Cameron Close GU6 8EB Cranleigh Surrey | United Kingdom | British | 13184060001 | |||||
| HOLMES, Andrew Peter Geoffrey | Director | 51 Doneraile Street SW6 6EW London | England | British | 21151650001 | |||||
| MORRIS, Ian Leslie | Director | Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood 1 Lancashire England | United Kingdom | British | 138377860001 | |||||
| PRIMROSE, Sandy Blackadder, Doctor | Director | Amersham Road HP13 6QS High Wycombe 21 Buckinghamshire | England | British | 17972160001 | |||||
| RAPSON, Bernard David | Director | Bank Cottage Old Forge Lane Preston Capes NN11 3TD Daventry Northamptonshire | England | British | 3213310001 | |||||
| SMITH, Paul Gareth | Director | Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood 1 Lancashire England | England | British | 187422070001 | |||||
| SMITH, Peter James | Director | 19 Coolidge Avenue LA1 5ER Lancaster | British | 37288990001 | ||||||
| STANLEY, Christopher John, Dr | Director | Harradine House Church Street Woodhurst PE28 3BN Huntingdon Cambridgeshire | British | 45065760002 | ||||||
| STEWART, James Alexander | Director | 9 Jameson Street W8 7SH London | British | 13771800001 | ||||||
| SYMS, Allan, Dr | Director | Customs House Place Penarth Marina CF64 1TP Vale Of Glamorgan 12 Cariff | British | 128513480001 | ||||||
| THOMAS, Howard | Director | Wooton Court St Neots Road St Neots Road PE19 4UU Abbotsley Cambridgeshire | United Kingdom | British | 18174450001 | |||||
| WALPOLE, Malcolm William | Director | 28 Higher Mead RG24 8YL Old Basing Hampshire | British | 107822300001 | ||||||
| A B & C SECRETARIAL LIMITED | Director corporativo | Dennis House Marsden Street M2 1JD Manchester | 38962110002 | |||||||
| INHOCO FORMATIONS LIMITED | Director designado corporativo | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 900006560001 |
¿Tiene INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 28 mar 2003 Entregado el 12 abr 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 24 ene 2002 Entregado el 30 ene 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the obligor to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripci ón A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 30 nov 1995 Entregado el 02 dic 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or by the companies hereinafter defined ("the customer") and all monies agreed to be paid by the company in accordance with the provisions of any guarantee or guarantees given by the company to the yorkshire bank public limited company in respect of the indebtedness and liability of the customer or any company or companies which may constitute a subsidiary or subsidiaries of the charging company or of any holding company or any (as therein defined) of the charging company or any company or companies which may be otherwise associated with the charging company in business | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 19 may 1995 Entregado el 23 may 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0