INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED

INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaINTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03045060
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED?

    • Otras industrias manufactureras n.c.p. (32990) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    Lancashire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP PLC06 abr 199506 abr 1995

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 abr 2015

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Nombramiento de Mr Steve Quinlan como director el 26 ago 2015

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 28 sept 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital20 oct 2015

    Estado de capital el 20 oct 2015

    • Capital: GBP 1,939,100.9
    SH01

    Nombramiento de James Lamar Herbert como director el 26 ago 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Paul Gareth Smith como director el 26 ago 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Paul Gareth Smith como director el 26 ago 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Ian Leslie Morris como director el 26 ago 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Colin Goodwille como director el 26 ago 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de John Maclaren Cassells como director el 26 ago 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Paul Gareth Smith como secretario el 26 ago 2015

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Stephen Jeffrey Irwin Holmes como director el 26 ago 2015

    2 páginasAP01

    Cancelación total de la carga 5

    1 páginasMR04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2015

    8 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2014

    8 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 28 sept 2014 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital23 oct 2014

    Estado de capital el 23 oct 2014

    • Capital: GBP 1,939,100.9
    SH01

    Cambio de datos del director Colin Goodwille el 23 oct 2014

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mr Ian Leslie Morris como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Paul Gareth Smith como director

    2 páginasAP01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 abr 2013

    4 páginasAA

    Nombramiento de Mr Paul Gareth Smith como secretario

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Mark Sullivan como secretario

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 28 sept 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 oct 2013

    Estado de capital el 02 oct 2013

    • Capital: GBP 1,939,100.9
    SH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 abr 2012

    4 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HERBERT, James Lamar
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    Director
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    United StatesAmerican200649010001
    HOLMES, Stephen Jeffrey Irwin, Dr
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    Director
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    United KingdomBritish200627160001
    QUINLAN, Steve
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    Director
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    UsaAmerican203115340001
    BAKER, Edward Matthew Scott
    2 Homelands Close
    Sale
    M33 4EB Manchester
    Secretario
    2 Homelands Close
    Sale
    M33 4EB Manchester
    British4668730002
    BROWN, Michael Stewart
    Flat 6 Derwent Park House
    New Road
    DE22 1DR Derby
    Secretario
    Flat 6 Derwent Park House
    New Road
    DE22 1DR Derby
    British86327240001
    COTTON, Angela
    3 Ravens Holme
    BL1 5TN Bolton
    Greater Mancheseter
    Secretario
    3 Ravens Holme
    BL1 5TN Bolton
    Greater Mancheseter
    British62018140001
    DUNBAR, Stephen John
    43 Cotswold Drive
    Horwich
    BL6 7DE Bolton
    Lancashire
    Secretario
    43 Cotswold Drive
    Horwich
    BL6 7DE Bolton
    Lancashire
    British46237640003
    JAMES, Richard David
    19 Mill Close
    WA2 0ST Warrington
    Cheshire
    Secretario
    19 Mill Close
    WA2 0ST Warrington
    Cheshire
    British80458850001
    RAPSON, Bernard David
    Bank Cottage Old Forge Lane
    Preston Capes
    NN11 3TD Daventry
    Northamptonshire
    Secretario
    Bank Cottage Old Forge Lane
    Preston Capes
    NN11 3TD Daventry
    Northamptonshire
    British3213310001
    SMITH, Paul Gareth
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    Secretario
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    184029570001
    SULLIVAN, Mark James
    2 Grange Barn
    Malt Kiln Lane Bispham
    L40 3SH Ormskirk
    Lancashire
    Secretario
    2 Grange Barn
    Malt Kiln Lane Bispham
    L40 3SH Ormskirk
    Lancashire
    British101060960001
    A B & C SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secretario designado corporativo
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006570001
    BONDSWELL, Andrew
    19 Brier Hill View
    HD2 1JQ Huddersfield
    West Yorkshire
    Director
    19 Brier Hill View
    HD2 1JQ Huddersfield
    West Yorkshire
    British62729310001
    BOWHILL, Keith Nicholas
    Woodside
    Sandy Lane Rushmoor
    GU10 2ET Farnham
    Surrey
    Director
    Woodside
    Sandy Lane Rushmoor
    GU10 2ET Farnham
    Surrey
    British61679460002
    CASSELLS, John Maclaren, Dr
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    Director
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    EnglandBritish63881080001
    DAWE, Peter John
    The Manor House 71 High Street
    Oakington
    CB4 5AG Cambridge
    Director
    The Manor House 71 High Street
    Oakington
    CB4 5AG Cambridge
    British48967260001
    EDGE, Christopher Thomas
    Fife House 30a Fife Road
    East Sheen
    SW14 7EL London
    Director
    Fife House 30a Fife Road
    East Sheen
    SW14 7EL London
    EnglandBritish11465390002
    EDWARDS, Stephen Peter
    The Grange
    Lamberhurst Quarter
    TN3 8AN Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    The Grange
    Lamberhurst Quarter
    TN3 8AN Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritish147275950001
    GOODWILLE, Colin
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    Director
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    EnglandBritish3856830002
    GOODWILLE, Fiona Ford
    The Old Rectory Church Lane
    CB3 8QN Papworth Everard
    Cambridge
    Director
    The Old Rectory Church Lane
    CB3 8QN Papworth Everard
    Cambridge
    British20914960001
    GUNLACK, Robert Henry
    Treviades Barton
    High Cross Constantine
    TR11 5RG Falmouth
    Cornwall
    Director
    Treviades Barton
    High Cross Constantine
    TR11 5RG Falmouth
    Cornwall
    EnglandBritish27971040006
    HILLARY, Alan
    1 Cameron Close
    GU6 8EB Cranleigh
    Surrey
    Director
    1 Cameron Close
    GU6 8EB Cranleigh
    Surrey
    United KingdomBritish13184060001
    HOLMES, Andrew Peter Geoffrey
    51 Doneraile Street
    SW6 6EW London
    Director
    51 Doneraile Street
    SW6 6EW London
    EnglandBritish21151650001
    MORRIS, Ian Leslie
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    Director
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    United KingdomBritish138377860001
    PRIMROSE, Sandy Blackadder, Doctor
    Amersham Road
    HP13 6QS High Wycombe
    21
    Buckinghamshire
    Director
    Amersham Road
    HP13 6QS High Wycombe
    21
    Buckinghamshire
    EnglandBritish17972160001
    RAPSON, Bernard David
    Bank Cottage Old Forge Lane
    Preston Capes
    NN11 3TD Daventry
    Northamptonshire
    Director
    Bank Cottage Old Forge Lane
    Preston Capes
    NN11 3TD Daventry
    Northamptonshire
    EnglandBritish3213310001
    SMITH, Paul Gareth
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    Director
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    EnglandBritish187422070001
    SMITH, Peter James
    19 Coolidge Avenue
    LA1 5ER Lancaster
    Director
    19 Coolidge Avenue
    LA1 5ER Lancaster
    British37288990001
    STANLEY, Christopher John, Dr
    Harradine House Church Street
    Woodhurst
    PE28 3BN Huntingdon
    Cambridgeshire
    Director
    Harradine House Church Street
    Woodhurst
    PE28 3BN Huntingdon
    Cambridgeshire
    British45065760002
    STEWART, James Alexander
    9 Jameson Street
    W8 7SH London
    Director
    9 Jameson Street
    W8 7SH London
    British13771800001
    SYMS, Allan, Dr
    Customs House Place
    Penarth Marina
    CF64 1TP Vale Of Glamorgan
    12
    Cariff
    Director
    Customs House Place
    Penarth Marina
    CF64 1TP Vale Of Glamorgan
    12
    Cariff
    British128513480001
    THOMAS, Howard
    Wooton Court St Neots Road
    St Neots Road
    PE19 4UU Abbotsley
    Cambridgeshire
    Director
    Wooton Court St Neots Road
    St Neots Road
    PE19 4UU Abbotsley
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish18174450001
    WALPOLE, Malcolm William
    28 Higher Mead
    RG24 8YL Old Basing
    Hampshire
    Director
    28 Higher Mead
    RG24 8YL Old Basing
    Hampshire
    British107822300001
    A B & C SECRETARIAL LIMITED
    Dennis House
    Marsden Street
    M2 1JD Manchester
    Director corporativo
    Dennis House
    Marsden Street
    M2 1JD Manchester
    38962110002
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Director designado corporativo
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001

    ¿Tiene INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 28 mar 2003
    Entregado el 12 abr 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 12 abr 2003Registro de un cargo (395)
    • 06 ago 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 24 ene 2002
    Entregado el 30 ene 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligor to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Quester Vct PLC (The 'Security Trustee')
    Transacciones
    • 30 ene 2002Registro de un cargo (395)
    • 02 feb 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 30 nov 1995
    Entregado el 02 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or by the companies hereinafter defined ("the customer") and all monies agreed to be paid by the company in accordance with the provisions of any guarantee or guarantees given by the company to the yorkshire bank public limited company in respect of the indebtedness and liability of the customer or any company or companies which may constitute a subsidiary or subsidiaries of the charging company or of any holding company or any (as therein defined) of the charging company or any company or companies which may be otherwise associated with the charging company in business
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Yorkshire Bank PLC
    Transacciones
    • 02 dic 1995Registro de un cargo (395)
    • 04 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 19 may 1995
    Entregado el 23 may 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 23 may 1995Registro de un cargo (395)
    • 30 ene 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0