PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED

PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED
    Estado de la empresaLiquidación
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03048528
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED?

    • (3410) /

    ¿Dónde se encuentra PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    800 Field End Road
    South Ruislip
    HA4 0QH Middlesex
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ASSETCO PAPWORTH LIMITED23 mar 200423 mar 2004
    ADVANCED TRANSPORT TECHNOLOGY LIMITED21 abr 199521 abr 1995

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 sept 2011
    Próximas cuentas vencen el30 jun 2012
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2010

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED?

    Vencido
    Última declaración de confirmación cerrada hasta21 abr 2017
    Próxima declaración de confirmación vence05 may 2017
    Vencido

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual
    Vencido

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    2 páginasF10.2

    Parte del bien o empresa ha sido liberada de la carga 9

    5 páginasMR05

    Parte del bien o empresa ha sido liberada de la carga 8

    5 páginasMR05

    Orden del tribunal para liquidar

    2 páginasCOCOMP

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cese del nombramiento de Mark Clissett como director

    1 páginasTM01

    Exercice comptable précédent prolongé du 31 mar 2011 au 30 sept 2011

    1 páginasAA01

    Cese del nombramiento de Philip Mcdaid como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 21 abr 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital11 oct 2011

    Estado de capital el 11 oct 2011

    • Capital: GBP 60,000
    SH01

    Nombramiento de Continental Shelf 548 Limited como director

    3 páginasAP02

    Nombramiento de Continental Shelf 547 Limited como director

    3 páginasAP02

    Cese del nombramiento de Scott Brown como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Philip Mcdaid como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Scott Brown como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Mark Anthony Clissett como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Marcus Shannon como director

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2010

    17 páginasAA

    Cese del nombramiento de Ricahrd Fulton como secretario

    2 páginasTM02

    Nombramiento de Scott Brown como secretario

    3 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Raymond Flynn como director

    2 páginasTM01

    Nombramiento de Scott Douglas Brown como director

    3 páginasAP01

    Nombramiento de Ricahrd Fulton como secretario

    3 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Michael Lavender como secretario

    2 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 21 abr 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    A deed of accession 09/02/2010
    RES13

    ¿Quiénes son los directivos de PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CONTINENTAL SHELF 547 LIMITED
    Field End Road
    HA4 0QH South Ruislip
    800
    Middlesex
    England
    Director corporativo
    Field End Road
    HA4 0QH South Ruislip
    800
    Middlesex
    England
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro7669797
    163247510001
    CONTINENTAL SHELF 548 LIMITED
    Field End Road
    HA4 0QH South Ruislip
    800
    Middlesex
    England
    Director corporativo
    Field End Road
    HA4 0QH South Ruislip
    800
    Middlesex
    England
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro7669811
    163247580001
    BROWN, Scott
    800 Field End Road
    South Ruislip
    HA4 0QH Middlesex
    Secretario
    800 Field End Road
    South Ruislip
    HA4 0QH Middlesex
    Australian154943660001
    FAIERS, Colin Charles
    4 Elm Way
    Willingham
    CB4 5JS Cambridge
    Canbridgeshire
    Secretario
    4 Elm Way
    Willingham
    CB4 5JS Cambridge
    Canbridgeshire
    British157295550001
    FULTON, Ricahrd
    Arthur Street
    BT1 4GA Belfast
    21
    Antrim
    Secretario
    Arthur Street
    BT1 4GA Belfast
    21
    Antrim
    British154196160001
    HENWOOD, Julian Richard
    8 Brickyard Close
    CV7 7EN Balsall Common
    Warwickshire
    Secretario
    8 Brickyard Close
    CV7 7EN Balsall Common
    Warwickshire
    British65188860002
    LAVENDER, Michael David
    Forty Hill House
    EN2 9EU Forty Hill
    Middlesex
    Secretario
    Forty Hill House
    EN2 9EU Forty Hill
    Middlesex
    British149181030001
    LEWIN, Peter Jonathan
    2 Cormont Road
    SE5 9RA London
    Secretario
    2 Cormont Road
    SE5 9RA London
    British45962560004
    MATTHEWS, Michael James
    11 Caxton Lane
    Foxton
    CB2 6SR Cambridge
    Cambridgeshire
    Secretario
    11 Caxton Lane
    Foxton
    CB2 6SR Cambridge
    Cambridgeshire
    British9389260001
    WATSON, Philip George
    29 Northcroft
    SG19 1JJ Sandy
    Bedfordshire
    Secretario
    29 Northcroft
    SG19 1JJ Sandy
    Bedfordshire
    British42944690001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secretario designado corporativo
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    SARCON COMPLIANCE LIMITED
    Murray House
    Murray Street
    BT1 6DN Belfast
    Antrim
    Secretario corporativo
    Murray House
    Murray Street
    BT1 6DN Belfast
    Antrim
    143646650001
    BROWN, Scott Douglas
    800 Field End Road
    South Ruislip
    HA4 0QH Middlesex
    Director
    800 Field End Road
    South Ruislip
    HA4 0QH Middlesex
    EnglandAustralian183542790001
    CLISSETT, Mark Anthony
    800 Field End Road
    South Ruislip
    HA4 0QH Middlesex
    Director
    800 Field End Road
    South Ruislip
    HA4 0QH Middlesex
    United KingdomBritish159159010001
    EDDY, Jonathan Charles Grenville
    Heath House
    Queen Mary Close
    GU51 4QR Fleet
    Hampshire
    Director
    Heath House
    Queen Mary Close
    GU51 4QR Fleet
    Hampshire
    British72062400003
    FAIERS, Colin Charles
    4 Elm Way
    Willingham
    CB4 5JS Cambridge
    Canbridgeshire
    Director
    4 Elm Way
    Willingham
    CB4 5JS Cambridge
    Canbridgeshire
    United KingdomBritish157295550001
    FLYNN, Raymond Francis
    66 Kiln Park
    BT39 0BB Templepatrick
    County Antrim
    Northern Ireland
    Director
    66 Kiln Park
    BT39 0BB Templepatrick
    County Antrim
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish119131330001
    HOUSDEN, Malcolm Brian
    16 The Woodlands
    Broom
    SG18 9NH Biggleswade
    Bedfordshire
    Director
    16 The Woodlands
    Broom
    SG18 9NH Biggleswade
    Bedfordshire
    British31969440001
    LEWIN, Peter Jonathan
    2 Cormont Road
    SE5 9RA London
    Director
    2 Cormont Road
    SE5 9RA London
    United KingdomBritish45962560004
    MCDAID, Philip
    Field End Road
    HA4 0QH South Ruislip
    800
    Middlesex
    United Kingdom
    Director
    Field End Road
    HA4 0QH South Ruislip
    800
    Middlesex
    United Kingdom
    United KingdomIrish161036530001
    MELLON, Denis
    19 Homewood Road
    AL1 4BG St Albans
    Hertfordshire
    Director
    19 Homewood Road
    AL1 4BG St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish105707560001
    OLIVE, Michael Pelham Morris, Mr.
    Church Farm House
    Lower Basildon
    RG8 9NH Pangbourne
    Berkshire
    Director
    Church Farm House
    Lower Basildon
    RG8 9NH Pangbourne
    Berkshire
    EnglandBritish36404130004
    REILLY, Paul
    Sonning Mead
    Thames Street
    RG4 6UR Sonning
    Berkshire
    Director
    Sonning Mead
    Thames Street
    RG4 6UR Sonning
    Berkshire
    United KingdomBritish67639350002
    SCOTT, George Douglas
    Hill Farm House
    Holywell
    PE27 4TG Huntingdon
    Cambridgeshire
    Director
    Hill Farm House
    Holywell
    PE27 4TG Huntingdon
    Cambridgeshire
    British76708940001
    SHANNON, Marcus John
    48 Loughanmore Road
    BT41 2HN Dunadry
    County Antrim
    N Ireland
    Director
    48 Loughanmore Road
    BT41 2HN Dunadry
    County Antrim
    N Ireland
    United KingdomBritish108366960001
    SMITH, David Michael
    9 Crowdon Drive
    CV32 6NX Royal Leamington Spa
    Warwickshire
    Director
    9 Crowdon Drive
    CV32 6NX Royal Leamington Spa
    Warwickshire
    British119131400001
    WATSON, Philip George
    29 Northcroft
    SG19 1JJ Sandy
    Bedfordshire
    Director
    29 Northcroft
    SG19 1JJ Sandy
    Bedfordshire
    British42944690001
    WESTBURY, Peter
    Somerset Hill
    Holmbury St Mary
    RH5 6NR Dorking
    Surrey
    Director
    Somerset Hill
    Holmbury St Mary
    RH5 6NR Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish2193910001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Director designado corporativo
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    ¿Tiene PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee & debenture
    Creado el 01 oct 2008
    Entregado el 16 oct 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 16 oct 2008Registro de un cargo (395)
    • 11 sept 2013Parte del bien o empresa ha sido liberada de la carga (MR05)
    Mortgage debenture
    Creado el 05 oct 2005
    Entregado el 12 oct 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from sarcon vehicles limited to the chargee
    Breve descripción
    The property k/a unit 1 papworth business park papworth everard cambridge & units 3/5 papworth business park papworth everard cambridge. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland (Ireland) Limited
    Transacciones
    • 12 oct 2005Registro de un cargo (395)
    • 11 sept 2013Parte del bien o empresa ha sido liberada de la carga (MR05)
    Mortgage deed
    Creado el 01 nov 2004
    Entregado el 03 nov 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a unit 5, papworth business park, cambridge. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 03 nov 2004Registro de un cargo (395)
    • 14 oct 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage deed
    Creado el 01 nov 2004
    Entregado el 03 nov 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a unit 3, papworth business park, cambridge. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 03 nov 2004Registro de un cargo (395)
    • 14 oct 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage deed
    Creado el 09 mar 2000
    Entregado el 11 mar 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The property being unit 3,papworth business park,cambridge.. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 11 mar 2000Registro de un cargo (395)
    • 21 may 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    All assets debenture
    Creado el 11 ago 1999
    Entregado el 14 ago 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 14 ago 1999Registro de un cargo (395)
    • 28 oct 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 07 jul 1999
    Entregado el 15 jul 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 15 jul 1999Registro de un cargo (395)
    • 14 oct 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 31 may 1995
    Entregado el 13 jun 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an acquisition agreement dated 10 may 1995 or this debenture
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Papworth Trust
    Transacciones
    • 13 jun 1995Registro de un cargo (395)
    • 08 jul 1998Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 01 jul 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 31 may 1995
    Entregado el 06 jun 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 06 jun 1995Registro de un cargo (395)
    • 20 ago 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    26 jun 2013Fecha de la petición
    19 ago 2013Inicio de la liquidación
    Liquidación forzosa
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Profesional
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0