KENSINGTON MORTGAGE COMPANY LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | KENSINGTON MORTGAGE COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03049877 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de KENSINGTON MORTGAGE COMPANY LIMITED?
- Actividades de las sociedades de financiación hipotecaria (64922) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra KENSINGTON MORTGAGE COMPANY LIMITED?
| Dirección de la sede social | Kensington Mortgage Company Ltd, 2nd Floor Marlow International Parkway SL7 1YL Marlow United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KENSINGTON MORTGAGE COMPANY LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| REGENT'S PARK MORTGAGE FUNDING LIMITED | 22 sept 1995 | 22 sept 1995 |
| NORLAND CAPITAL NO.4 LIMITED | 29 jun 1995 | 29 jun 1995 |
| WOLSINGLAWN LIMITED | 26 abr 1995 | 26 abr 1995 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de KENSINGTON MORTGAGE COMPANY LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para KENSINGTON MORTGAGE COMPANY LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 21 mar 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 04 abr 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 21 mar 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para KENSINGTON MORTGAGE COMPANY LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Andrew Nicholas Ratcliffe como director el 01 feb 2026 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Diana Susan Miller como director el 31 dic 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Ascot House Maidenhead Office Park Maidenhead SL6 3QQ a Kensington Mortgage Company Ltd, 2nd Floor Marlow International Parkway Marlow SL7 1YL el 11 nov 2025 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Robert Albert Joseph Swaak como director el 01 nov 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 60 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 mar 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Ms. Allison Buckley como director el 01 feb 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Mark John Arnold como director el 31 ene 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Simon Richard Betteridge como director el 01 jul 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Marc Stephen Page como director el 30 jun 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 63 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 mar 2024 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Jayne Doreen Almond como director el 31 dic 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Estado de capital el 12 dic 2023
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Exercice comptable en cours raccourci du 31 mar 2024 au 31 dic 2023 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Jeffrey Preston como director el 31 jul 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Marc Stephen Page como director el 15 sept 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 58 páginas | AA | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Andrew Nicholas Ratcliffe como director el 27 jun 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Exercice comptable précédent prolongé du 31 dic 2022 au 31 mar 2023 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||||||
Exercice comptable précédent raccourci du 31 mar 2023 au 31 dic 2022 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Alexander Filshie como director el 31 mar 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de KENSINGTON MORTGAGE COMPANY LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETTERIDGE, Simon Richard | Director | Marlow International Parkway SL7 1YL Marlow Kensington Mortgage Company Ltd, 2nd Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 120055130003 | |||||
| BUCKLEY, Allison, Ms. | Director | Marlow International Parkway SL7 1YL Marlow Kensington Mortgage Company Ltd, 2nd Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 332360880001 | |||||
| JARY, Michael Keith | Director | Marlow International Parkway SL7 1YL Marlow Kensington Mortgage Company Ltd, 2nd Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 41194840001 | |||||
| SWAAK, Robert Albert Joseph | Director | Marlow International Parkway SL7 1YL Marlow Kensington Mortgage Company Ltd, 2nd Floor United Kingdom | Netherlands | Dutch | 337620670001 | |||||
| MORRIS, James Harvey | Secretario | Basingstoke Road RG2 6DB Reading Reading International Business Park Berkshire | 194727470001 | |||||||
| MURRAY, Dominic | Secretario | Gresham Street 2 Gresham Street EC2V 7QP London 2 England England | Other | 121945810002 | ||||||
| PINDORIA, Shilla | Secretario | Gresham Street EC2V 7QP London 2 England England | 157092860001 | |||||||
| TOMSETT, Ann Sara | Secretario | 3a Palace Green W8 4TR London | British | 58027970005 | ||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||
| KENSINGTON SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | 2 Gresham Street EC2V 7QP London | 109008650002 | |||||||
| ALMOND, Jayne Doreen | Director | Maidenhead Office Park SL6 3QQ Maidenhead Ascot House United Kingdom | United Kingdom | British | 67416500001 | |||||
| ARNOLD, Mark John | Director | Maidenhead Office Park SL6 3QQ Maidenhead Ascot House | United Kingdom | British | 245151950001 | |||||
| ATTIA, Amany | Director | Maidenhead Office Park SL6 3QQ Maidenhead Ascot House | England | British | 201267950001 | |||||
| BIRCH, Peter Gibbs | Director | Bibury 24 Broad High Way KT11 2RP Cobham Surrey | United Kingdom | British | 58500710002 | |||||
| BLUNDELL, Roger Frederick Crawford | Director | Vineyard Hill Road SW19 7JL London 61 | England | British | 56525730002 | |||||
| BREEDON, Timothy James | Director | Maidenhead Office Park SL6 3QQ Maidenhead Ascot House | England | British | 224447890001 | |||||
| CHARLTON, Peter John | Director designado | 17 Kirkdale Road AL5 2PT Harpenden Hertfordshire | British | 900005610001 | ||||||
| CLAPHAM, Andrew | Director | Gresham Street 2 Gresham Street EC2V 7QP London 2 England England | United Kingdom | British | 185499550001 | |||||
| CLAYS, Malcolm | Director | 9 Llewelyn Park RG10 9NG Twyford Berkshire | British | 124718190001 | ||||||
| COLSELL, Steven James | Director | Limes House Bytham Road Ogbourne St George SN8 1TD Marlborough Wiltshire | England | British | 101387770001 | |||||
| FILSHIE, Alexander | Director | Maidenhead Office Park SL6 3QQ Maidenhead Ascot House | United Kingdom | British | 103835020012 | |||||
| FINEGOLD, Martin Alan | Director | Lexicon House 17 Old Court Place W8 4PL London | United Kingdom | American | 125782340001 | |||||
| FRANCIS, Michael Richard | Director | Basingstoke Road RG2 6DB Reading Reading International Business Park Berkshire England | England | British | 106167680003 | |||||
| FRENCH, Christopher | Director | Tudor Cottage The Green OX12 0HQ East Hanney Oxfordshire | British | 80863030001 | ||||||
| GUPTA, Rajesh | Director | Maidenhead Office Park SL6 3QQ Maidenhead Ascot House | United Kingdom | British | 161613460004 | |||||
| HENDERSON, Ian Arthur | Director | Basingstoke Road RG2 6DB Reading Reading International Business Park Berkshire | United Kingdom | British | 207828370001 | |||||
| HERBERT, Peter Ronald | Director | Maidenhead Office Park SL6 3QQ Maidenhead Ascot House United Kingdom | United Kingdom | British | 196629280001 | |||||
| HUTCHINSON, Alison | Director | 1 Sheldon Square W2 6PU London | British | 74158760003 | ||||||
| JONES, David Gareth | Director | Hillhouse Farm Misbrooks Green Road Beare Green RH5 4QQ Dorking Surrey | United Kingdom | British | 6205890002 | |||||
| KINGDON, Simon Charles | Director | 64 Waterman's Quay William Morris Way SW6 2UU London | British | 56324870004 | ||||||
| LLOYD, Derek | Director | Gresham Street 2 Gresham Street EC2V 7QP London 2 England England | United Kingdom | British | 124660210001 | |||||
| LLOYD, Derek | Director | 3 Bovingdon Heights SL7 2JR Marlow Buckinghamshire | United Kingdom | British | 124660210001 | |||||
| LLOYD, Derek | Director | 3 Bovingdon Heights SL7 2JR Marlow Buckinghamshire | United Kingdom | British | 124660210001 | |||||
| MADDOX, Alexander James | Director | Maidenhead Office Park SL6 3QQ Maidenhead Ascot House United Kingdom | United Kingdom | British | 215439420001 | |||||
| MALTBY, John Neil | Director | Priory House Priory Close BR7 5LB Chislehurst Kent | England | British | 84264890001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de KENSINGTON MORTGAGE COMPANY LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barclays Bank Uk Plc | 01 mar 2023 | Churchill Place E14 5HP London 1 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Khl Mortgage Services Limited | 12 mar 2020 | Maidenhead Office Park SL6 3QQ Maidenhead Ascot House England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| The Northview Group Limited | 06 abr 2016 | Old Jewry 7th Floor EC2R 8DU London 11 England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0