ROAMER LEISURE LIMITED

ROAMER LEISURE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaROAMER LEISURE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03052792
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ROAMER LEISURE LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra ROAMER LEISURE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o ROBSON LAIDLER LLP
    Fernwood House Fernwood Road
    Jesmond
    NE2 1TJ Newcastle Upon Tyne
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ROAMER LEISURE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para ROAMER LEISURE LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ROAMER LEISURE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    13 páginas4.71

    Domicilio social registrado cambiado de Centenary House Centenary Way Salford Manchester M50 1RF a C/O Robson Laidler Llp Fernwood House Fernwood Road Jesmond Newcastle upon Tyne NE2 1TJ el 08 may 2015

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 23 abr 2015

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Déclaration annuelle établie au 01 feb 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital24 feb 2015

    Estado de capital el 24 feb 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cese del nombramiento de Robert Stephen Lister como director el 05 nov 2014

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Ulf Stefan Brettschneider como director el 05 nov 2014

    2 páginasTM01

    Nombramiento de Robert Arthur Bacon como director el 04 nov 2014

    3 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Nicholas Andrew Cottrell como director el 04 nov 2014

    3 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 feb 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital05 mar 2014

    Estado de capital el 05 mar 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 feb 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Nombramiento de Robert Arthur Bacon como secretario

    3 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Christopher Kershaw como secretario

    2 páginasTM02

    Domicilio social registrado cambiado de * Aire Valley Business Centre Lawkholme Lane Keighley West Yorkshire BD21 3BB* el 09 nov 2012

    2 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 feb 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    6 páginasAA

    Cese del nombramiento de Spencer Fung como director

    2 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 01 feb 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Spencer Theodore Fung el 09 feb 2011

    3 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Christopher Sydney Sagar Kershaw el 13 ene 2011

    3 páginasCH03

    ¿Quiénes son los directivos de ROAMER LEISURE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BACON, Robert Arthur
    East Farm
    Cleadon Lane
    SR6 7UU Cleadon
    The Mill House
    Sunderland
    United Kingdom
    Secretario
    East Farm
    Cleadon Lane
    SR6 7UU Cleadon
    The Mill House
    Sunderland
    United Kingdom
    British175830360001
    BACON, Robert Arthur
    c/o Robson Laidler Llp
    Fernwood Road
    Jesmond
    NE2 1TJ Newcastle Upon Tyne
    Fernwood House
    Director
    c/o Robson Laidler Llp
    Fernwood Road
    Jesmond
    NE2 1TJ Newcastle Upon Tyne
    Fernwood House
    United KingdomBritish192986020001
    COTTRELL, Nicholas Andrew
    c/o Robson Laidler Llp
    Fernwood Road
    Jesmond
    NE2 1TJ Newcastle Upon Tyne
    Fernwood House
    Director
    c/o Robson Laidler Llp
    Fernwood Road
    Jesmond
    NE2 1TJ Newcastle Upon Tyne
    Fernwood House
    EnglandBritish7316340002
    BACON, Robert Arthur
    The Mill House East Farm
    Cleadon Lane Cleadon
    SR6 7UU Sunderland
    Secretario
    The Mill House East Farm
    Cleadon Lane Cleadon
    SR6 7UU Sunderland
    British192986020001
    KERSHAW, Christopher Sydney Sagar
    Centenary Way
    Salford
    M50 1RF Manchester
    Centenary House
    Secretario
    Centenary Way
    Salford
    M50 1RF Manchester
    Centenary House
    British152312820001
    PARKINSON, Thomas
    57 Twizell Avenue
    NE21 4EX Blaydon
    Tyne & Wear
    Secretario
    57 Twizell Avenue
    NE21 4EX Blaydon
    Tyne & Wear
    British10758990001
    RM REGISTRARS LIMITED
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    Secretario designado corporativo
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    900000760001
    BACON, Robert Arthur
    The Mill House East Farm
    Cleadon Lane Cleadon
    SR6 7UU Sunderland
    Director
    The Mill House East Farm
    Cleadon Lane Cleadon
    SR6 7UU Sunderland
    United KingdomBritish192986020001
    BRETTSCHNEIDER, Ulf Stefan
    Shelgate Road
    SW11 1BA London
    35
    Director
    Shelgate Road
    SW11 1BA London
    35
    United KingdomGerman125315710001
    FUNG, Spencer Theodore
    Marylebone Road
    NW1 6JQ London
    Woolworth House 242-246
    Director
    Marylebone Road
    NW1 6JQ London
    Woolworth House 242-246
    Hong KongBritish161919240001
    HUTCHINS, Tony
    6 Grosvenor Close
    SK9 1QY Wilmslow
    Cheshire
    Director
    6 Grosvenor Close
    SK9 1QY Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritish22327070001
    LISTER, Robert Stephen
    Hebers Ghyll Drive
    LS29 9QQ Ilkley
    Briery Wood
    West Yorkshire
    Director
    Hebers Ghyll Drive
    LS29 9QQ Ilkley
    Briery Wood
    West Yorkshire
    EnglandBritish161918280001
    MEHAN, Ramesh Lal
    11 Eyebrook Road
    Bowdon
    WA14 3LH Altrincham
    Cheshire
    Director
    11 Eyebrook Road
    Bowdon
    WA14 3LH Altrincham
    Cheshire
    British3755840001
    MEHAN, Sanjeev
    Ross Gables
    8 Hill Top
    WA15 0NH Hale
    Cheshire
    Director
    Ross Gables
    8 Hill Top
    WA15 0NH Hale
    Cheshire
    United KingdomBritish38495800004
    MEHAN, Sanjeev
    Ross Gables
    8 Hill Top
    WA15 0NH Hale
    Cheshire
    Director
    Ross Gables
    8 Hill Top
    WA15 0NH Hale
    Cheshire
    United KingdomBritish38495800004
    RAO, Ashwin Kumar
    33 Cringle Drive
    SK8 1JH Cheadle
    Cheshire
    Director
    33 Cringle Drive
    SK8 1JH Cheadle
    Cheshire
    United KingdomBritish31781040001
    SEHGAL, Mukesh Kumar
    Seghal Villa Denehurst
    Jesmond Park East
    NE7 7BT Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    Seghal Villa Denehurst
    Jesmond Park East
    NE7 7BT Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish64711760001
    SEHGAL, Promila
    Sehgal Villa Denehurst
    Jesmond Park East
    NE7 7BT Newcastle Upon Tyne
    Director
    Sehgal Villa Denehurst
    Jesmond Park East
    NE7 7BT Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish10759000002
    SEHGAL, Raj Kumar
    Seghal Villa Denehurst
    Jesmond Park East
    NE7 7BT Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    Seghal Villa Denehurst
    Jesmond Park East
    NE7 7BT Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish108127120002
    SEHGAL, Rakesh Kumar
    18 Sheldon Grove
    Kenton
    NE3 4JP Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    18 Sheldon Grove
    Kenton
    NE3 4JP Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish6304460001
    VARSANI, Nandas
    121 Auburn Street
    BL3 6UG Bolton
    Lancashire
    Director
    121 Auburn Street
    BL3 6UG Bolton
    Lancashire
    British49053210001
    WEIDENBAUM, David
    The Willows
    45 Prestwich Park Road, Prestwich
    M25 9PF Manchester
    Lancashire
    Director
    The Willows
    45 Prestwich Park Road, Prestwich
    M25 9PF Manchester
    Lancashire
    EnglandBritish70310330001
    RM NOMINEES LIMITED
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    Director designado corporativo
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    900009140001

    ¿Tiene ROAMER LEISURE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Mortgage debenture
    Creado el 12 mar 1996
    Entregado el 15 mar 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 15 mar 1996Registro de un cargo (395)
    • 20 oct 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 06 mar 1996
    Entregado el 08 mar 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 08 mar 1996Registro de un cargo (395)
    • 13 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 29 feb 1996
    Entregado el 01 mar 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transacciones
    • 01 mar 1996Registro de un cargo (395)
    • 13 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene ROAMER LEISURE LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    23 abr 2015Inicio de la liquidación
    06 feb 2016Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Simon Blakey
    Robson Laidler Llp Fernwood House Fernwood Road
    Jesmond
    NE2 1TJ Newcastle Upon Tyne
    Profesional
    Robson Laidler Llp Fernwood House Fernwood Road
    Jesmond
    NE2 1TJ Newcastle Upon Tyne
    Martin Daley
    Fernwood House Fernwood Road
    Jesmond
    NE2 1TJ Newcastle Upon Tyne
    Profesional
    Fernwood House Fernwood Road
    Jesmond
    NE2 1TJ Newcastle Upon Tyne

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0