OCS GROUP UK LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaOCS GROUP UK LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03056469
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de OCS GROUP UK LIMITED?

    • Actividades combinadas de apoyo a instalaciones (81100) / Actividades administrativas y de apoyo
    • Limpieza general de edificios (81210) / Actividades administrativas y de apoyo
    • Otras actividades de limpieza de edificios e industrial (81229) / Actividades administrativas y de apoyo
    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra OCS GROUP UK LIMITED?

    Dirección de la sede social
    New Century House
    The Havens
    IP3 9SJ Ipswich
    Suffolk
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de OCS GROUP UK LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    OCS LIMITED28 mar 200228 mar 2002
    OCS SUPPORT SERVICES LIMITED31 mar 200031 mar 2000
    OCS CLEANING MIDLANDS & NORTH LIMITED15 may 199515 may 1995

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de OCS GROUP UK LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2025
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para OCS GROUP UK LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta18 dic 2026
    Próxima declaración de confirmación vence01 ene 2027
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta18 dic 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para OCS GROUP UK LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Declaración de confirmación presentada el 18 dic 2025 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Jack Domonic Holmes como director el 17 dic 2025

    2 páginasAP01

    legacy

    6 páginasRP04SH01

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 01 dic 2025

    • Capital: GBP 2,000
    4 páginasSH01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    12 dic 2025Clarification A second filed SH01 was registered on 12/12/2025.

    Memorándum y Estatutos

    12 páginasMA

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024

    81 páginasAA

    Nombramiento de Mr Robert John Taylor como director el 08 jul 2025

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mrs Sarah Anne Williams como director el 23 jun 2025

    2 páginasAP01

    Registro de la carga 030564690008, creada el 20 mar 2025

    21 páginasMR01

    Cese del nombramiento de Ian Leighton Nisbet como director el 31 ene 2025

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Bruce James Mcdonnell como director el 13 ene 2025

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Nicholas David Maggs como director el 13 ene 2025

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del director Mr Daniel Grant Dickson el 06 ene 2025

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 18 dic 2024 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 030564690005

    1 páginasMR04

    Estado de capital el 22 nov 2024

    • Capital: GBP 2,000
    5 páginasSH19

    legacy

    2 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Nombramiento de Mr Ian Leighton Nisbet como director el 02 nov 2024

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Philip Henry Watts como director el 02 nov 2024

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Andrew Brian Sugars como director el 02 nov 2024

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Sean Paul Fisher como director el 02 nov 2024

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Steven Scott Moore como director el 02 nov 2024

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de OCS GROUP UK LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    RYAN, Laura Clare
    The Havens
    IP3 9SJ Ipswich
    New Century House
    Suffolk
    England
    Secretario
    The Havens
    IP3 9SJ Ipswich
    New Century House
    Suffolk
    England
    312646680001
    DICKSON, Daniel Grant
    The Havens
    IP3 9SJ Ipswich
    New Century House
    Suffolk
    England
    Director
    The Havens
    IP3 9SJ Ipswich
    New Century House
    Suffolk
    England
    EnglandBritish312644680001
    EVANS, Thomas Edward
    The Havens
    IP3 9SJ Ipswich
    New Century House
    Suffolk
    England
    Director
    The Havens
    IP3 9SJ Ipswich
    New Century House
    Suffolk
    England
    EnglandBritish289303810001
    FISHER, Sean Paul
    The Havens
    IP3 9SJ Ipswich
    New Century House
    Suffolk
    England
    Director
    The Havens
    IP3 9SJ Ipswich
    New Century House
    Suffolk
    England
    EnglandBritish316998890001
    HOLMES, Jack Domonic
    The Havens
    IP3 9SJ Ipswich
    New Century House
    Suffolk
    England
    Director
    The Havens
    IP3 9SJ Ipswich
    New Century House
    Suffolk
    England
    EnglandBritish343550290001
    MAGGS, Nicholas David
    The Havens
    IP3 9SJ Ipswich
    New Century House
    Suffolk
    England
    Director
    The Havens
    IP3 9SJ Ipswich
    New Century House
    Suffolk
    England
    EnglandBritish104782310001
    MCDONNELL, Bruce James
    The Havens
    IP3 9SJ Ipswich
    New Century House
    Suffolk
    England
    Director
    The Havens
    IP3 9SJ Ipswich
    New Century House
    Suffolk
    England
    EnglandBritish171262180002
    MOORE, Steven Scott
    The Havens
    IP3 9SJ Ipswich
    New Century House
    Suffolk
    England
    Director
    The Havens
    IP3 9SJ Ipswich
    New Century House
    Suffolk
    England
    EnglandBritish255221480001
    RYAN, Laura Clare
    The Havens
    IP3 9SJ Ipswich
    New Century House
    Suffolk
    England
    Director
    The Havens
    IP3 9SJ Ipswich
    New Century House
    Suffolk
    England
    EnglandBritish312646560001
    SUGARS, Andrew Brian
    The Havens
    IP3 9SJ Ipswich
    New Century House
    Suffolk
    England
    Director
    The Havens
    IP3 9SJ Ipswich
    New Century House
    Suffolk
    England
    EnglandBritish328936770001
    TAYLOR, Robert John
    The Havens
    IP3 9SJ Ipswich
    New Century House
    Suffolk
    England
    Director
    The Havens
    IP3 9SJ Ipswich
    New Century House
    Suffolk
    England
    EnglandBritish89340650002
    WATTS, Philip Henry
    The Havens
    IP3 9SJ Ipswich
    New Century House
    Suffolk
    England
    Director
    The Havens
    IP3 9SJ Ipswich
    New Century House
    Suffolk
    England
    EnglandBritish328956960001
    WILLIAMS, Sarah Anne
    The Havens
    IP3 9SJ Ipswich
    New Century House
    Suffolk
    England
    Director
    The Havens
    IP3 9SJ Ipswich
    New Century House
    Suffolk
    England
    EnglandBritish243885880001
    CLARK, Malcolm
    2 Monks Farm Cottages
    Honeywood Lane Okewoodhill
    RH5 5QA Dorking
    Surrey
    Secretario
    2 Monks Farm Cottages
    Honeywood Lane Okewoodhill
    RH5 5QA Dorking
    Surrey
    United Kingdom2624450004
    DODD, Christopher Stuart
    Tilgate Forest Business Park
    Brighton Road
    RH11 9BP Crawley
    4
    West Sussex
    England
    Secretario
    Tilgate Forest Business Park
    Brighton Road
    RH11 9BP Crawley
    4
    West Sussex
    England
    British164308020001
    LEWIS, Jacqueline Ann
    Tilgate Forest Business Park
    Brighton Road
    RH11 9BP Crawley
    4
    West Sussex
    Secretario
    Tilgate Forest Business Park
    Brighton Road
    RH11 9BP Crawley
    4
    West Sussex
    245663730001
    THORN-DAVIS, Scott Peter
    The Enterprise Centre
    Kelvin Lane, Manor Royal
    RH10 9PE Crawley
    Unit 5
    West Sussex
    England
    Secretario
    The Enterprise Centre
    Kelvin Lane, Manor Royal
    RH10 9PE Crawley
    Unit 5
    West Sussex
    England
    276219510001
    ARMITAGE, Peter Lockhart
    Longmead Highfields
    East Horsley
    KT24 5AA Leatherhead
    Surrey
    Director
    Longmead Highfields
    East Horsley
    KT24 5AA Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritish1681180001
    BRUTER, Alan
    7 Sheep Fair Way
    RG17 7LQ Lambourn
    Berkshire
    Director
    7 Sheep Fair Way
    RG17 7LQ Lambourn
    Berkshire
    United KingdomBritish146742220001
    BURL, Richard
    44 Oakwood Road
    GU20 6JD Windlesham
    Surrey
    Director
    44 Oakwood Road
    GU20 6JD Windlesham
    Surrey
    British104639210001
    CALEY, Peter James
    19 The Glebe
    MK46 4HY Lavendon
    Buckinghamshire
    Director
    19 The Glebe
    MK46 4HY Lavendon
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish114232310001
    COX, Martin Christopher Sharman
    Woodways New Road
    TN17 3LE Cranbrook
    Kent
    Director
    Woodways New Road
    TN17 3LE Cranbrook
    Kent
    British55937150001
    CRACKNELL, Christopher David
    Brighton Road
    RH11 9BP Crawley
    4 Tilgate Forest Business Park
    West Sussex
    England
    Director
    Brighton Road
    RH11 9BP Crawley
    4 Tilgate Forest Business Park
    West Sussex
    England
    United KingdomBritish40487050001
    DARNTON, James
    Tilgate Forest Business Park
    Brighton Road
    RH11 9BP Crawley
    4
    West Sussex
    Director
    Tilgate Forest Business Park
    Brighton Road
    RH11 9BP Crawley
    4
    West Sussex
    EnglandBritish51472910003
    DAVIS, John Eric
    33 Thorpe Avenue
    TN10 4PW Tonbridge
    Kent
    Director
    33 Thorpe Avenue
    TN10 4PW Tonbridge
    Kent
    United KingdomBritish54289640002
    DRYSDALE, Jane Louise
    Brighton Road
    RH11 9BP Crawley
    4 Tilgate Forest Business Park
    West Sussex
    England
    Director
    Brighton Road
    RH11 9BP Crawley
    4 Tilgate Forest Business Park
    West Sussex
    England
    EnglandBritish126480370002
    EMBUREY, Philip George
    Winterstoke
    Logs Hill Close
    BR7 5LP Chislehurst
    Kent
    Director
    Winterstoke
    Logs Hill Close
    BR7 5LP Chislehurst
    Kent
    EnglandBritish56802790001
    FENTON JONES, Richard Langford
    Eaton
    16 St Peters Road
    GL7 1RG Cirencester
    Gloucestershire
    Director
    Eaton
    16 St Peters Road
    GL7 1RG Cirencester
    Gloucestershire
    British81444230001
    GAMMON, Martin Benjamin
    13 St Pauls Mews
    RH4 2HP Dorking
    Surrey
    Director
    13 St Pauls Mews
    RH4 2HP Dorking
    Surrey
    EnglandBritish16589510005
    GAMMON, Martin Benjamin
    13 St Pauls Mews
    RH4 2HP Dorking
    Surrey
    Director
    13 St Pauls Mews
    RH4 2HP Dorking
    Surrey
    EnglandBritish16589510005
    GILBERT, Graham
    34 Walwyn Close
    Birdham
    PO20 7SR Chichester
    West Sussex
    Director
    34 Walwyn Close
    Birdham
    PO20 7SR Chichester
    West Sussex
    EnglandBritish104416760001
    GOODLIFFE, Ian Thomas
    The Enterprise Centre
    Kelvin Lane, Manor Royal
    RH10 9PE Crawley
    Unit 5
    West Sussex
    England
    Director
    The Enterprise Centre
    Kelvin Lane, Manor Royal
    RH10 9PE Crawley
    Unit 5
    West Sussex
    England
    EnglandBritish247145560001
    GOODLIFFE, Peter George
    Brighton Road
    RH11 9BP Crawley
    4 Tilgate Forest Business Park
    West Sussex
    England
    Director
    Brighton Road
    RH11 9BP Crawley
    4 Tilgate Forest Business Park
    West Sussex
    England
    EnglandBritish71675760004
    GOODLIFFE, Peter George
    Summerhill
    Mark Beech
    TN8 7LR Edenbridge
    Kent
    Director
    Summerhill
    Mark Beech
    TN8 7LR Edenbridge
    Kent
    British71675760002
    GRATTON, David Martin
    Tilgate Forest Business Park
    Brighton Road
    RH11 9BP Crawley
    4
    West Sussex
    Director
    Tilgate Forest Business Park
    Brighton Road
    RH11 9BP Crawley
    4
    West Sussex
    EnglandBritish125673640002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de OCS GROUP UK LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    The Havens
    IP3 9SJ Ipswich
    New Century House
    England
    01 oct 2024
    The Havens
    IP3 9SJ Ipswich
    New Century House
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro06355228
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    Ocs Group International Limited
    Kelvin Lane
    Manor Royal
    RH10 9PE Crawley
    Unit 5
    West Sussex
    England
    06 abr 2016
    Kelvin Lane
    Manor Royal
    RH10 9PE Crawley
    Unit 5
    West Sussex
    England
    Forma jurídicaLimited Liability
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalEnglish Law
    Lugar de registroEngland
    Número de registro02946849
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0